INTERSERVE INVESTMENTS LIMITED

INTERSERVE INVESTMENTS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaINTERSERVE INVESTMENTS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00074643
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenesNo
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de INTERSERVE INVESTMENTS LIMITED?

    • Actividades de otras sociedades holding n.c.o.p. (64209) / Actividades financieras y de seguros

    ¿Dónde se encuentra INTERSERVE INVESTMENTS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de INTERSERVE INVESTMENTS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    INTERSERVE INVESTMENTS PLC16 jul 200116 jul 2001
    TILBURY SECURITIES PLC28 feb 198628 feb 1986
    TILBURY INTERNATIONAL MANAGEMENT SERVICES LIMITED31 dic 197731 dic 1977
    TILBURY BUILDING LIMITED16 ago 190216 ago 1902

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de INTERSERVE INVESTMENTS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 jun 2021

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para INTERSERVE INVESTMENTS LIMITED?

    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta21 jun 2023

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para INTERSERVE INVESTMENTS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de acreedores

    30 páginasLIQ14

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 19 sept 2024

    68 páginasLIQ03

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    4 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo extraordinario para la liquidación el 20 sept 2023

    LRESEX

    Declaración de asuntos

    11 páginasLIQ02

    Domicilio social registrado cambiado de , Capital Tower 91 Waterloo Road, London, SE1 8RT, England a Central Square 29 Wellington Street Leeds LS1 4DL el 15 sept 2023

    1 páginasAD01

    Declaración de confirmación presentada el 21 jun 2023 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Exercice comptable précédent raccourci du 27 jun 2022 au 26 jun 2022

    1 páginasAA01

    Exercice comptable précédent raccourci du 28 jun 2022 au 27 jun 2022

    1 páginasAA01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2021

    27 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 21 jun 2022 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Exercice comptable précédent raccourci du 29 jun 2021 au 28 jun 2021

    1 páginasAA01

    Exercice comptable précédent prolongé du 29 dic 2020 au 29 jun 2021

    1 páginasAA01

    Cese del nombramiento de Julie Helen Downman como director el 23 jun 2021

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Jeremy Mark White como director el 22 jun 2021

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 21 jun 2021 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2019

    27 páginasAA

    Nombramiento de Mr Christopher James Edwards como director el 03 feb 2021

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Andrew John Mcdonald como director el 04 feb 2021

    1 páginasTM01

    Exercice comptable précédent raccourci du 30 dic 2019 au 29 dic 2019

    1 páginasAA01

    Modification des détails de Interserve Group Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 04 dic 2020

    2 páginasPSC05

    Domicilio social registrado cambiado de , Interserve House, Ruscombe Park Twyford, Reading, Berkshire, RG10 9JU a Central Square 29 Wellington Street Leeds LS1 4DL el 04 dic 2020

    1 páginasAD01

    Nombramiento de Mr Andrew John Mcdonald como director el 12 oct 2020

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Rajan Goyal como director el 31 jul 2020

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de INTERSERVE INVESTMENTS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    EDWARDS, Christopher James
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    England
    Director
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    England
    EnglandBritish279311610001
    WHITE, Jeremy Mark
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    England
    Director
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    England
    EnglandBritish284537740001
    BRADBURY, Trevor
    22 East Park Farm Drive
    Charvil
    RG10 9UL Reading
    Berkshire
    Secretario
    22 East Park Farm Drive
    Charvil
    RG10 9UL Reading
    Berkshire
    British47884750003
    KEEN, Richard
    Interserve House
    Ruscombe Park Twyford
    RG10 9JU Reading
    Berkshire
    Secretario
    Interserve House
    Ruscombe Park Twyford
    RG10 9JU Reading
    Berkshire
    203303910001
    RICHARDSON, Lyn
    46 Strawberry Fields
    Bramley
    RG26 5QF Tadley
    Hampshire
    Secretario
    46 Strawberry Fields
    Bramley
    RG26 5QF Tadley
    Hampshire
    British21865010001
    SMERDON, Leigh
    1 Cedar Grove
    The Hedgerows Great Wyrley
    WS6 6QH Walsall
    West Midlands
    Secretario
    1 Cedar Grove
    The Hedgerows Great Wyrley
    WS6 6QH Walsall
    West Midlands
    Other89075910001
    BIRLEY SMITH, Gaynor
    Common House
    Ivington Court Ivington
    HR6 0JW Leominster
    Herefordshire
    Director
    Common House
    Ivington Court Ivington
    HR6 0JW Leominster
    Herefordshire
    EnglandEnglish83779370002
    BOTTJER, Michael Colin
    Larchlands
    Larch Avenue
    SL5 0AP Sunninghill
    Berkshire
    Director
    Larchlands
    Larch Avenue
    SL5 0AP Sunninghill
    Berkshire
    British66295720001
    BRADBURY, Trevor
    Interserve House
    Ruscombe Park Twyford
    RG10 9JU Reading
    Berkshire
    Director
    Interserve House
    Ruscombe Park Twyford
    RG10 9JU Reading
    Berkshire
    EnglandBritish47884750003
    BRADBURY, Trevor
    22 East Park Farm Drive
    Charvil
    RG10 9UL Reading
    Berkshire
    Director
    22 East Park Farm Drive
    Charvil
    RG10 9UL Reading
    Berkshire
    EnglandBritish47884750003
    BROWN, John Stockdale Spence
    3 Squires Gate
    WS7 9DG Burntwood
    Staffordshire
    Director
    3 Squires Gate
    WS7 9DG Burntwood
    Staffordshire
    EnglandBritish18566670001
    CARR, Michael Lewis
    Flat 7
    46 Elm Park Road
    SW3 6AX London
    Director
    Flat 7
    46 Elm Park Road
    SW3 6AX London
    British36816040001
    CARTER, Patrick Edward
    Erdington
    B23 7RZ Birmingham
    395 George Road
    England
    Director
    Erdington
    B23 7RZ Birmingham
    395 George Road
    England
    United KingdomBritish101985160001
    DOWNMAN, Julie Helen
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    Capital Tower
    England
    Director
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    Capital Tower
    England
    EnglandBritish242317210001
    FIELD, Christopher Richard
    Interserve House
    Ruscombe Park Twyford
    RG10 9JU Reading
    Berkshire
    Director
    Interserve House
    Ruscombe Park Twyford
    RG10 9JU Reading
    Berkshire
    United KingdomBritish117601990001
    GOYAL, Rajan
    27 Braywick Road
    SL6 1BN Maidenhead
    Berkshire
    Director
    27 Braywick Road
    SL6 1BN Maidenhead
    Berkshire
    EnglandBritish94399020001
    GROOM, Clive Jeremy
    6 Fulmar Court
    Arundel Way Highcliffe
    BH23 5DX Christchurch
    Director
    6 Fulmar Court
    Arundel Way Highcliffe
    BH23 5DX Christchurch
    British95142990001
    HAYWOOD, Timothy Paul
    Interserve House
    Ruscombe Park Twyford
    RG10 9JU Reading
    Berkshire
    Director
    Interserve House
    Ruscombe Park Twyford
    RG10 9JU Reading
    Berkshire
    EnglandBritish252141390002
    JONES, Stephen Michael
    Interserve House
    Ruscombe Park, Twyford
    RG10 9JU Reading
    Interserve House
    Berkshire
    England
    Director
    Interserve House
    Ruscombe Park, Twyford
    RG10 9JU Reading
    Interserve House
    Berkshire
    England
    United KingdomBritish88268290002
    JONES, Timothy Charles
    Interserve House
    Ruscombe Park Twyford
    RG10 9JU Reading
    Berkshire
    Director
    Interserve House
    Ruscombe Park Twyford
    RG10 9JU Reading
    Berkshire
    EnglandBritish81110720001
    LEE, Malcolm Stuart
    Orchard Gate, Ashley Hill Place
    Cockpole Green
    RG10 8NL Wargrave
    Berkshire
    Director
    Orchard Gate, Ashley Hill Place
    Cockpole Green
    RG10 8NL Wargrave
    Berkshire
    British12264540006
    MAROLI, Sushaan Shekar
    50 Greenbank Avenue
    Greenford
    HA0 2TF Wembley
    Middlesex
    Director
    50 Greenbank Avenue
    Greenford
    HA0 2TF Wembley
    Middlesex
    British56564240001
    MARSDEN, Robert James
    George Road
    395 George Road Erdington
    B23 7RZ Birmingham
    395
    England
    Director
    George Road
    395 George Road Erdington
    B23 7RZ Birmingham
    395
    England
    EnglandBritish86971250002
    MCDONALD, Andrew John
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    Capital Tower
    England
    Director
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    Capital Tower
    England
    EnglandBritish164670820001
    MCEVEDY, David Jason
    Village Farm
    Cherry Tree Avenue Newton On Ouse
    YO30 2BN York
    Director
    Village Farm
    Cherry Tree Avenue Newton On Ouse
    YO30 2BN York
    British69462470003
    MELIZAN, Bruce Anthony
    Interserve House
    Ruscombe Park Twyford
    RG10 9JU Reading
    Berkshire
    Director
    Interserve House
    Ruscombe Park Twyford
    RG10 9JU Reading
    Berkshire
    United KingdomBritish,Trinidadian92905500001
    PATERSON, David John
    George Road
    395 George Road Erdington
    B23 7RZ Birmingham
    395
    England
    Director
    George Road
    395 George Road Erdington
    B23 7RZ Birmingham
    395
    England
    EnglandBritish55601200002
    PREMACHANDRA, Asela
    George Road
    395 George Road Erdington
    B23 7RZ Birmingham
    395
    England
    Director
    George Road
    395 George Road Erdington
    B23 7RZ Birmingham
    395
    England
    United Kingdom ( England ) (Gb-Eng)British114612890002
    RINGROSE, Adrian Michael
    Interserve House
    Ruscombe Park Twyford
    RG10 9JU Reading
    Berkshire
    Director
    Interserve House
    Ruscombe Park Twyford
    RG10 9JU Reading
    Berkshire
    EnglandBritish232006700001
    SLATER, Trevor
    17 Yewdale
    196 Harborne Park Road Harborne
    B17 0BP Birmingham
    West Midlands
    Director
    17 Yewdale
    196 Harborne Park Road Harborne
    B17 0BP Birmingham
    West Midlands
    British39823150001
    SPARKS, Russell George
    45 Silver Street
    BS48 2AA Nailsea
    Somerset
    Director
    45 Silver Street
    BS48 2AA Nailsea
    Somerset
    United KingdomBritish189002230001
    SUTHERLAND, Douglas Iain
    Interserve House
    Ruscombe Park Twyford
    RG10 9JU Reading
    Berkshire
    Director
    Interserve House
    Ruscombe Park Twyford
    RG10 9JU Reading
    Berkshire
    United KingdomBritish257902560001
    THOMAS, Yvonne
    Tower
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    Capital
    England
    Director
    Tower
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    Capital
    England
    EnglandBritish194601710001
    VINCE, Robert David
    George Road
    395 George Road Erdington
    B23 7RZ Birmingham
    395
    England
    Director
    George Road
    395 George Road Erdington
    B23 7RZ Birmingham
    395
    England
    EnglandBritish69268810003
    VYSE, John Henry
    3 Kittiwake
    Watermead
    HP19 0FT Aylesbury
    Buckinghamshire
    Director
    3 Kittiwake
    Watermead
    HP19 0FT Aylesbury
    Buckinghamshire
    EnglandBritish10996210002

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de INTERSERVE INVESTMENTS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Interserve Group Holdings Limited
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    Capital Tower
    United Kingdom
    06 abr 2016
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    Capital Tower
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalUk Company Law
    Lugar de registroEngland And Wales
    Número de registro06402005
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene INTERSERVE INVESTMENTS LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    18 feb 2026Fecha prevista de disolución
    20 sept 2023Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de acreedores
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Victoria Hatton
    8th Floor Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    Profesional
    8th Floor Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    David Robert Baxendale
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Profesional
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Mark James Tobias Banfield
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Profesional
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0