KOHLER (UK) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaKOHLER (UK) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00075110
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de KOHLER (UK) LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra KOHLER (UK) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Whaddon Works
    Cromwell Road
    GL52 5EP Cheltenham
    Gloucestershire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de KOHLER (UK) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    MEYNELL VALVES LIMITED14 oct 190214 oct 1902

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de KOHLER (UK) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2020

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para KOHLER (UK) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Resoluciones

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Application for strike off 03/05/2022
    RES13

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Estado de capital el 21 dic 2021

    • Capital: GBP 1
    3 páginasSH19

    legacy

    3 páginasSH20

    legacy

    3 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    5 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 dic 2020

    9 páginasAA

    legacy

    37 páginasPARENT_ACC

    legacy

    1 páginasAGREEMENT2

    legacy

    3 páginasGUARANTEE2

    Declaración de confirmación presentada el 19 jul 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2019

    9 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 19 jul 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado de C/O Cleary Gottlieb Steen & Hamilton Llp City Place House 55 Basinghall Street London EC2V 5EH a Kohler Emea Corporate Services Davy Way Quedgeley Gloucester GL2 2DE

    1 páginasAD02

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2018

    9 páginasAA

    legacy

    4 páginasGUARANTEE2

    legacy

    1 páginasAGREEMENT2

    Declaración de confirmación presentada el 19 jul 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de James Mc Kee Robinson Iv como director el 20 nov 2018

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de James Mc Kee Robinson Iv como secretario el 20 nov 2018

    1 páginasTM02

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017

    9 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 19 jul 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    ¿Quiénes son los directivos de KOHLER (UK) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    ADLER, Thomas Gerard
    444 Highland Drive
    Kohler
    Kohler Holdings Limited
    Wisconsin 53044
    United States
    Director
    444 Highland Drive
    Kohler
    Kohler Holdings Limited
    Wisconsin 53044
    United States
    United StatesAmerican224426520001
    KOHLER JUNIOR, Herbert V
    Highland Drive
    53044 Kohler
    444
    Wisconsin
    United States
    Director
    Highland Drive
    53044 Kohler
    444
    Wisconsin
    United States
    United StatesAmerican77428040001
    SADLER, Sarah Louise
    Whaddon Works
    Cromwell Road
    GL52 5EP Cheltenham
    Kohler Mira
    Gloucestershire
    England
    Director
    Whaddon Works
    Cromwell Road
    GL52 5EP Cheltenham
    Kohler Mira
    Gloucestershire
    England
    United KingdomBritish208635430001
    BHOWMIK, Chandan Kanti
    22 Armour Hill
    Tilehurst
    RG31 6JP Reading
    Berkshire
    Secretario
    22 Armour Hill
    Tilehurst
    RG31 6JP Reading
    Berkshire
    British3752320001
    BLACK, Natalie Ann
    Highland Drive
    53044 Kohler
    444
    Wisconsin
    Usa
    Secretario
    Highland Drive
    53044 Kohler
    444
    Wisconsin
    Usa
    American73647190004
    BURNINGHAM, Derek
    58 Brooklands Way
    RH1 2BW Redhill
    Surrey
    Secretario
    58 Brooklands Way
    RH1 2BW Redhill
    Surrey
    British3360080001
    CAMERON, Ewen
    Oakfield House Station Road
    RG10 8EU Wargrave
    Berkshire
    Secretario
    Oakfield House Station Road
    RG10 8EU Wargrave
    Berkshire
    British2421530001
    ROBINSON IV, James Mc Kee
    Highland Drive
    Kohler
    444
    Wisconsin 53044
    United States
    Secretario
    Highland Drive
    Kohler
    444
    Wisconsin 53044
    United States
    181053390001
    EVER 1058 LIMITED
    Fourth Floor
    Cloth Hall Court, Infirmary Street
    LS1 2JB Leeds
    West Yorkshire
    Secretario corporativo
    Fourth Floor
    Cloth Hall Court, Infirmary Street
    LS1 2JB Leeds
    West Yorkshire
    69209680001
    AGARD, Martin Dean
    Highland Drive
    Kohler
    444
    Wisconsin 53044
    Usa
    Director
    Highland Drive
    Kohler
    444
    Wisconsin 53044
    Usa
    UsaAmerican179886850001
    BLACK, Natalie Ann
    Highland Drive
    53044 Kohler
    444
    Wisconsin
    Usa
    Director
    Highland Drive
    53044 Kohler
    444
    Wisconsin
    Usa
    United StatesAmerican73647190004
    CARRIER, John
    Sandbeck Ridge 48 Willowmead Drive
    Prestbury
    SK10 4DD Macclesfield
    Cheshire
    Director
    Sandbeck Ridge 48 Willowmead Drive
    Prestbury
    SK10 4DD Macclesfield
    Cheshire
    British46823900001
    CHAMBRE, Peter Alan
    25 Mount Ararat Road
    TW10 6PQ Richmond
    Surrey
    Director
    25 Mount Ararat Road
    TW10 6PQ Richmond
    Surrey
    British17430990001
    CHENEY, Jeffrey Paul
    Highland Drive
    53044 Kohler
    444
    Wisconsin
    Usa
    Director
    Highland Drive
    53044 Kohler
    444
    Wisconsin
    Usa
    UsaAmerican152013920001
    FREUND, Juergen
    36 Onslow Road
    Burwood Park
    KT12 5BA Walton On Thames
    Surrey
    Director
    36 Onslow Road
    Burwood Park
    KT12 5BA Walton On Thames
    Surrey
    German39320550001
    GOODWILL, David John, Dr
    The Dormer
    Walnut Court
    GL20 8JA Teddington
    Gloucestershire
    Director
    The Dormer
    Walnut Court
    GL20 8JA Teddington
    Gloucestershire
    British42136590001
    HAAS, Delbert Peter
    Highland Drive
    Kohler
    444
    Wisconsin 53044
    Usa
    Director
    Highland Drive
    Kohler
    444
    Wisconsin 53044
    Usa
    Usa/WisconsinAmerican202272000001
    HANNAH, Alan Grant
    The Old Post Office 8 Newcastle Road
    South Brereton Green
    CW11 1RS Sandbach
    Cheshire
    Director
    The Old Post Office 8 Newcastle Road
    South Brereton Green
    CW11 1RS Sandbach
    Cheshire
    British72607060001
    HASTINGS, Charles Richard
    Hollybush House
    Pamington
    GL20 8LX Tewkesbury
    Gloucestershire
    Director
    Hollybush House
    Pamington
    GL20 8LX Tewkesbury
    Gloucestershire
    United KingdomBritish65787770002
    HAWKINS, Maureen Ann
    11 Pennine Way
    CV10 8PW Nuneaton
    Warwickshire
    Director
    11 Pennine Way
    CV10 8PW Nuneaton
    Warwickshire
    British47004180001
    MCFAULL, John
    12a Charlotte Rose House
    Christchurch Road
    GL50 2PB Cheltenham
    Gloucestershire
    Director
    12a Charlotte Rose House
    Christchurch Road
    GL50 2PB Cheltenham
    Gloucestershire
    British62344930002
    MCGRATH, Alwyn Mary
    389 Innsworth Lane
    Churchdown
    GL3 1HA Gloucester
    Gloucestershire
    Director
    389 Innsworth Lane
    Churchdown
    GL3 1HA Gloucester
    Gloucestershire
    British4468010001
    MILLS, Robert John Henry
    Hacheston Lodge The Street
    Hacheston
    IP13 0DL Woodbridge
    Suffolk
    Director
    Hacheston Lodge The Street
    Hacheston
    IP13 0DL Woodbridge
    Suffolk
    EnglandBritish62567910001
    MONKS, Terence John
    Brantingham
    24 Green Lane
    SL1 8DX Burnham
    Buckinghamshire
    Director
    Brantingham
    24 Green Lane
    SL1 8DX Burnham
    Buckinghamshire
    British80344460001
    MOSS, Andrew John
    Field View Ham Lane
    Aston
    OX18 2DE Bampton
    Oxfordshire
    Director
    Field View Ham Lane
    Aston
    OX18 2DE Bampton
    Oxfordshire
    British55351010001
    PICKERING, Mark Ian
    54 Broadway Road
    WR11 1BQ Evesham
    Worcestershire
    Director
    54 Broadway Road
    WR11 1BQ Evesham
    Worcestershire
    EnglandBritish107375670001
    ROBINSON IV, James Mc Kee
    Highland Drive
    Kohler
    444
    Wisconsin 53044
    United States
    Director
    Highland Drive
    Kohler
    444
    Wisconsin 53044
    United States
    United StatesAmerican179424210001
    SEDDON, Andrew David
    19 Balmuir Gardens
    Putney
    SW15 6NG London
    Director
    19 Balmuir Gardens
    Putney
    SW15 6NG London
    British68650190001
    SIFORD, Neil Edward
    29 Vernon Road
    SW14 8NH London
    Director
    29 Vernon Road
    SW14 8NH London
    British65308310001
    TILMAN, David Ward
    Fairmead
    Woodland Drive
    KT24 5AN East Horsley
    Surrey
    Director
    Fairmead
    Woodland Drive
    KT24 5AN East Horsley
    Surrey
    United KingdomBritish81215590001
    VINE CHATTERTON, Laurence
    St Marys Kingfisher Corner
    Old Merrow Street
    GU4 7AX Guildford
    Surrey
    Director
    St Marys Kingfisher Corner
    Old Merrow Street
    GU4 7AX Guildford
    Surrey
    British52625790001
    WALKER, Timothy
    Sandhurst Farm
    Clayhill Road, Lamberhurst
    TN3 8AX Tunbridge Wells
    Kent
    Director
    Sandhurst Farm
    Clayhill Road, Lamberhurst
    TN3 8AX Tunbridge Wells
    Kent
    United KingdomBritish64603310001
    WHEELER, Simon Crane
    Pond Oast Postern Park Farm
    Postern Lane
    TN11 0QT Tonbridge
    Kent
    Director
    Pond Oast Postern Park Farm
    Postern Lane
    TN11 0QT Tonbridge
    Kent
    British39252030001
    WHITE, Richard William
    Hallery House
    48 Shurdington Road
    GL53 0JE Cheltenham
    Gloucestershire
    Director
    Hallery House
    48 Shurdington Road
    GL53 0JE Cheltenham
    Gloucestershire
    British77704060003
    WINSTONE, Robert James
    The Coach House
    Stanley Road Battledown
    GL52 6PB Cheltenham
    Gloucestershire
    Director
    The Coach House
    Stanley Road Battledown
    GL52 6PB Cheltenham
    Gloucestershire
    British12687420002

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de KOHLER (UK) LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Cromwell Road
    GL52 5EP Cheltenham
    Kohler Mira Limited
    Gloucestershire
    England
    06 abr 2016
    Cromwell Road
    GL52 5EP Cheltenham
    Kohler Mira Limited
    Gloucestershire
    England
    No
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro252115
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene KOHLER (UK) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 03 abr 1981
    Entregado el 07 abr 1981
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital. & all buildings fixtures (inc. Trade fixtures) fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 07 abr 1981Registro de una carga
    • 05 ago 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 04 jul 1978
    Entregado el 24 jul 1978
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £85,776.00.
    Breve descripción
    Steinel bz 20 machining centre, serial no. ME7 6619.
    Personas con derecho
    • Lloyds and Scottish Trust Limited
    Transacciones
    • 24 jul 1978Registro de una carga
    • 05 ago 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 11 ene 1940
    Entregado el 25 ene 1940
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed & floating charge on undertaking and all property and assets present and future including goodwill & uncalled capital. F/h property in montrose street, littles lane & southampton street, wolverhampton. Together with all fixtures (including trade fixtures) fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 25 ene 1940Registro de una carga
    • 05 ago 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0