KOHLER (UK) LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | KOHLER (UK) LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 00075110 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de KOHLER (UK) LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra KOHLER (UK) LIMITED?
| Dirección de la sede social | Whaddon Works Cromwell Road GL52 5EP Cheltenham Gloucestershire |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de KOHLER (UK) LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| MEYNELL VALVES LIMITED | 14 oct 1902 | 14 oct 1902 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de KOHLER (UK) LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2020 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para KOHLER (UK) LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 3 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Estado de capital el 21 dic 2021
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | SH20 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 5 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 dic 2020 | 9 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 37 páginas | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT2 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE2 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 19 jul 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2019 | 9 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 19 jul 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado de C/O Cleary Gottlieb Steen & Hamilton Llp City Place House 55 Basinghall Street London EC2V 5EH a Kohler Emea Corporate Services Davy Way Quedgeley Gloucester GL2 2DE | 1 páginas | AD02 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2018 | 9 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 4 páginas | GUARANTEE2 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT2 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 19 jul 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de James Mc Kee Robinson Iv como director el 20 nov 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de James Mc Kee Robinson Iv como secretario el 20 nov 2018 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017 | 9 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 19 jul 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de KOHLER (UK) LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADLER, Thomas Gerard | Director | 444 Highland Drive Kohler Kohler Holdings Limited Wisconsin 53044 United States | United States | American | 224426520001 | |||||
| KOHLER JUNIOR, Herbert V | Director | Highland Drive 53044 Kohler 444 Wisconsin United States | United States | American | 77428040001 | |||||
| SADLER, Sarah Louise | Director | Whaddon Works Cromwell Road GL52 5EP Cheltenham Kohler Mira Gloucestershire England | United Kingdom | British | 208635430001 | |||||
| BHOWMIK, Chandan Kanti | Secretario | 22 Armour Hill Tilehurst RG31 6JP Reading Berkshire | British | 3752320001 | ||||||
| BLACK, Natalie Ann | Secretario | Highland Drive 53044 Kohler 444 Wisconsin Usa | American | 73647190004 | ||||||
| BURNINGHAM, Derek | Secretario | 58 Brooklands Way RH1 2BW Redhill Surrey | British | 3360080001 | ||||||
| CAMERON, Ewen | Secretario | Oakfield House Station Road RG10 8EU Wargrave Berkshire | British | 2421530001 | ||||||
| ROBINSON IV, James Mc Kee | Secretario | Highland Drive Kohler 444 Wisconsin 53044 United States | 181053390001 | |||||||
| EVER 1058 LIMITED | Secretario corporativo | Fourth Floor Cloth Hall Court, Infirmary Street LS1 2JB Leeds West Yorkshire | 69209680001 | |||||||
| AGARD, Martin Dean | Director | Highland Drive Kohler 444 Wisconsin 53044 Usa | Usa | American | 179886850001 | |||||
| BLACK, Natalie Ann | Director | Highland Drive 53044 Kohler 444 Wisconsin Usa | United States | American | 73647190004 | |||||
| CARRIER, John | Director | Sandbeck Ridge 48 Willowmead Drive Prestbury SK10 4DD Macclesfield Cheshire | British | 46823900001 | ||||||
| CHAMBRE, Peter Alan | Director | 25 Mount Ararat Road TW10 6PQ Richmond Surrey | British | 17430990001 | ||||||
| CHENEY, Jeffrey Paul | Director | Highland Drive 53044 Kohler 444 Wisconsin Usa | Usa | American | 152013920001 | |||||
| FREUND, Juergen | Director | 36 Onslow Road Burwood Park KT12 5BA Walton On Thames Surrey | German | 39320550001 | ||||||
| GOODWILL, David John, Dr | Director | The Dormer Walnut Court GL20 8JA Teddington Gloucestershire | British | 42136590001 | ||||||
| HAAS, Delbert Peter | Director | Highland Drive Kohler 444 Wisconsin 53044 Usa | Usa/Wisconsin | American | 202272000001 | |||||
| HANNAH, Alan Grant | Director | The Old Post Office 8 Newcastle Road South Brereton Green CW11 1RS Sandbach Cheshire | British | 72607060001 | ||||||
| HASTINGS, Charles Richard | Director | Hollybush House Pamington GL20 8LX Tewkesbury Gloucestershire | United Kingdom | British | 65787770002 | |||||
| HAWKINS, Maureen Ann | Director | 11 Pennine Way CV10 8PW Nuneaton Warwickshire | British | 47004180001 | ||||||
| MCFAULL, John | Director | 12a Charlotte Rose House Christchurch Road GL50 2PB Cheltenham Gloucestershire | British | 62344930002 | ||||||
| MCGRATH, Alwyn Mary | Director | 389 Innsworth Lane Churchdown GL3 1HA Gloucester Gloucestershire | British | 4468010001 | ||||||
| MILLS, Robert John Henry | Director | Hacheston Lodge The Street Hacheston IP13 0DL Woodbridge Suffolk | England | British | 62567910001 | |||||
| MONKS, Terence John | Director | Brantingham 24 Green Lane SL1 8DX Burnham Buckinghamshire | British | 80344460001 | ||||||
| MOSS, Andrew John | Director | Field View Ham Lane Aston OX18 2DE Bampton Oxfordshire | British | 55351010001 | ||||||
| PICKERING, Mark Ian | Director | 54 Broadway Road WR11 1BQ Evesham Worcestershire | England | British | 107375670001 | |||||
| ROBINSON IV, James Mc Kee | Director | Highland Drive Kohler 444 Wisconsin 53044 United States | United States | American | 179424210001 | |||||
| SEDDON, Andrew David | Director | 19 Balmuir Gardens Putney SW15 6NG London | British | 68650190001 | ||||||
| SIFORD, Neil Edward | Director | 29 Vernon Road SW14 8NH London | British | 65308310001 | ||||||
| TILMAN, David Ward | Director | Fairmead Woodland Drive KT24 5AN East Horsley Surrey | United Kingdom | British | 81215590001 | |||||
| VINE CHATTERTON, Laurence | Director | St Marys Kingfisher Corner Old Merrow Street GU4 7AX Guildford Surrey | British | 52625790001 | ||||||
| WALKER, Timothy | Director | Sandhurst Farm Clayhill Road, Lamberhurst TN3 8AX Tunbridge Wells Kent | United Kingdom | British | 64603310001 | |||||
| WHEELER, Simon Crane | Director | Pond Oast Postern Park Farm Postern Lane TN11 0QT Tonbridge Kent | British | 39252030001 | ||||||
| WHITE, Richard William | Director | Hallery House 48 Shurdington Road GL53 0JE Cheltenham Gloucestershire | British | 77704060003 | ||||||
| WINSTONE, Robert James | Director | The Coach House Stanley Road Battledown GL52 6PB Cheltenham Gloucestershire | British | 12687420002 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de KOHLER (UK) LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kohler Mira Limited | 06 abr 2016 | Cromwell Road GL52 5EP Cheltenham Kohler Mira Limited Gloucestershire England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene KOHLER (UK) LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creado el 03 abr 1981 Entregado el 07 abr 1981 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital. & all buildings fixtures (inc. Trade fixtures) fixed plant & machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 04 jul 1978 Entregado el 24 jul 1978 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £85,776.00. | |
Breve descripción Steinel bz 20 machining centre, serial no. ME7 6619. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 11 ene 1940 Entregado el 25 ene 1940 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed & floating charge on undertaking and all property and assets present and future including goodwill & uncalled capital. F/h property in montrose street, littles lane & southampton street, wolverhampton. Together with all fixtures (including trade fixtures) fixed plant & machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0