CARILLION JM LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCARILLION JM LIMITED
    Estado de la empresaLiquidación
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00077628
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CARILLION JM LIMITED?

    • Construcción de edificios comerciales (41201) / Construcción
    • Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
    • Otras actividades de servicios n.c.p. (96090) / Otras actividades de servicios

    ¿Dónde se encuentra CARILLION JM LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Pwc 8th Floor Central Square 29
    Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CARILLION JM LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    MOWLEM LIMITED25 abr 200625 abr 2006
    MOWLEM PLC31 dic 200231 dic 2002
    JOHN MOWLEM & COMPANY PLC08 jun 190308 jun 1903

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CARILLION JM LIMITED?

    Vencido
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 dic 2017
    Próximas cuentas vencen el30 sept 2018
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2016

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para CARILLION JM LIMITED?

    Vencido
    Última declaración de confirmación cerrada hasta02 abr 2018
    Próxima declaración de confirmación vence16 abr 2018
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta02 abr 2017
    Vencido

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CARILLION JM LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Domicilio social registrado cambiado de , Crown House Birch Street, Wolverhampton, WV1 4JX, United Kingdom a Pwc 8th Floor Central Square 29 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 4DL el 23 jul 2019

    2 páginasAD01

    Modification des détails de Carillion Plc en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 oct 2018

    2 páginasPSC05

    Domicilio social registrado cambiado de , Carillion House 84 Salop Street, Wolverhampton, WV3 0SR a Pwc 8th Floor Central Square 29 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 4DL el 01 oct 2018

    1 páginasAD01

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    4 páginasNDISC

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    6 páginasNDISC

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    6 páginasNDISC

    Cese del nombramiento de Richard Francis Tapp como secretario el 25 jun 2018

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Lee James Mills como director el 18 jun 2018

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Francis Robin Herzberg como director el 18 jun 2018

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Westley Maffei como secretario el 04 jun 2018

    1 páginasTM02

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    14 páginasNDISC

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    14 páginasNDISC

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    24 páginasNDISC

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    13 páginasNDISC

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    14 páginasNDISC

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    14 páginasNDISC

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    14 páginasNDISC

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    7 páginasNDISC

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    4 páginasNDISC

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    4 páginasNDISC

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    4 páginasNDISC

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    4 páginasNDISC

    Orden del tribunal para liquidar

    3 páginasCOCOMP

    Cese del nombramiento de Richard John Howson como director el 15 ene 2018

    1 páginasTM01

    Resoluciones

    Resolutions
    34 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01

    ¿Quiénes son los directivos de CARILLION JM LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BIRCHALL, Arthur James
    16 Cheriton Close
    Queens Walk Ealing
    W5 1TR London
    Secretario
    16 Cheriton Close
    Queens Walk Ealing
    W5 1TR London
    British40911100001
    GEORGE, Timothy Francis
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    Secretario
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    British24075160004
    MAFFEI, Westley
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    Secretario
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    235183720001
    TAPP, Richard Francis
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    Secretario
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    British173852420001
    WOODWARD, Keith
    223 Lauderdale Tower
    Barbican
    EC2Y 8BY London
    Secretario
    223 Lauderdale Tower
    Barbican
    EC2Y 8BY London
    British33803420002
    ADAM, Richard John
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    Director
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    United KingdomBritish67133560004
    BARTON, Charles Richard
    38 Rusholme Road
    SW15 3LG London
    Director
    38 Rusholme Road
    SW15 3LG London
    British12889450002
    BAYLES, Geoffrey Francis
    Valley House
    6 Boyce Farm Road
    KT7 0TS Thames Ditton
    Surrey
    Director
    Valley House
    6 Boyce Farm Road
    KT7 0TS Thames Ditton
    Surrey
    United KingdomBritish40127320001
    BECK, Clive
    2 Parkside Gardens
    Wimbledon
    SW19 5EY London
    Director
    2 Parkside Gardens
    Wimbledon
    SW19 5EY London
    British2735240001
    BECK, Edgar Philip, Sir
    Pylle Manor
    Pylle
    BA4 6TD Shepton Mallet
    Somerset
    Director
    Pylle Manor
    Pylle
    BA4 6TD Shepton Mallet
    Somerset
    British612200009
    BOOTH, Karen Jane
    Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    24
    United Kingdom
    Director
    Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    24
    United Kingdom
    United KingdomBritish192636860001
    BROWN, Gerald Thornton
    35 The Conifers
    Pine Ridge New Wokingham Road
    RG45 6TG Crowthorne
    Berkshire
    Director
    35 The Conifers
    Pine Ridge New Wokingham Road
    RG45 6TG Crowthorne
    Berkshire
    EnglandBritish37084320001
    BUNKER, Christopher Jonathan
    9 Regents Riverside
    Brigham Road
    RG1 8QS Reading
    Berkshire
    Director
    9 Regents Riverside
    Brigham Road
    RG1 8QS Reading
    Berkshire
    British77062320001
    CHARLESWORTH, Arthur Leonard
    61 Vicarage Road
    East Sheen
    SW14 8RY London
    Director
    61 Vicarage Road
    East Sheen
    SW14 8RY London
    British26703670001
    DERBY, Joseph
    Denefield
    Rectory Road Oakley
    RG23 7LJ Basingstoke
    Hampshire
    Director
    Denefield
    Rectory Road Oakley
    RG23 7LJ Basingstoke
    Hampshire
    EnglandBritish168320001
    FISHER, Charles Murray
    Warneford House
    Sudgrove
    GL6 7JD Miserden
    Gloucestershire
    Director
    Warneford House
    Sudgrove
    GL6 7JD Miserden
    Gloucestershire
    United KingdomBritish74765660002
    FRY, Anthony Michael
    102 Elgin Crescent
    W11 2JL London
    Director
    102 Elgin Crescent
    W11 2JL London
    EnglandBritish79576680001
    GAINS, Sir John Christopher
    Longridge
    Farm Lane,East Markham
    NG22 0QH Newark
    Nottinghamshire
    Director
    Longridge
    Farm Lane,East Markham
    NG22 0QH Newark
    Nottinghamshire
    British4797420003
    GILL, Matthew Clement Hugh
    Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    24
    United Kingdom
    Director
    Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    24
    United Kingdom
    EnglandBritish160968480002
    GIRLING, Christopher Francis
    12 Spithead Close
    PO34 5AZ Seaview
    Isle Of Wight
    Director
    12 Spithead Close
    PO34 5AZ Seaview
    Isle Of Wight
    British67125270002
    HAYWARD, Alan
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    Director
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    United KingdomBritish154549030001
    HERZBERG, Francis Robin
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    Director
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    EnglandBritish52429400001
    HOWSON, Richard John
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    Director
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    EnglandBritish147650310001
    KHAN, Zafar Iqbal
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    Director
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    EnglandBritish195408780001
    LEDWIDGE, Joseph John
    Sneyd Lane
    WV11 2DX Essington, Wolverhampton
    153
    United Kingdom
    Director
    Sneyd Lane
    WV11 2DX Essington, Wolverhampton
    153
    United Kingdom
    United KingdomBritish105384920001
    LEDWIDGE, Joseph John
    153 Sneyd Lane
    Essington
    WV11 2DX Wolverhampton
    Director
    153 Sneyd Lane
    Essington
    WV11 2DX Wolverhampton
    United KingdomBritish105384920001
    MAINWARING, Paul Richard
    7 Woodlands Park
    Merrow
    GU1 2TH Guildford
    Surrey
    Director
    7 Woodlands Park
    Merrow
    GU1 2TH Guildford
    Surrey
    EnglandBritish116302540001
    MARSHALL, John Roger
    24 Albert Road
    TW11 0BD Teddington
    Middlesex
    Director
    24 Albert Road
    TW11 0BD Teddington
    Middlesex
    British46613440001
    MARSHALL, John Jeremy Seymour
    High Street
    Bourn
    CB23 2SQ Cambridge
    Willow House
    Cambirdgeshire
    Director
    High Street
    Bourn
    CB23 2SQ Cambridge
    Willow House
    Cambirdgeshire
    British133190600001
    MCDONOUGH, John
    Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    24
    West Midlands
    United Kingdom
    Director
    Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    24
    West Midlands
    United Kingdom
    UkBritish74536340007
    MERCER, Emma
    Chester Road
    Boldmere
    B73 5BB Sutton Coldfield
    189
    United Kingdom
    Director
    Chester Road
    Boldmere
    B73 5BB Sutton Coldfield
    189
    United Kingdom
    United KingdomBritish157967530001
    MERCER, Emma
    Cottage
    Lawnhead
    ST20 0JQ Stafford
    Ivy
    Staffordhire
    United Kingdom
    Director
    Cottage
    Lawnhead
    ST20 0JQ Stafford
    Ivy
    Staffordhire
    United Kingdom
    United KingdomBritish137321980002
    MILLS, Lee James
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    Director
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    United KingdomBritish53951880001
    MINTON, Kenneth Joseph
    7 Midway
    AL3 4BD St Albans
    Hertfordshire
    Director
    7 Midway
    AL3 4BD St Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritish513690001
    MOORE, Arthur Harold
    9 Hartswood Road
    W12 9NQ London
    Director
    9 Hartswood Road
    W12 9NQ London
    EnglandBritish14695940001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de CARILLION JM LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Birch Street
    WV1 4JX Wolverhampton
    Crown House
    United Kingdom
    06 abr 2016
    Birch Street
    WV1 4JX Wolverhampton
    Crown House
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaPublic Limited Company
    País de registroEngland & Wales
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro3782379
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene CARILLION JM LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 09 dic 2016
    Entregado el 16 dic 2016
    Pendiente
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Santander UK PLC as Security Agent for the Secured Parties
    Transacciones
    • 16 dic 2016Registro de una carga (MR01)
    Legal charge
    Creado el 01 jul 2005
    Entregado el 02 jul 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Unit 1 falmouth business park, bickland water road falmouth.
    Personas con derecho
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transacciones
    • 02 jul 2005Registro de un cargo (395)
    • 24 abr 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creado el 02 dic 2004
    Entregado el 03 dic 2004
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    All monies standing to the credit of the deposit account.
    Personas con derecho
    • Rathbone Media Limited
    Transacciones
    • 03 dic 2004Registro de un cargo (395)
    Chattel mortgage
    Creado el 30 abr 2004
    Entregado el 07 may 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The equipment being the plant machinery and other equipment being herrenknecht tunnel machine avn 1600 id no. M508, herrenknecht tunnel machine avn 1200C id no. M453, bauer desanding unit id no. 137, for details of further equipment charged please refer to the form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 07 may 2004Registro de un cargo (395)
    • 24 abr 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    The intercreditor deed
    Creado el 07 abr 2004
    Entregado el 16 abr 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By the intercreditor deed, mowlem agree to hold on trust for the benefit of security trustees all monies received from the company and pay such monies to the security trustee towards the discharge of the senior liabilities until they are discharged in full.
    Personas con derecho
    • Hsh Nordbank Ag
    Transacciones
    • 16 abr 2004Registro de un cargo (395)
    • 24 abr 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 18 dic 2001
    Entregado el 20 dic 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £1,100,000.00 due or to become due from the company to the chargee pursuant to the legal charge
    Breve descripción
    All that freehold property situate and known as exchange buildings lowgate kingston upon hull title number HS46178. All movable plant machinery implements building materials furniture andd equipment now or from time to time placed on or used in the above referred to property by way of floating security for payment of the amount secured by the charge.
    Personas con derecho
    • Modern Courts (Humberside) Limited
    Transacciones
    • 20 dic 2001Registro de un cargo (395)
    • 24 jul 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee
    Creado el 27 jul 2001
    Entregado el 28 jul 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    The interest on the principal monies covenanted to be paid by reeb estates limited (the debtor) under and secured (inter alia) by a mortgage dated 27TH july 2001 due to the chargee and all other monies due under the terms of the guarantee
    Breve descripción
    In respect of the guarantors liability hereunder the bank shall have a lien on all securities documents or other property of the guarantor at any time held by the bank. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Julian Hodge Bank Limited
    Transacciones
    • 28 jul 2001Registro de un cargo (395)
    • 17 nov 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene CARILLION JM LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    09 feb 2018Fecha de la petición
    16 feb 2018Inicio de la liquidación
    Liquidación forzosa
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    The Official Receiver Or London
    2nd Floor, 4 Abbey Orchard Street
    Westminster
    SW1P 2HT London
    Profesional
    2nd Floor, 4 Abbey Orchard Street
    Westminster
    SW1P 2HT London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0