CARILLION JM LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | CARILLION JM LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Liquidación |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 00077628 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de CARILLION JM LIMITED?
- Construcción de edificios comerciales (41201) / Construcción
- Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
- Otras actividades de servicios n.c.p. (96090) / Otras actividades de servicios
¿Dónde se encuentra CARILLION JM LIMITED?
| Dirección de la sede social | Pwc 8th Floor Central Square 29 Wellington Street LS1 4DL Leeds West Yorkshire |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CARILLION JM LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| MOWLEM LIMITED | 25 abr 2006 | 25 abr 2006 |
| MOWLEM PLC | 31 dic 2002 | 31 dic 2002 |
| JOHN MOWLEM & COMPANY PLC | 08 jun 1903 | 08 jun 1903 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de CARILLION JM LIMITED?
| Vencido | Sí |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2017 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2018 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2016 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para CARILLION JM LIMITED?
| Vencido | Sí |
|---|---|
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 02 abr 2018 |
| Próxima declaración de confirmación vence | 16 abr 2018 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 02 abr 2017 |
| Vencido | Sí |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para CARILLION JM LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domicilio social registrado cambiado de , Crown House Birch Street, Wolverhampton, WV1 4JX, United Kingdom a Pwc 8th Floor Central Square 29 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 4DL el 23 jul 2019 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Modification des détails de Carillion Plc en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 oct 2018 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de , Carillion House 84 Salop Street, Wolverhampton, WV3 0SR a Pwc 8th Floor Central Square 29 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 4DL el 01 oct 2018 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 4 páginas | NDISC | ||||||||||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 6 páginas | NDISC | ||||||||||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 6 páginas | NDISC | ||||||||||
Cese del nombramiento de Richard Francis Tapp como secretario el 25 jun 2018 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Lee James Mills como director el 18 jun 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Francis Robin Herzberg como director el 18 jun 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Westley Maffei como secretario el 04 jun 2018 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 14 páginas | NDISC | ||||||||||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 14 páginas | NDISC | ||||||||||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 24 páginas | NDISC | ||||||||||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 13 páginas | NDISC | ||||||||||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 14 páginas | NDISC | ||||||||||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 14 páginas | NDISC | ||||||||||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 14 páginas | NDISC | ||||||||||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 7 páginas | NDISC | ||||||||||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 4 páginas | NDISC | ||||||||||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 4 páginas | NDISC | ||||||||||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 4 páginas | NDISC | ||||||||||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 4 páginas | NDISC | ||||||||||
Orden del tribunal para liquidar | 3 páginas | COCOMP | ||||||||||
Cese del nombramiento de Richard John Howson como director el 15 ene 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 34 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de CARILLION JM LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIRCHALL, Arthur James | Secretario | 16 Cheriton Close Queens Walk Ealing W5 1TR London | British | 40911100001 | ||||||
| GEORGE, Timothy Francis | Secretario | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | British | 24075160004 | ||||||
| MAFFEI, Westley | Secretario | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | 235183720001 | |||||||
| TAPP, Richard Francis | Secretario | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | British | 173852420001 | ||||||
| WOODWARD, Keith | Secretario | 223 Lauderdale Tower Barbican EC2Y 8BY London | British | 33803420002 | ||||||
| ADAM, Richard John | Director | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | United Kingdom | British | 67133560004 | |||||
| BARTON, Charles Richard | Director | 38 Rusholme Road SW15 3LG London | British | 12889450002 | ||||||
| BAYLES, Geoffrey Francis | Director | Valley House 6 Boyce Farm Road KT7 0TS Thames Ditton Surrey | United Kingdom | British | 40127320001 | |||||
| BECK, Clive | Director | 2 Parkside Gardens Wimbledon SW19 5EY London | British | 2735240001 | ||||||
| BECK, Edgar Philip, Sir | Director | Pylle Manor Pylle BA4 6TD Shepton Mallet Somerset | British | 612200009 | ||||||
| BOOTH, Karen Jane | Director | Birch Street WV1 4HY Wolverhampton 24 United Kingdom | United Kingdom | British | 192636860001 | |||||
| BROWN, Gerald Thornton | Director | 35 The Conifers Pine Ridge New Wokingham Road RG45 6TG Crowthorne Berkshire | England | British | 37084320001 | |||||
| BUNKER, Christopher Jonathan | Director | 9 Regents Riverside Brigham Road RG1 8QS Reading Berkshire | British | 77062320001 | ||||||
| CHARLESWORTH, Arthur Leonard | Director | 61 Vicarage Road East Sheen SW14 8RY London | British | 26703670001 | ||||||
| DERBY, Joseph | Director | Denefield Rectory Road Oakley RG23 7LJ Basingstoke Hampshire | England | British | 168320001 | |||||
| FISHER, Charles Murray | Director | Warneford House Sudgrove GL6 7JD Miserden Gloucestershire | United Kingdom | British | 74765660002 | |||||
| FRY, Anthony Michael | Director | 102 Elgin Crescent W11 2JL London | England | British | 79576680001 | |||||
| GAINS, Sir John Christopher | Director | Longridge Farm Lane,East Markham NG22 0QH Newark Nottinghamshire | British | 4797420003 | ||||||
| GILL, Matthew Clement Hugh | Director | Birch Street WV1 4HY Wolverhampton 24 United Kingdom | England | British | 160968480002 | |||||
| GIRLING, Christopher Francis | Director | 12 Spithead Close PO34 5AZ Seaview Isle Of Wight | British | 67125270002 | ||||||
| HAYWARD, Alan | Director | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | United Kingdom | British | 154549030001 | |||||
| HERZBERG, Francis Robin | Director | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | England | British | 52429400001 | |||||
| HOWSON, Richard John | Director | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | England | British | 147650310001 | |||||
| KHAN, Zafar Iqbal | Director | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | England | British | 195408780001 | |||||
| LEDWIDGE, Joseph John | Director | Sneyd Lane WV11 2DX Essington, Wolverhampton 153 United Kingdom | United Kingdom | British | 105384920001 | |||||
| LEDWIDGE, Joseph John | Director | 153 Sneyd Lane Essington WV11 2DX Wolverhampton | United Kingdom | British | 105384920001 | |||||
| MAINWARING, Paul Richard | Director | 7 Woodlands Park Merrow GU1 2TH Guildford Surrey | England | British | 116302540001 | |||||
| MARSHALL, John Roger | Director | 24 Albert Road TW11 0BD Teddington Middlesex | British | 46613440001 | ||||||
| MARSHALL, John Jeremy Seymour | Director | High Street Bourn CB23 2SQ Cambridge Willow House Cambirdgeshire | British | 133190600001 | ||||||
| MCDONOUGH, John | Director | Birch Street WV1 4HY Wolverhampton 24 West Midlands United Kingdom | Uk | British | 74536340007 | |||||
| MERCER, Emma | Director | Chester Road Boldmere B73 5BB Sutton Coldfield 189 United Kingdom | United Kingdom | British | 157967530001 | |||||
| MERCER, Emma | Director | Cottage Lawnhead ST20 0JQ Stafford Ivy Staffordhire United Kingdom | United Kingdom | British | 137321980002 | |||||
| MILLS, Lee James | Director | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | United Kingdom | British | 53951880001 | |||||
| MINTON, Kenneth Joseph | Director | 7 Midway AL3 4BD St Albans Hertfordshire | United Kingdom | British | 513690001 | |||||
| MOORE, Arthur Harold | Director | 9 Hartswood Road W12 9NQ London | England | British | 14695940001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de CARILLION JM LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carillion Plc | 06 abr 2016 | Birch Street WV1 4JX Wolverhampton Crown House United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene CARILLION JM LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creado el 09 dic 2016 Entregado el 16 dic 2016 | Pendiente | ||
Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 01 jul 2005 Entregado el 02 jul 2005 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Unit 1 falmouth business park, bickland water road falmouth. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Rent deposit deed | Creado el 02 dic 2004 Entregado el 03 dic 2004 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Breve descripción All monies standing to the credit of the deposit account. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Chattel mortgage | Creado el 30 abr 2004 Entregado el 07 may 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción The equipment being the plant machinery and other equipment being herrenknecht tunnel machine avn 1600 id no. M508, herrenknecht tunnel machine avn 1200C id no. M453, bauer desanding unit id no. 137, for details of further equipment charged please refer to the form 395. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| The intercreditor deed | Creado el 07 abr 2004 Entregado el 16 abr 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción By the intercreditor deed, mowlem agree to hold on trust for the benefit of security trustees all monies received from the company and pay such monies to the security trustee towards the discharge of the senior liabilities until they are discharged in full. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 18 dic 2001 Entregado el 20 dic 2001 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £1,100,000.00 due or to become due from the company to the chargee pursuant to the legal charge | |
Breve descripción All that freehold property situate and known as exchange buildings lowgate kingston upon hull title number HS46178. All movable plant machinery implements building materials furniture andd equipment now or from time to time placed on or used in the above referred to property by way of floating security for payment of the amount secured by the charge. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Guarantee | Creado el 27 jul 2001 Entregado el 28 jul 2001 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada The interest on the principal monies covenanted to be paid by reeb estates limited (the debtor) under and secured (inter alia) by a mortgage dated 27TH july 2001 due to the chargee and all other monies due under the terms of the guarantee | |
Breve descripción In respect of the guarantors liability hereunder the bank shall have a lien on all securities documents or other property of the guarantor at any time held by the bank. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene CARILLION JM LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación forzosa |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0