KVAERNER ENERGY LIMITED

KVAERNER ENERGY LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaKVAERNER ENERGY LIMITED
    Estado de la empresaLiquidación
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00089980
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de KVAERNER ENERGY LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra KVAERNER ENERGY LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Forvis Mazars Llp
    30 Old Bailey
    EC4M 7AU London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de KVAERNER ENERGY LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    JOHN BROWN ENGINEERING LIMITED31 dic 198031 dic 1980
    JOHN BROWN ENGINEERING (CLYDE BANK) LIMITED28 ago 190628 ago 1906

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de KVAERNER ENERGY LIMITED?

    Vencido
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 dic 2013
    Próximas cuentas vencen el30 sept 2014
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2012

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para KVAERNER ENERGY LIMITED?

    Vencido
    Última declaración de confirmación cerrada hasta02 abr 2017
    Próxima declaración de confirmación vence16 abr 2017
    Vencido

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para KVAERNER ENERGY LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual
    Vencido

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para KVAERNER ENERGY LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 27 may 2024

    11 páginasLIQ03

    Domicilio social registrado cambiado de 30 Old Bailey London EC4M 7AU a Forvis Mazars Llp 30 Old Bailey London EC4M 7AU el 26 jul 2024

    3 páginasAD01

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 27 may 2023

    12 páginasLIQ03

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 27 may 2022

    11 páginasLIQ03

    Domicilio social registrado cambiado de Tower Bridge House St Katharines Way London E1W 1DD a 30 Old Bailey London EC4M 7AU el 13 may 2022

    2 páginasAD01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    17 páginas600

    Destitución del liquidador por orden judicial

    2 páginasLIQ10

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 27 may 2021

    10 páginasLIQ03

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 27 may 2019

    15 páginasLIQ03

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 27 may 2018

    14 páginasLIQ03

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 27 may 2017

    14 páginasLIQ03

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    2 páginas600

    Orden judicial de insolvencia

    Court order insolvency:C.O. To remove/replace liquidator
    28 páginasLIQ MISC OC

    Aviso de cese de funciones como liquidador voluntario

    1 páginas4.40

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 27 may 2016

    5 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 27 may 2015

    6 páginas4.68

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    2 páginas600

    Orden judicial de insolvencia

    Court order INSOLVENCY:replacement of liquidator
    10 páginasLIQ MISC OC

    Aviso de cese de funciones como liquidador voluntario

    1 páginas4.40

    Declaración de asuntos con el formulario adjunto 4.19

    5 páginas4.20

    Domicilio social registrado cambiado de * Surrey House 36-44 High Street Redhill Surrey RH1 1RH* el 09 jun 2014

    2 páginasAD01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo extraordinario para la liquidación

    LRESEX

    Déclaration annuelle établie au 02 abr 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital11 abr 2014

    Estado de capital el 11 abr 2014

    • Capital: GBP 82,000,000
    SH01

    Cambio de datos del director Rufus Laycock el 26 feb 2014

    3 páginasCH01

    ¿Quiénes son los directivos de KVAERNER ENERGY LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    LAYCOCK, Rufus
    33 Burghley Avenue
    KT3 4SW New Malden
    Surrey
    Secretario
    33 Burghley Avenue
    KT3 4SW New Malden
    Surrey
    British42000530001
    LAYCOCK, Rufus
    30 Old Bailey
    EC4M 7AU London
    Forvis Mazars Llp
    Director
    30 Old Bailey
    EC4M 7AU London
    Forvis Mazars Llp
    United KingdomBritishCompany Secretary7584610002
    NILSEN, Runar
    30 Old Bailey
    EC4M 7AU London
    Forvis Mazars Llp
    Director
    30 Old Bailey
    EC4M 7AU London
    Forvis Mazars Llp
    NorwegianCeo And Cfo102391880002
    HIORTH, Thomas
    Langoddveien 81
    No-1367 Snaroya
    Norway
    Secretario
    Langoddveien 81
    No-1367 Snaroya
    Norway
    Norwegian85164320002
    MACLEOD, Donald Malcolm Rees
    7 Queens Court 114 East Clyde Street
    Helensburgh
    G84 7AH Glasgow
    Dunbartonshire
    Secretario
    7 Queens Court 114 East Clyde Street
    Helensburgh
    G84 7AH Glasgow
    Dunbartonshire
    British45197950001
    MCGREGOR, Fiona
    11 Ewing Walk
    Milngavie
    G62 6EG Glasgow
    Secretario
    11 Ewing Walk
    Milngavie
    G62 6EG Glasgow
    BritishSolicitor64533810001
    O'HARE, Paul
    6 Mansefield Avenue
    Cambuslang
    G72 8NY Glasgow
    Secretario
    6 Mansefield Avenue
    Cambuslang
    G72 8NY Glasgow
    BritishAccountant59944510001
    QUEEN, Stuart
    Duncrub Park House
    Dunning
    PH2 0QR Perth
    Perthshire
    Secretario
    Duncrub Park House
    Dunning
    PH2 0QR Perth
    Perthshire
    BritishAccountant67165200001
    BEVERIDGE, Donald Mcintosh
    27 Polnoon Street
    Eaglesham
    G76 0BH Glasgow
    Director
    27 Polnoon Street
    Eaglesham
    G76 0BH Glasgow
    BritishEngineer46793640001
    CUMMINGS, Richard
    Larkfield Court 10/5 Wardie Road
    EH5 3QD Edinburgh
    Midlothian
    Director
    Larkfield Court 10/5 Wardie Road
    EH5 3QD Edinburgh
    Midlothian
    BritishDirector824550001
    FARSTAD, Atle
    Flat 3 6 Upper Brook Street
    W1Y 1PA London
    Director
    Flat 3 6 Upper Brook Street
    W1Y 1PA London
    NorwegianDirector50057960003
    FINNE, Hans Petter
    32 Gloucester Walk
    W8 4HY London
    Director
    32 Gloucester Walk
    W8 4HY London
    NorwegianCompany Director50130950001
    FORREST, William Williamson
    Cremanan
    Balfron
    G63 0QP Glasgow
    Director
    Cremanan
    Balfron
    G63 0QP Glasgow
    BritishEngineer15514730002
    FOSSHEIM, Edgar Andreas
    Dalhaugveien 46
    Tronheim 7020
    Norway
    Director
    Dalhaugveien 46
    Tronheim 7020
    Norway
    NorwegianPersonel Administrator64673580001
    GISVOLD, Rune
    Iver Holters Vei 36
    N1710 Kolbotn
    Norway
    Director
    Iver Holters Vei 36
    N1710 Kolbotn
    Norway
    NorwegianCfo85499620001
    GORMLY, Allan Graham
    56 North Park
    SL9 8JR Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Director
    56 North Park
    SL9 8JR Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    BritishChartered Accountant1308140001
    GRAY, Thomas William
    40 Redclyffe Gardens
    G84 9JJ Helensburgh
    Dunbartonshire
    Director
    40 Redclyffe Gardens
    G84 9JJ Helensburgh
    Dunbartonshire
    BritishEngineer17324900001
    HANSON, Derek
    9 Honeywood House
    28 Alington Road Canford Cliffs
    BH14 8LZ Poole
    Dorset
    Director
    9 Honeywood House
    28 Alington Road Canford Cliffs
    BH14 8LZ Poole
    Dorset
    BritishDirector8271310002
    HEGGELUND, Jan Magne
    126 Silverdale Avenue
    KT12 1EH Walton On Thames
    Surrey
    Director
    126 Silverdale Avenue
    KT12 1EH Walton On Thames
    Surrey
    BritishCfo67742180002
    HELLUM, Geir Ivar
    Kringsjaagrenda 2
    Oslo 0861
    FOREIGN Norway
    Director
    Kringsjaagrenda 2
    Oslo 0861
    FOREIGN Norway
    NorwegianEngineer58021570001
    HEPBURN, Robert George
    The Crossways 33 Charlotte Street
    G84 7SE Helensburgh
    Dunbartonshire
    Director
    The Crossways 33 Charlotte Street
    G84 7SE Helensburgh
    Dunbartonshire
    ScotlandScottishDirector16084680001
    HIORTH, Thomas
    Langoddveien 81
    No-1367 Snaroya
    Norway
    Director
    Langoddveien 81
    No-1367 Snaroya
    Norway
    NorwegianAccountant85164320002
    LAYCOCK, Rufus
    Burghley Avenue
    KT3 4SW New Malden
    33
    Surrey
    Director
    Burghley Avenue
    KT3 4SW New Malden
    33
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Secretary7584610001
    MACLENNAN, Gordon
    15 Gibson Road
    PA4 0RH Renfrew
    Renfrewshire
    Director
    15 Gibson Road
    PA4 0RH Renfrew
    Renfrewshire
    ScotlandBritishEngineer15514720001
    MARTIN-LOF, Roland
    17 Kensington Court Gardens
    W8 5QF London
    Director
    17 Kensington Court Gardens
    W8 5QF London
    SwedishAccountant64612330001
    MCCABE, Raymond Arthur
    10 Craignethan Road
    Whitecraigs
    G46 6SQ Glasgow
    Director
    10 Craignethan Road
    Whitecraigs
    G46 6SQ Glasgow
    BritishAccountant421900001
    NICHOLLS, Brian
    Croy Shandon
    G84 8NN Helensburgh
    Dunbartonshire
    Director
    Croy Shandon
    G84 8NN Helensburgh
    Dunbartonshire
    BritishDirector45345590001
    PACKARD, Christopher John
    Dolphin Lodge
    2a East Montrose Street
    G84 7EP Helensburgh
    Dunbartonshire
    Director
    Dolphin Lodge
    2a East Montrose Street
    G84 7EP Helensburgh
    Dunbartonshire
    ScotlandBritishEngineer35532090001
    RICH, Nigel Mervyn Sutherland
    65 Chelsea Square
    SW3 6LE London
    Director
    65 Chelsea Square
    SW3 6LE London
    United KingdomBritishDirector50875570003
    ROBINSON, Ian, Sir
    29 St Germains
    Bearsden
    G61 2RS Glasgow
    Director
    29 St Germains
    Bearsden
    G61 2RS Glasgow
    BritishChartered Engineer74491260002
    SIMPSON, Norman
    40 Neilston Road
    Uplawmoor
    G78 4AB Glasgow
    Director
    40 Neilston Road
    Uplawmoor
    G78 4AB Glasgow
    BritishAccountant60075600002
    SOBERG, Otto
    Trettebakken 6
    0755 Oslo
    Norway
    Director
    Trettebakken 6
    0755 Oslo
    Norway
    NorwegianDirector48074890001
    SVANEVIK, Orjan
    Baldersgate 10
    FOREIGN 0263 Oslo
    Norway
    Director
    Baldersgate 10
    FOREIGN 0263 Oslo
    Norway
    NorwegianSvp Group Business Development90050730001
    TONSETH, Erik
    10 Charles Street
    W1X 7HB London
    Director
    10 Charles Street
    W1X 7HB London
    NorwegianCompany Director48350850001
    WILLIAMS, Nigel Edward Oliver
    17 Holmes Road
    Strawberry Hill
    TW1 4RF Twickenham
    Middlesex
    Director
    17 Holmes Road
    Strawberry Hill
    TW1 4RF Twickenham
    Middlesex
    EnglandBritishSolicitor8325950001

    ¿Tiene KVAERNER ENERGY LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Letter of charge
    Creado el 10 abr 1995
    Entregado el 21 abr 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All monies standing to the credit of the account of the company with the bank's international division glasgow numbered 00021FRF01 and designated bank of scotland international division manager o/a john brown engineering letter of credit no N1370.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 21 abr 1995Registro de un cargo (395)
    • 14 feb 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Standard security presented for registration in scotland on 28.5.84
    Creado el 28 may 1984
    Entregado el 11 jun 1984
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Clydebank engineering works lying in the parish of old or west kilpatrick dumbarton.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 11 jun 1984Registro de una carga
    • 26 jun 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Standard security presented for registration in scotland on 28.5.84
    Creado el 23 may 1984
    Entregado el 11 jun 1984
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Plot of ground O.88 acres approx lying generally on the south west side of glasgow road and east south east side of wallace street clydebank.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 11 jun 1984Registro de una carga
    • 17 oct 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 23 may 1984
    Entregado el 25 may 1984
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to national westminster bank PLC as trustees for the parties named in the debenture.
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all f/h & l/h property all fixtures & fittings. Stocks shares and other securities. Book & other debts goodwill & the benefit of any licenses floating charge on please see doc M180. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 25 may 1984Registro de una carga
    • 10 ago 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fifth supplemental trust deed
    Creado el 23 may 1984
    Entregado el 23 may 1984
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    For securing £742,000 47/8 per cent secured loan stock 2003 and £2,416,915 5 5/8 percent secured loan stock 2003 of john brown PLC and all other monies intended to be secured by this deed constituted by a trust deed 19.12.68 and deeds supplemental thereto.
    Breve descripción
    Floating charge on the (see doc M181). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • Alliance Assurance Company Limited
    Transacciones
    • 23 may 1984Registro de una carga
    • 06 ene 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene KVAERNER ENERGY LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    28 may 2014Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de acreedores
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Guy Robert Thomas Hollander
    Tower Bridge House St Katharine S Way
    E1W 1DD London
    Profesional
    Tower Bridge House St Katharine S Way
    E1W 1DD London
    Michael James Wellard
    Tower Bridge House St Katharines Way
    E1W 1DD London
    Profesional
    Tower Bridge House St Katharines Way
    E1W 1DD London
    Adam Harris
    Tower Bridge House St Katherines Way
    E1W 1DD London
    Profesional
    Tower Bridge House St Katherines Way
    E1W 1DD London
    Roderick John Weston
    Mazars Llp Tower Bridge House
    St Katharines Way
    E1W 1DD London
    Profesional
    Mazars Llp Tower Bridge House
    St Katharines Way
    E1W 1DD London
    Neil John Mather
    Tower Bridge House St Katharines Way
    E1W 1DD London
    Profesional
    Tower Bridge House St Katharines Way
    E1W 1DD London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0