MAPPIN & WEBB HOLDINGS LIMITED

MAPPIN & WEBB HOLDINGS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaMAPPIN & WEBB HOLDINGS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00100620
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de MAPPIN & WEBB HOLDINGS LIMITED?

    • (7499) /

    ¿Dónde se encuentra MAPPIN & WEBB HOLDINGS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Aurum House 2 Elland Road
    Braunstone
    LE3 1TT Leicester
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de MAPPIN & WEBB HOLDINGS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    MAPPIN & WEBB LIMITED10 dic 190810 dic 1908

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de MAPPIN & WEBB HOLDINGS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 ene 2010

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para MAPPIN & WEBB HOLDINGS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Déclaration annuelle établie au 10 jul 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital13 jul 2010

    Estado de capital el 13 jul 2010

    • Capital: GBP 1,264,248
    SH01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 ene 2010

    3 páginasAA

    Cuentas completas preparadas hasta el 01 feb 2009

    11 páginasAA

    Cambio de datos del director Mr Richard Edwin Gerrard el 05 oct 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Justin Paul David Stead el 05 oct 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Stephen Clive Sargent el 05 oct 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Anthony John Broderick el 05 oct 2009

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Mrs Gillian Oliff el 05 oct 2009

    1 páginasCH03

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    5 páginas363a

    Cuentas completas preparadas hasta el 03 feb 2008

    12 páginasAA

    legacy

    5 páginas363a

    legacy

    1 páginas287

    legacy

    1 páginas288c

    legacy

    1 páginas288c

    legacy

    1 páginas288c

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    Cuentas completas preparadas hasta el 27 ene 2007

    12 páginasAA

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    2 páginas288a

    ¿Quiénes son los directivos de MAPPIN & WEBB HOLDINGS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    OLIFF, Gillian
    2 Elland Road
    Braunstone
    LE3 1TT Leicester
    Aurum House
    Secretario
    2 Elland Road
    Braunstone
    LE3 1TT Leicester
    Aurum House
    British128108960001
    BRODERICK, Anthony John
    2 Elland Road
    Braunstone
    LE3 1TT Leicester
    Aurum House
    Director
    2 Elland Road
    Braunstone
    LE3 1TT Leicester
    Aurum House
    EnglandBritish98431500001
    GERRARD, Richard Edwin
    2 Elland Road
    Braunstone
    LE3 1TT Leicester
    Aurum House
    Director
    2 Elland Road
    Braunstone
    LE3 1TT Leicester
    Aurum House
    EnglandBritish124068680001
    SARGENT, Stephen Clive
    2 Elland Road
    Braunstone
    LE3 1TT Leicester
    Aurum House
    Director
    2 Elland Road
    Braunstone
    LE3 1TT Leicester
    Aurum House
    EnglandBritish16905350005
    STEAD, Justin Paul David
    2 Elland Road
    Braunstone
    LE3 1TT Leicester
    Aurum House
    Director
    2 Elland Road
    Braunstone
    LE3 1TT Leicester
    Aurum House
    EnglandAustralian116638810003
    FISHER, Mark
    The Cottage
    London Road
    SG8 9LT Royston
    Hertfordshire
    Secretario
    The Cottage
    London Road
    SG8 9LT Royston
    Hertfordshire
    British61931900002
    FISHER, Mark
    The Cottage
    London Road
    SG8 9LT Royston
    Hertfordshire
    Secretario
    The Cottage
    London Road
    SG8 9LT Royston
    Hertfordshire
    British61931900002
    GREGG, Terence Michael
    6 Chilterns End Close
    RG9 1SQ Henley On Thames
    Oxfordshire
    Secretario
    6 Chilterns End Close
    RG9 1SQ Henley On Thames
    Oxfordshire
    British64357220001
    HARRINGTON, Nicholas Joseph
    9 Kingsmead Avenue
    KT4 8XB Worcester Park
    Surrey
    Secretario
    9 Kingsmead Avenue
    KT4 8XB Worcester Park
    Surrey
    British1273670001
    LOBB, Andrew Mark
    33 Lyndhurst Avenue
    NW7 2AD London
    Secretario
    33 Lyndhurst Avenue
    NW7 2AD London
    British74760630002
    PAGE, Elizabeth
    Flat 3
    5 St Leonards Road, Ealing
    W13 8PN London
    Secretario
    Flat 3
    5 St Leonards Road, Ealing
    W13 8PN London
    British34006010001
    REID, Michael John
    49 Waldemar Avenue
    W13 9PZ London
    Secretario
    49 Waldemar Avenue
    W13 9PZ London
    Irish950490001
    RIVERS, Paul Edward
    Fox Cottage 1a Abingdon Road
    Tubney
    OX13 5QL Abingdon
    Oxfordshire
    Secretario
    Fox Cottage 1a Abingdon Road
    Tubney
    OX13 5QL Abingdon
    Oxfordshire
    British62321110002
    ADAMS, David Alexander Robertson
    Applegarth Three Elm Lane
    Hadlow
    TN11 0AB Tonbridge
    Kent
    Director
    Applegarth Three Elm Lane
    Hadlow
    TN11 0AB Tonbridge
    Kent
    EnglandBritish55757700003
    ASPREY, John Rolls
    166 New Bond Street
    W1Y 0AR London
    Director
    166 New Bond Street
    W1Y 0AR London
    United KingdomBritish68034280002
    ATTALLAH, Naim Ibrahim
    Flat 15
    51 South Street
    W1Y 5PA London
    Director
    Flat 15
    51 South Street
    W1Y 5PA London
    United KingdomBritish25646240001
    BERKMEN, Gillian
    Orchard View 27 Woodhill Avenue
    SL9 8DP Gerrards Cross
    South Buckinghamshire
    Director
    Orchard View 27 Woodhill Avenue
    SL9 8DP Gerrards Cross
    South Buckinghamshire
    GbBritish92154270001
    BROWN, Andrew Saville
    123 Edenfield Gardens
    KT4 7DX Worcester Park
    Surrey
    Director
    123 Edenfield Gardens
    KT4 7DX Worcester Park
    Surrey
    United KingdomBritish69874610002
    COOPER, Caroline
    222 Caraway 2 Cayenne Court
    32 Shad Thames
    SE1 2PP London
    Director
    222 Caraway 2 Cayenne Court
    32 Shad Thames
    SE1 2PP London
    British92733900001
    DAHL, Ian Xavier
    2 Heathfield Lodge
    Carron Lane
    GU29 9LD Midhurst
    West Sussex
    Director
    2 Heathfield Lodge
    Carron Lane
    GU29 9LD Midhurst
    West Sussex
    British66486140001
    EVANS, Nicholas David
    6 Raddington Road
    W10 5TF London
    Director
    6 Raddington Road
    W10 5TF London
    United KingdomBritish57490310002
    FISHER, Mark
    The Cottage
    London Road
    SG8 9LT Royston
    Hertfordshire
    Director
    The Cottage
    London Road
    SG8 9LT Royston
    Hertfordshire
    British61931900002
    GREEN, Edward Maurice
    82 Portland Place
    W1N 3DH London
    Director
    82 Portland Place
    W1N 3DH London
    British47989150001
    GREGG, Terence Michael
    6 Chilterns End Close
    RG9 1SQ Henley On Thames
    Oxfordshire
    Director
    6 Chilterns End Close
    RG9 1SQ Henley On Thames
    Oxfordshire
    British64357220001
    LOWDEN, David Soutar
    The Squirrels
    Riversdale
    SL8 5EB Bourne End
    Buckinghamshire
    Director
    The Squirrels
    Riversdale
    SL8 5EB Bourne End
    Buckinghamshire
    EnglandBritish54836190001
    MCCLOSKEY, Ciaran
    Whitehouse Farm
    PE12 0HE Sutton St James
    Lincolnshire
    Director
    Whitehouse Farm
    PE12 0HE Sutton St James
    Lincolnshire
    British88312080001
    PIASECKI, Jerzy Stanislaw
    Mill Lane
    Lower Shiplake
    RG9 3ND Henley On Thames
    Lockend House
    Oxon
    Director
    Mill Lane
    Lower Shiplake
    RG9 3ND Henley On Thames
    Lockend House
    Oxon
    EnglandBritish129561330001
    PILKINGTON, Judith Mary
    43 The Nautilus Building
    3 Myddleton Passage
    EC1R 1XW London
    Director
    43 The Nautilus Building
    3 Myddleton Passage
    EC1R 1XW London
    United KingdomBritish106791670001
    REID, Michael John
    49 Waldemar Avenue
    W13 9PZ London
    Director
    49 Waldemar Avenue
    W13 9PZ London
    EnglandIrish950490001
    RIVERS, Paul Edward
    Fox Cottage 1a Abingdon Road
    Tubney
    OX13 5QL Abingdon
    Oxfordshire
    Director
    Fox Cottage 1a Abingdon Road
    Tubney
    OX13 5QL Abingdon
    Oxfordshire
    EnglandBritish62321110002
    SIGURDSSON, Gunnar
    4 Greenlink Walk
    Kew Riverside
    TW9 4AF Richmond Upon Thames
    London
    Director
    4 Greenlink Walk
    Kew Riverside
    TW9 4AF Richmond Upon Thames
    London
    EnglandIcelandic114179720001
    SUMMERS, Jeffrey
    5 Ashley Road
    Stoke Albany
    LE16 8PL Market Harborough
    Leicestershire
    Director
    5 Ashley Road
    Stoke Albany
    LE16 8PL Market Harborough
    Leicestershire
    British127606650001
    WEST, James Edward
    4 Church Lane
    Stanford On Avon
    NN6 6JP Northampton
    Northamptonshire
    Director
    4 Church Lane
    Stanford On Avon
    NN6 6JP Northampton
    Northamptonshire
    EnglandBritish14107350002

    ¿Tiene MAPPIN & WEBB HOLDINGS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Deed of debenture
    Creado el 22 nov 2005
    Entregado el 02 dic 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Landsbanki Islands Hf
    Transacciones
    • 02 dic 2005Registro de un cargo (395)
    • 12 ene 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of debenture made between the company and others as chargors and burdale financial limited as agent and trustee for itself and each of the finance parties
    Creado el 05 jun 2001
    Entregado el 13 jun 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All present and future obligations and liabilities of each obligor to the finance parties (or any of them) under the finance documents (all terms as defined)
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Burdale Financial Limited
    Transacciones
    • 13 jun 2001Registro de un cargo (395)
    • 13 ene 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee and debenture under the tranche b loan agreement dated 24TH december 1998 between the company and the agent
    Creado el 24 dic 1998
    Entregado el 02 ene 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Bankboston N.A.(As Agent and Trustee for the Lenders)
    Transacciones
    • 02 ene 1999Registro de un cargo (395)
    • 26 jun 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creado el 24 dic 1998
    Entregado el 02 ene 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the loan documents (and each of them) which shall for the avoidance of doubt include the debenture and the guarantee set out therein
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Bankboston N.A. (As Agent for the Lenders)
    Transacciones
    • 02 ene 1999Registro de un cargo (395)
    • 28 sept 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Security agreement
    Creado el 29 jun 1995
    Entregado el 06 jul 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All the companies right title and interest in "the real property" as defined in form 395 together with fixed charge all of each charging companys right title and interest in and to the "investments" (as defined in the security agreement) any rights or assets belonging to the company deriving from such investments. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank Plcas Trustee for the Secured Creditors
    Transacciones
    • 06 jul 1995Registro de un cargo (395)
    • 07 feb 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Demise supplemental to trust deed of 15 jan 1909 registered pursuant to an order of court dated 10 december 1915
    Creado el 10 nov 1915
    Entregado el 15 dic 1915
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    An issue of £250,000 debenture stock
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets at the time of the registration of the said debenture issue being both the present demise is in substitution of certain property in norfolk street sheffield for property no 220 regent street london present and future including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • W.J. Mappin
    • V. Alexander
    • C.H. Passingham
    • E.W. Grimwade
    Transacciones
    • 15 dic 1915Registro de una carga
    • 12 jul 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Land registry charge supplemental to trust deed dated 15 january 1909
    Creado el 22 oct 1909
    Entregado el 26 oct 1909
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £250,000 debenture stock
    Breve descripción
    Mansion house buildings queen victoria street the land comprised in land registry title no 120242 city of london. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • W.J. Mappin
    • E.W. Grimwade
    • V. Alexander
    • C.H. Passingham
    Transacciones
    • 26 oct 1909Registro de una carga
    • 12 jul 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Instrument of charge under land transfer acts 1875 & 1897
    Creado el 15 sept 1909
    Entregado el 18 sept 1909
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £250,000
    Breve descripción
    158, 160 & 162 oxford street and 1 & 2 winsley street and land comprised in the title no 88368 district london parish st.marylebone.
    Personas con derecho
    • E.W.Grimwade
    • V.Alexander
    • W.J.Mappin
    • C.H. Passingham
    Transacciones
    • 18 sept 1909Registro de una carga
    • 12 jul 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0