THOMAS COOK RETAIL LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | THOMAS COOK RETAIL LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Liquidación |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 00102630 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de THOMAS COOK RETAIL LIMITED?
- Actividades de agencias de viajes (79110) / Actividades administrativas y de apoyo
¿Dónde se encuentra THOMAS COOK RETAIL LIMITED?
| Dirección de la sede social | C/O Interpath Ltd 10 Fleet Place EC4M 7RB London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de THOMAS COOK RETAIL LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| GOING PLACES LEISURE TRAVEL LIMITED | 27 dic 1993 | 27 dic 1993 |
| PICKFORDS TRAVEL SERVICE LIMITED | 22 abr 1909 | 22 abr 1909 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de THOMAS COOK RETAIL LIMITED?
| Vencido | Sí |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 30 sept 2019 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2020 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 sept 2018 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para THOMAS COOK RETAIL LIMITED?
| Vencido | Sí |
|---|---|
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 03 abr 2020 |
| Próxima declaración de confirmación vence | 17 abr 2020 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 03 abr 2019 |
| Vencido | Sí |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para THOMAS COOK RETAIL LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Domicilio social registrado cambiado de 10 Fleet Place London EC4M 6FZ a C/O Interpath Ltd 10 Fleet Place London EC4M 7RB el 01 nov 2022 | 2 páginas | AD01 | ||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 4 páginas | NDISC | ||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 4 páginas | NDISC | ||
Domicilio social registrado cambiado de Kpmg Llp 15 Canada Square Canary Wharf London E14 5GL a 10 Fleet Place London EC4M 6FZ el 31 dic 2021 | 2 páginas | AD01 | ||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 4 páginas | NDISC | ||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 4 páginas | NDISC | ||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 4 páginas | NDISC | ||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 4 páginas | NDISC | ||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 4 páginas | NDISC | ||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 4 páginas | NDISC | ||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 4 páginas | NDISC | ||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 5 páginas | NDISC | ||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 5 páginas | NDISC | ||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 5 páginas | NDISC | ||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 5 páginas | NDISC | ||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 5 páginas | NDISC | ||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 4 páginas | NDISC | ||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 4 páginas | NDISC | ||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 4 páginas | NDISC | ||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 4 páginas | NDISC | ||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 4 páginas | NDISC | ||
Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia | 4 páginas | NDISC | ||
Domicilio social registrado cambiado de Kpmg Llp, Botanic House, 100 Hills Road Cambridge Cambridgeshire CB2 1AR a Kpmg Llp 15 Canada Square Canary Wharf London E14 5GL el 15 oct 2019 | 2 páginas | AD01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de Westpoint Peterborough Business Park Lynch Wood Peterborough PE2 6FZ England a Kpmg Llp, Botanic House, 100 Hills Road Cambridge Cambridgeshire CB2 1AR el 07 oct 2019 | 2 páginas | AD01 | ||
Orden del tribunal para liquidar | 7 páginas | COCOMP | ||
¿Quiénes son los directivos de THOMAS COOK RETAIL LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRADLEY, Shirley | Secretario | 10 Fleet Place EC4M 7RB London C/O Interpath Ltd | British | 65475670001 | ||||||||||
| RUSSELL, Justin Lee | Director | 10 Fleet Place EC4M 7RB London C/O Interpath Ltd | United Kingdom | British | 259488950001 | |||||||||
| THOMAS COOK GROUP MANAGEMENT SERVICES LIMITED | Director corporativo | Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6FZ Peterborough Westpoint England |
| 146474110001 | ||||||||||
| BURNS, David Campbell | Secretario | 12 Broadway WA15 0PG Hale Cheshire | British | 73653730001 | ||||||||||
| DETKO, Tadeusz Stephen | Secretario | Yew Tree Barn White Horse Lane Barton PR3 5AH Preston Lancashire | British | 77446300001 | ||||||||||
| MCMAHON, Gregory Joseph | Secretario | Hollin Grove 5 Holly Grove Dobcross OL3 5JQ Oldham Lancashire | British | 49723980004 | ||||||||||
| THORNELL, Beverley Jane | Secretario | Shorts Farm Cottage Plaistow RH14 0PJ Billingshurst West Sussex | British | 63063940002 | ||||||||||
| N F C SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | The Merton Centre 45 St Peters Street MK40 2UB Bedford Bedfordshire | 32524900003 | |||||||||||
| ARTHUR, Nigel John | Director | The Thomas Cook Business Park Coningsby Road PE3 8SB Peterborough | England | English | 175689210001 | |||||||||
| BARRASS, Steven Robert | Director | 11 The Woodlands Brockhall Village BB6 8BH Blackshaw Lancashire | British | 112159920001 | ||||||||||
| BAVISTER, John Howard | Director | 21 Fox Hill SE19 2UX London | England | British | 96232900001 | |||||||||
| BAYNARD, Stephen | Director | Bracklands House Hazel Grove GU26 6JB Hindhead Surrey | British | 35719760002 | ||||||||||
| BENNETT, Anthony John | Director | 13 Hale End GU22 0LH Woking Surrey | England | British | 75260940001 | |||||||||
| BLACKLEDGE, David Albert | Director | The Stoop Stanley SN15 3RF Chippenham Wiltshire | England | British | 123065010001 | |||||||||
| BLOODWORTH, John Milton | Director | 29 Thorn Road Bramhall SK7 1HG Stockport | American | 100712540002 | ||||||||||
| BURNS, David Campbell | Director | 12 Broadway WA15 0PG Hale Cheshire | British | 73653730001 | ||||||||||
| CHARNOCK, Alison | Director | The Stables Cross Farm Liverpool Old Road PR4 6HR Tarleton Preston | United Kingdom | British | 161617710001 | |||||||||
| CLANCY, Timothy Patrick | Director | 6 The Mount WA14 4DX Altrincham Cheshire | United Kingdom | British | 76313780002 | |||||||||
| COE, Albert Henry | Director | 48 Broad Walk SK9 5PL Wilmslow Cheshire | British | 3977310001 | ||||||||||
| COLLINSON, Harold Hugh | Director | Raaes Wyke Longlands Road LA23 1DL Windermere Cumbria | England | British | 104953440001 | |||||||||
| CONLON, James Martin | Director | Killonan IRISH Ballysimon County Limerick Eire | Ireland | Irish | 125103490001 | |||||||||
| CONNOLLY, Aidan Joseph | Director | Ridgeways 18 Chiltern Hills Road HP9 1PL Beaconsfield Buckinghamshire | England | British | 100376210001 | |||||||||
| CROSSLAND, David | Director | Daisy Hill House La Cheuve Rue JE3 9EH Grouville Jersey | Jersey | British | 3977330005 | |||||||||
| DAVIES, Roger Oliver | Director | 7 Elsworthy Road NW3 3DS London | United Kingdom | British | 13540001 | |||||||||
| DONALD, Alan Charles | Director | Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6FZ Peterborough Westpoint England | England | British | 252692000001 | |||||||||
| ECSERY MERRENS, Francesca Eva | Director | 60 Grove Park Road W4 3SD London | British | 47923900001 | ||||||||||
| ENDACOTT, Steven | Director | 19 Hamnet Close Banktop Astley Bridge BL1 7RZ Bolton | British | 66781360002 | ||||||||||
| EVANS, Paul Richard | Director | Alderne House Horsted Lane RH19 4HX Sharpthorne West Sussex | United Kingdom | British | 103115560001 | |||||||||
| FISHER, Terry | Director | Greylands Sharp Lane HD4 6SW Huddersfield West Yorkshire | British | 69021830001 | ||||||||||
| GADSBY, Christopher James | Director | The Thomas Cook Business Park Coningsby Road PE3 8SB Peterborough | England | British | 118396090002 | |||||||||
| HALLISEY, David Michael William | Director | The Thomas Cook Business Park Coningsby Road PE3 8SB Peterborough | England | British | 1919030001 | |||||||||
| HARRIS, David Ronald | Director | 2 Sheridan Place Winwick Park WA2 8XG Warrington Cheshire | British | 98073810001 | ||||||||||
| HEMINGWAY, Paul Andrew | Director | Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6FZ Peterborough Westpoint England | United Kingdom | British | 188221460001 | |||||||||
| JARDINE, David | Director | The Old Cottage Hough End SK9 7JD Alderley Edge Cheshire | British | 105046880001 | ||||||||||
| JONES, Bryn Rhys | Director | 39 Royal Chase TN4 8AX Tunbridge Wells Kent | British | 7382330001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de THOMAS COOK RETAIL LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Cook Group Uk Limited | 06 abr 2016 | Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6FZ Peterborough Westpoint England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene THOMAS COOK RETAIL LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Construction account charge | Creado el 02 abr 1999 Entregado el 22 abr 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada The obligations of the company to the chargee to pay the developer for the fit out works and any changes in accordance with clause 8 of the prelet agreements (as defined) | |
Breve descripción All secured obligations and full credit balance thereon with all related rights/benefits therewith. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Deed of charge under land transfer acts 1875 and 1897 supplemental to a mortgage dated 6/8/24 | Creado el 20 mar 1925 Entregado el 24 mar 1925 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £13,444 | |
Breve descripción Land at rear of 60 and 62 long lane southwark t/n 292898. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Mortgage | Creado el 06 ago 1924 Entregado el 08 ago 1924 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada For further securing principal sum of £13,444 secured by a debenture dated 16/5/12 | |
Breve descripción 1-9 cardol place southwark and heriditaments in long lane and tabard street southwark. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Mortgage supplemental to indenture DATED15/5/12 and further charge dated 8/4/18 | Creado el 02 nov 1923 Entregado el 08 nov 1923 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £146,500 | |
Breve descripción F/H property at loose road maidstone dover road folkstone st. John's road lowerstoft and sussex road brighton. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene THOMAS COOK RETAIL LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación forzosa |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0