THOMAS COOK RETAIL LIMITED

THOMAS COOK RETAIL LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTHOMAS COOK RETAIL LIMITED
    Estado de la empresaLiquidación
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00102630
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de THOMAS COOK RETAIL LIMITED?

    • Actividades de agencias de viajes (79110) / Actividades administrativas y de apoyo

    ¿Dónde se encuentra THOMAS COOK RETAIL LIMITED?

    Dirección de la sede social
    C/O Interpath Ltd
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de THOMAS COOK RETAIL LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    GOING PLACES LEISURE TRAVEL LIMITED27 dic 199327 dic 1993
    PICKFORDS TRAVEL SERVICE LIMITED22 abr 190922 abr 1909

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de THOMAS COOK RETAIL LIMITED?

    Vencido
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el30 sept 2019
    Próximas cuentas vencen el30 sept 2020
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 sept 2018

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para THOMAS COOK RETAIL LIMITED?

    Vencido
    Última declaración de confirmación cerrada hasta03 abr 2020
    Próxima declaración de confirmación vence17 abr 2020
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta03 abr 2019
    Vencido

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para THOMAS COOK RETAIL LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Domicilio social registrado cambiado de 10 Fleet Place London EC4M 6FZ a C/O Interpath Ltd 10 Fleet Place London EC4M 7RB el 01 nov 2022

    2 páginasAD01

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    4 páginasNDISC

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    4 páginasNDISC

    Domicilio social registrado cambiado de Kpmg Llp 15 Canada Square Canary Wharf London E14 5GL a 10 Fleet Place London EC4M 6FZ el 31 dic 2021

    2 páginasAD01

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    4 páginasNDISC

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    4 páginasNDISC

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    4 páginasNDISC

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    4 páginasNDISC

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    4 páginasNDISC

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    4 páginasNDISC

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    4 páginasNDISC

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    5 páginasNDISC

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    5 páginasNDISC

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    5 páginasNDISC

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    5 páginasNDISC

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    5 páginasNDISC

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    4 páginasNDISC

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    4 páginasNDISC

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    4 páginasNDISC

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    4 páginasNDISC

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    4 páginasNDISC

    Notificación al Registro Mercantil de la notificación de renuncia

    4 páginasNDISC

    Domicilio social registrado cambiado de Kpmg Llp, Botanic House, 100 Hills Road Cambridge Cambridgeshire CB2 1AR a Kpmg Llp 15 Canada Square Canary Wharf London E14 5GL el 15 oct 2019

    2 páginasAD01

    Domicilio social registrado cambiado de Westpoint Peterborough Business Park Lynch Wood Peterborough PE2 6FZ England a Kpmg Llp, Botanic House, 100 Hills Road Cambridge Cambridgeshire CB2 1AR el 07 oct 2019

    2 páginasAD01

    Orden del tribunal para liquidar

    7 páginasCOCOMP

    ¿Quiénes son los directivos de THOMAS COOK RETAIL LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BRADLEY, Shirley
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    C/O Interpath Ltd
    Secretario
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    C/O Interpath Ltd
    British65475670001
    RUSSELL, Justin Lee
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    C/O Interpath Ltd
    Director
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    C/O Interpath Ltd
    United KingdomBritish259488950001
    THOMAS COOK GROUP MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6FZ Peterborough
    Westpoint
    England
    Director corporativo
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6FZ Peterborough
    Westpoint
    England
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registro3696823
    146474110001
    BURNS, David Campbell
    12 Broadway
    WA15 0PG Hale
    Cheshire
    Secretario
    12 Broadway
    WA15 0PG Hale
    Cheshire
    British73653730001
    DETKO, Tadeusz Stephen
    Yew Tree Barn
    White Horse Lane Barton
    PR3 5AH Preston
    Lancashire
    Secretario
    Yew Tree Barn
    White Horse Lane Barton
    PR3 5AH Preston
    Lancashire
    British77446300001
    MCMAHON, Gregory Joseph
    Hollin Grove
    5 Holly Grove Dobcross
    OL3 5JQ Oldham
    Lancashire
    Secretario
    Hollin Grove
    5 Holly Grove Dobcross
    OL3 5JQ Oldham
    Lancashire
    British49723980004
    THORNELL, Beverley Jane
    Shorts Farm Cottage
    Plaistow
    RH14 0PJ Billingshurst
    West Sussex
    Secretario
    Shorts Farm Cottage
    Plaistow
    RH14 0PJ Billingshurst
    West Sussex
    British63063940002
    N F C SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    The Merton Centre
    45 St Peters Street
    MK40 2UB Bedford
    Bedfordshire
    Secretario corporativo
    The Merton Centre
    45 St Peters Street
    MK40 2UB Bedford
    Bedfordshire
    32524900003
    ARTHUR, Nigel John
    The Thomas Cook Business Park
    Coningsby Road
    PE3 8SB Peterborough
    Director
    The Thomas Cook Business Park
    Coningsby Road
    PE3 8SB Peterborough
    EnglandEnglish175689210001
    BARRASS, Steven Robert
    11 The Woodlands
    Brockhall Village
    BB6 8BH Blackshaw
    Lancashire
    Director
    11 The Woodlands
    Brockhall Village
    BB6 8BH Blackshaw
    Lancashire
    British112159920001
    BAVISTER, John Howard
    21 Fox Hill
    SE19 2UX London
    Director
    21 Fox Hill
    SE19 2UX London
    EnglandBritish96232900001
    BAYNARD, Stephen
    Bracklands House
    Hazel Grove
    GU26 6JB Hindhead
    Surrey
    Director
    Bracklands House
    Hazel Grove
    GU26 6JB Hindhead
    Surrey
    British35719760002
    BENNETT, Anthony John
    13 Hale End
    GU22 0LH Woking
    Surrey
    Director
    13 Hale End
    GU22 0LH Woking
    Surrey
    EnglandBritish75260940001
    BLACKLEDGE, David Albert
    The Stoop
    Stanley
    SN15 3RF Chippenham
    Wiltshire
    Director
    The Stoop
    Stanley
    SN15 3RF Chippenham
    Wiltshire
    EnglandBritish123065010001
    BLOODWORTH, John Milton
    29 Thorn Road
    Bramhall
    SK7 1HG Stockport
    Director
    29 Thorn Road
    Bramhall
    SK7 1HG Stockport
    American100712540002
    BURNS, David Campbell
    12 Broadway
    WA15 0PG Hale
    Cheshire
    Director
    12 Broadway
    WA15 0PG Hale
    Cheshire
    British73653730001
    CHARNOCK, Alison
    The Stables
    Cross Farm Liverpool Old Road
    PR4 6HR Tarleton
    Preston
    Director
    The Stables
    Cross Farm Liverpool Old Road
    PR4 6HR Tarleton
    Preston
    United KingdomBritish161617710001
    CLANCY, Timothy Patrick
    6 The Mount
    WA14 4DX Altrincham
    Cheshire
    Director
    6 The Mount
    WA14 4DX Altrincham
    Cheshire
    United KingdomBritish76313780002
    COE, Albert Henry
    48 Broad Walk
    SK9 5PL Wilmslow
    Cheshire
    Director
    48 Broad Walk
    SK9 5PL Wilmslow
    Cheshire
    British3977310001
    COLLINSON, Harold Hugh
    Raaes Wyke
    Longlands Road
    LA23 1DL Windermere
    Cumbria
    Director
    Raaes Wyke
    Longlands Road
    LA23 1DL Windermere
    Cumbria
    EnglandBritish104953440001
    CONLON, James Martin
    Killonan
    IRISH Ballysimon
    County Limerick
    Eire
    Director
    Killonan
    IRISH Ballysimon
    County Limerick
    Eire
    IrelandIrish125103490001
    CONNOLLY, Aidan Joseph
    Ridgeways 18 Chiltern Hills Road
    HP9 1PL Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Director
    Ridgeways 18 Chiltern Hills Road
    HP9 1PL Beaconsfield
    Buckinghamshire
    EnglandBritish100376210001
    CROSSLAND, David
    Daisy Hill House
    La Cheuve Rue
    JE3 9EH Grouville
    Jersey
    Director
    Daisy Hill House
    La Cheuve Rue
    JE3 9EH Grouville
    Jersey
    JerseyBritish3977330005
    DAVIES, Roger Oliver
    7 Elsworthy Road
    NW3 3DS London
    Director
    7 Elsworthy Road
    NW3 3DS London
    United KingdomBritish13540001
    DONALD, Alan Charles
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6FZ Peterborough
    Westpoint
    England
    Director
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6FZ Peterborough
    Westpoint
    England
    EnglandBritish252692000001
    ECSERY MERRENS, Francesca Eva
    60 Grove Park Road
    W4 3SD London
    Director
    60 Grove Park Road
    W4 3SD London
    British47923900001
    ENDACOTT, Steven
    19 Hamnet Close
    Banktop Astley Bridge
    BL1 7RZ Bolton
    Director
    19 Hamnet Close
    Banktop Astley Bridge
    BL1 7RZ Bolton
    British66781360002
    EVANS, Paul Richard
    Alderne House
    Horsted Lane
    RH19 4HX Sharpthorne
    West Sussex
    Director
    Alderne House
    Horsted Lane
    RH19 4HX Sharpthorne
    West Sussex
    United KingdomBritish103115560001
    FISHER, Terry
    Greylands
    Sharp Lane
    HD4 6SW Huddersfield
    West Yorkshire
    Director
    Greylands
    Sharp Lane
    HD4 6SW Huddersfield
    West Yorkshire
    British69021830001
    GADSBY, Christopher James
    The Thomas Cook Business Park
    Coningsby Road
    PE3 8SB Peterborough
    Director
    The Thomas Cook Business Park
    Coningsby Road
    PE3 8SB Peterborough
    EnglandBritish118396090002
    HALLISEY, David Michael William
    The Thomas Cook Business Park
    Coningsby Road
    PE3 8SB Peterborough
    Director
    The Thomas Cook Business Park
    Coningsby Road
    PE3 8SB Peterborough
    EnglandBritish1919030001
    HARRIS, David Ronald
    2 Sheridan Place
    Winwick Park
    WA2 8XG Warrington
    Cheshire
    Director
    2 Sheridan Place
    Winwick Park
    WA2 8XG Warrington
    Cheshire
    British98073810001
    HEMINGWAY, Paul Andrew
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6FZ Peterborough
    Westpoint
    England
    Director
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6FZ Peterborough
    Westpoint
    England
    United KingdomBritish188221460001
    JARDINE, David
    The Old Cottage
    Hough End
    SK9 7JD Alderley Edge
    Cheshire
    Director
    The Old Cottage
    Hough End
    SK9 7JD Alderley Edge
    Cheshire
    British105046880001
    JONES, Bryn Rhys
    39 Royal Chase
    TN4 8AX Tunbridge Wells
    Kent
    Director
    39 Royal Chase
    TN4 8AX Tunbridge Wells
    Kent
    British7382330001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de THOMAS COOK RETAIL LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6FZ Peterborough
    Westpoint
    England
    06 abr 2016
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6FZ Peterborough
    Westpoint
    England
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalUnited Kingdom (England And Wales)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro2319744
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene THOMAS COOK RETAIL LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Construction account charge
    Creado el 02 abr 1999
    Entregado el 22 abr 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    The obligations of the company to the chargee to pay the developer for the fit out works and any changes in accordance with clause 8 of the prelet agreements (as defined)
    Breve descripción
    All secured obligations and full credit balance thereon with all related rights/benefits therewith. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • David John George Royds and Robert John Hugo Randall,the Trustees of the Ventura No 2 Syndicatetrust
    Transacciones
    • 22 abr 1999Registro de un cargo (395)
    • 06 jun 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    Deed of charge under land transfer acts 1875 and 1897 supplemental to a mortgage dated 6/8/24
    Creado el 20 mar 1925
    Entregado el 24 mar 1925
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £13,444
    Breve descripción
    Land at rear of 60 and 62 long lane southwark t/n 292898.
    Personas con derecho
    • Lloyd Harry Baxendale
    Transacciones
    • 24 mar 1925Registro de una carga
    • 11 ago 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage
    Creado el 06 ago 1924
    Entregado el 08 ago 1924
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    For further securing principal sum of £13,444 secured by a debenture dated 16/5/12
    Breve descripción
    1-9 cardol place southwark and heriditaments in long lane and tabard street southwark.
    Personas con derecho
    • Lloyd Harry Baxendale
    Transacciones
    • 08 ago 1924Registro de una carga
    • 11 ago 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage supplemental to indenture DATED15/5/12 and further charge dated 8/4/18
    Creado el 02 nov 1923
    Entregado el 08 nov 1923
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £146,500
    Breve descripción
    F/H property at loose road maidstone dover road folkstone st. John's road lowerstoft and sussex road brighton.
    Personas con derecho
    • Legal and General Assurance Society Limited
    Transacciones
    • 08 nov 1923Registro de una carga
    • 11 ago 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene THOMAS COOK RETAIL LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    23 sept 2019Fecha de la petición
    23 sept 2019Inicio de la liquidación
    Liquidación forzosa
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    The Official Receiver Or London
    2nd Floor, 4 Abbey Orchard Street
    Westminster
    SW1P 2HT London
    Profesional
    2nd Floor, 4 Abbey Orchard Street
    Westminster
    SW1P 2HT London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0