DOROTHY PERKINS LIMITED

DOROTHY PERKINS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaDOROTHY PERKINS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00106273
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de DOROTHY PERKINS LIMITED?

    • Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción
    • Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra DOROTHY PERKINS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    30 Old Bailey
    EC4M 7AU London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de DOROTHY PERKINS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta01 sept 2018

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para DOROTHY PERKINS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de acreedores

    18 páginasLIQ14

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 28 jun 2022

    23 páginasLIQ03

    Domicilio social registrado cambiado de Tower Bridge House St. Katharines Way London E1W 1DD a 30 Old Bailey London EC4M 7AU el 11 may 2022

    2 páginasAD01

    Domicilio social registrado cambiado de Colegrave House 70 Berners Street London W1T 3NL a Tower Bridge House St. Katharines Way London E1W 1DD el 14 jul 2021

    2 páginasAD01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    3 páginas600

    Declaración de asuntos

    10 páginasLIQ02

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo extraordinario para la liquidación el 29 jun 2021

    LRESEX

    Cese del nombramiento de Rebecca Rose Flaherty como secretario el 21 abr 2021

    1 páginasTM02

    Declaración de confirmación presentada el 01 jun 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 01 sept 2018

    17 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 01 jun 2019 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cambio de datos del director Mrs Gillian Anne Hague el 16 ene 2019

    2 páginasCH01

    Declaración de confirmación presentada el 01 jun 2018 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 26 ago 2017

    13 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 01 jun 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 27 ago 2016

    20 páginasAA

    Cambio de datos del director Mrs Sally Marion Wightman el 19 ago 2016

    2 páginasCH01

    Déclaration annuelle établie au 01 jun 2016 avec liste complète des actionnaires

    8 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital09 jun 2016

    Estado de capital el 09 jun 2016

    • Capital: GBP 1,848,498.75
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 29 ago 2015

    17 páginasAA

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 ago 2014

    17 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 jun 2015 avec liste complète des actionnaires

    8 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital04 jun 2015

    Estado de capital el 04 jun 2015

    • Capital: GBP 1,848,498.75
    SH01

    Nombramiento de Rebecca Rose Flaherty como secretario el 19 dic 2014

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Anthony Gordon Farndon como secretario el 19 dic 2014

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Gurpal Premi como secretario el 03 oct 2014

    1 páginasTM02

    ¿Quiénes son los directivos de DOROTHY PERKINS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BURCHILL, Richard Leeroy
    70 Berners Street
    W1T 3NL London
    Colegrave House
    England
    Director
    70 Berners Street
    W1T 3NL London
    Colegrave House
    England
    United KingdomBritish115568070002
    DEDOMBAL, Richard
    Blackmoor Lane
    Bardsey
    LS17 9DY Leeds
    46
    United Kingdom
    Director
    Blackmoor Lane
    Bardsey
    LS17 9DY Leeds
    46
    United Kingdom
    United KingdomBritish165695440001
    HAGUE, Gillian Anne
    70 Berners Street
    W1T 3NL London
    Colegrave House
    England
    Director
    70 Berners Street
    W1T 3NL London
    Colegrave House
    England
    United KingdomBritish99223490001
    WIGHTMAN, Sally Marion
    Crowlees Road
    Mirfield
    WF14 9PR West Yorkshire
    4a
    United Kingdom
    Director
    Crowlees Road
    Mirfield
    WF14 9PR West Yorkshire
    4a
    United Kingdom
    United KingdomBritish158198380002
    BERGAMIN, Jayabaduri
    12 Newry Road
    TW1 1PL Twickenham
    Middlesex
    Secretario
    12 Newry Road
    TW1 1PL Twickenham
    Middlesex
    British116935080001
    CASH, Daphne Valerie
    20 Chichester Mews
    SE27 0NS London
    Secretario
    20 Chichester Mews
    SE27 0NS London
    British59646330004
    COX, Michelle Hazel
    154 Eastwood Road North
    SS9 4LZ Leigh On Sea
    Essex
    Secretario
    154 Eastwood Road North
    SS9 4LZ Leigh On Sea
    Essex
    British104461530003
    FARNDON, Anthony Gordon
    W14 8AJ London
    Flat 3a, 27 Upper Addison Gardens, Kensington,
    United Kingdom
    Secretario
    W14 8AJ London
    Flat 3a, 27 Upper Addison Gardens, Kensington,
    United Kingdom
    192149300001
    FLAHERTY, Rebecca Rose
    70 Berners Street
    W1T 3NL London
    Colegrave House
    United Kingdom
    Secretario
    70 Berners Street
    W1T 3NL London
    Colegrave House
    United Kingdom
    193607220001
    HICKS, Beverley
    7 Westminster Court
    King & Queen Wharf Rotherhithe
    SE16 5SY London
    Secretario
    7 Westminster Court
    King & Queen Wharf Rotherhithe
    SE16 5SY London
    British92357410001
    HODGES, John
    The Old Orchard Burney Road
    Westhumble
    RH5 6AU Dorking
    Surrey
    Secretario
    The Old Orchard Burney Road
    Westhumble
    RH5 6AU Dorking
    Surrey
    British3666240001
    JACKMAN, Ian Peter
    Flat 11 Macready House
    75 Crawford Street
    W1H 5LR London
    Secretario
    Flat 11 Macready House
    75 Crawford Street
    W1H 5LR London
    British71660800001
    JACKMAN, Ian Peter
    Flat 11 Macready House
    75 Crawford Street
    W1H 5LR London
    Secretario
    Flat 11 Macready House
    75 Crawford Street
    W1H 5LR London
    British71660800001
    PREMI, Gurpal
    Colegrave House
    Berners Street
    W1T 3NL London
    Arcadia Group Limited
    England
    Secretario
    Colegrave House
    Berners Street
    W1T 3NL London
    Arcadia Group Limited
    England
    British180478370001
    RODIE, Kimberly Donna
    Falcon Grove
    SW11 2ST Clapham
    26
    London
    United Kingdom
    Secretario
    Falcon Grove
    SW11 2ST Clapham
    26
    London
    United Kingdom
    Other134585610002
    SMITH, Philip Clayton
    24 Bishops Avenue
    Elstree
    WD6 3LZ Borehamwood
    Hertfordshire
    Secretario
    24 Bishops Avenue
    Elstree
    WD6 3LZ Borehamwood
    Hertfordshire
    British613980001
    STEVENSON, Rebecca Jayne
    49 Rivulet Road
    Tottenham
    N17 7JT London
    Secretario
    49 Rivulet Road
    Tottenham
    N17 7JT London
    British71917770002
    WALDRON, Aisha Leah
    Bookerhill Road
    HP12 4HA High Wycombe
    29
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Secretario
    Bookerhill Road
    HP12 4HA High Wycombe
    29
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    161204100001
    BATES, David John
    11 The Laurels
    Potten End
    HP4 2SP Berkhamsted
    Hertfordshire
    Director
    11 The Laurels
    Potten End
    HP4 2SP Berkhamsted
    Hertfordshire
    United KingdomBritish613990001
    BOTTOMLEY, Andrew Christopher
    Hill Brow
    Queens Road
    HX3 8RA Norwood Green Halifax
    West Yorkshire
    Director
    Hill Brow
    Queens Road
    HX3 8RA Norwood Green Halifax
    West Yorkshire
    British89625410001
    BROWN, David Nigel
    116 Clarence Road
    AL1 4NW St Albans
    Hertfordshire
    Director
    116 Clarence Road
    AL1 4NW St Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritish40354400003
    CROSSLAND, Julie Sook Hein
    9 Rowallan Road
    SW6 6AF London
    Director
    9 Rowallan Road
    SW6 6AF London
    EnglandBritish70464290002
    DUCKELS, Colin Peter
    14 Woodlands Park
    Scarcroft
    LS14 3JU Leeds
    West Yorkshire
    Director
    14 Woodlands Park
    Scarcroft
    LS14 3JU Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish44237310004
    GOLDMAN, Adam Alexander
    4 Jenner Way
    Clarendon Park
    KT19 7LJ Epsom
    Surrey
    Director
    4 Jenner Way
    Clarendon Park
    KT19 7LJ Epsom
    Surrey
    EnglandBritish28466260004
    HEALEY, Mark Anthony
    70 Berners Street
    W1T 3NL London
    Colegrave House
    England
    Director
    70 Berners Street
    W1T 3NL London
    Colegrave House
    England
    EnglandBritish77432550002
    HODGES, John
    The Old Orchard Burney Road
    Westhumble
    RH5 6AU Dorking
    Surrey
    Director
    The Old Orchard Burney Road
    Westhumble
    RH5 6AU Dorking
    Surrey
    British3666240001
    JACKMAN, Ian Peter
    Flat 11 Macready House
    75 Crawford Street
    W1H 5LR London
    Director
    Flat 11 Macready House
    75 Crawford Street
    W1H 5LR London
    British71660800001
    KILBEY, Graham John
    20 Brookmans Avenue
    Brookmans Park
    AL9 7QJ Hatfield
    Hertfordshire
    Director
    20 Brookmans Avenue
    Brookmans Park
    AL9 7QJ Hatfield
    Hertfordshire
    EnglandBritish150198820001
    SMITH, Philip Clayton
    24 Bishops Avenue
    Elstree
    WD6 3LZ Borehamwood
    Hertfordshire
    Director
    24 Bishops Avenue
    Elstree
    WD6 3LZ Borehamwood
    Hertfordshire
    British613980001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de DOROTHY PERKINS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    70 Berners Street
    W1T 3NL London
    Colegrave House
    United Kingdom
    06 abr 2016
    70 Berners Street
    W1T 3NL London
    Colegrave House
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalUnited Kingdom (England And Wales)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro00237511
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.

    ¿Tiene DOROTHY PERKINS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 14 dic 2004
    Entregado el 23 dic 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the charging companies to the chargee and/or the other security beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (Security Trustee)
    Transacciones
    • 23 dic 2004Registro de un cargo (395)
    • 04 feb 2013Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Deed of accession to a composite guarantee and debenture dated 10 september 2002
    Creado el 18 dic 2002
    Entregado el 23 dic 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All present and future obligations and liabilities of each charging company to the security trustee and the security beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland Acting in Its Capacity as Security Trustee Forthe Security Beneficiaries (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 23 dic 2002Registro de un cargo (395)
    • 18 ene 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage
    Creado el 03 jul 1931
    Adquirido el 16 feb 1939
    Entregado el 24 mar 1939
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    £1473 18/6 owing
    Breve descripción
    Freehold property, 10 ironmarket newcastle-under lyme, staffs.
    Personas con derecho
    • Mrs H Greenwood
    Transacciones
    • 24 mar 1939Registro de una carga

    ¿Tiene DOROTHY PERKINS LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    29 jun 2021Inicio de la liquidación
    30 nov 2023Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de acreedores
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Guy Robert Thomas Hollander
    Tower Bridge House St Katharine S Way
    E1W 1DD London
    Profesional
    Tower Bridge House St Katharine S Way
    E1W 1DD London
    Adam Harris
    Tower Bridge House St Katharines Way
    E1W 1DD London
    Profesional
    Tower Bridge House St Katharines Way
    E1W 1DD London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0