NAMESHELL 2 LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaNAMESHELL 2 LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00106501
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de NAMESHELL 2 LIMITED?

    • (7415) /

    ¿Dónde se encuentra NAMESHELL 2 LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Windsor House
    Barnett Way
    GL4 3RT Barnwood
    Gloucester
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de NAMESHELL 2 LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    HEATH GROUP LIMITED20 abr 199820 abr 1998
    C.E. HEATH PUBLIC LIMITED COMPANY17 dic 190917 dic 1909

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de NAMESHELL 2 LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2004

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para NAMESHELL 2 LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 10 feb 2011

    5 páginas4.68

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    3 páginas4.71

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 11 dic 2010

    5 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 11 jun 2010

    5 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 11 dic 2009

    5 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 11 jun 2009

    5 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 11 dic 2008

    5 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 11 dic 2008

    5 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador

    5 páginas4.68

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación

    LRESSP

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    legacy

    1 páginas287

    legacy

    1 páginas287

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2004

    11 páginasAA

    legacy

    7 páginas363s

    legacy

    4 páginas288a

    legacy

    3 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    Certificado de cambio de nombre

    Company name changed heath group LIMITED\certificate issued on 02/06/05
    2 páginasCERTNM

    legacy

    7 páginas363s

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2003

    12 páginasAA

    legacy

    3 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    ¿Quiénes son los directivos de NAMESHELL 2 LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    HL CORPORATE SERVICES LIMITED
    Friary Court
    Crutched Friars
    EC3N 2NP London
    Secretario corporativo
    Friary Court
    Crutched Friars
    EC3N 2NP London
    43700080004
    BLOOMER, William David
    Barry Road
    East Dulwich
    SE22 0JS London
    214
    Director
    Barry Road
    East Dulwich
    SE22 0JS London
    214
    United KingdomBritish72374560002
    BRUCE, Michael Andrew
    Royston Manor St Peter's Lane
    Clayworth
    DN22 9AA Retford
    Nottinghamshire
    Director
    Royston Manor St Peter's Lane
    Clayworth
    DN22 9AA Retford
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish61928170002
    THOMAS, Robert Nigel
    South West House
    Weston Road
    BA1 2XU Bath
    Avon
    Director
    South West House
    Weston Road
    BA1 2XU Bath
    Avon
    United KindgomBritish40630840002
    ROWE, Nicholas
    Amberly House
    The Cleave
    OX11 0EL Harwell
    Oxfordshire
    Secretario
    Amberly House
    The Cleave
    OX11 0EL Harwell
    Oxfordshire
    British33862660001
    BROADHURST, Timothy Edward
    Highfield House Main Road
    Knockholt
    TN14 7NU Sevenoaks
    Kent
    Director
    Highfield House Main Road
    Knockholt
    TN14 7NU Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritish8657480001
    BURTON, Michael John
    4a Langton Way
    SE3 7TL London
    Director
    4a Langton Way
    SE3 7TL London
    British63922600001
    CLAY, John Martin
    1 Hertsfield Oast
    Staplehurst Road Marden
    TN12 9BW Tonbridge
    Kent
    Director
    1 Hertsfield Oast
    Staplehurst Road Marden
    TN12 9BW Tonbridge
    Kent
    British1524000003
    CROWNE, Peter Charles
    74c
    Granville Park
    SE13 7DX London
    Director
    74c
    Granville Park
    SE13 7DX London
    British68603490001
    DUFFIELD, Peter William John
    Copyhold
    Eridge
    TN3 9LN Tunbridge Wells
    Kent
    Director
    Copyhold
    Eridge
    TN3 9LN Tunbridge Wells
    Kent
    British94820000001
    FIELDING, Richard Walter
    West Hall
    Longburton
    DT9 5PF Sherborne
    Dorset
    Director
    West Hall
    Longburton
    DT9 5PF Sherborne
    Dorset
    United KingdomBritish77656210001
    HUGHES, Paul John
    96 Burnham Road
    SS9 2JS Leigh On Sea
    Essex
    Director
    96 Burnham Road
    SS9 2JS Leigh On Sea
    Essex
    EnglandBritish5389800001
    KIER, Michael Hector
    23 Belmont Road
    TW2 5DA Twickenham
    Middlesex
    Director
    23 Belmont Road
    TW2 5DA Twickenham
    Middlesex
    Danish8719670001
    MACKAY, Ian Hamish Noel
    27 Percy Laurie House
    217 Upper Richmond Road
    SW15 6SY London
    Director
    27 Percy Laurie House
    217 Upper Richmond Road
    SW15 6SY London
    British104334150001
    MACKENZIE GREEN, John Garvie
    Higher Langdon
    DT8 3NN Beaminster
    Dorset
    Director
    Higher Langdon
    DT8 3NN Beaminster
    Dorset
    British34988570004
    MONEY, Anthony John
    Bevingdon House
    Belchamp Otten
    CO10 7BE Sudbury
    Suffolk
    Director
    Bevingdon House
    Belchamp Otten
    CO10 7BE Sudbury
    Suffolk
    EnglandBritish8785440001
    MORROW, Ian, Sir
    Broadacres
    7 Devils Lane
    CB11 4BB Saffron Walden
    Essex
    Director
    Broadacres
    7 Devils Lane
    CB11 4BB Saffron Walden
    Essex
    British1890700002
    PRESLAND, Peter Eric
    Rats Castle
    Castletons Oak Cranbrook Road
    TN27 8DY Biddenden Ashford
    Kent
    Director
    Rats Castle
    Castletons Oak Cranbrook Road
    TN27 8DY Biddenden Ashford
    Kent
    EnglandBritish7649630002
    ROWE, Nicholas
    Amberly House
    The Cleave
    OX11 0EL Harwell
    Oxfordshire
    Director
    Amberly House
    The Cleave
    OX11 0EL Harwell
    Oxfordshire
    British33862660001
    SANSOM, Richard James
    12 Birch Mead
    Locksbottom
    BR6 8LT Orpington
    Kent
    Director
    12 Birch Mead
    Locksbottom
    BR6 8LT Orpington
    Kent
    United KingdomBritish105966060001
    SPORBORG, Christopher Henry
    Brooms Farm
    Upwick Green Albury
    SG11 2JX Ware
    Hertfordshire
    Director
    Brooms Farm
    Upwick Green Albury
    SG11 2JX Ware
    Hertfordshire
    United KingdomBritish33747850002
    STEWART, Callum John Tyndale
    18 Hereford Square
    SW7 4TS London
    Director
    18 Hereford Square
    SW7 4TS London
    British5291230007
    TOOKEY, Timothy James William
    28 Brabourne Rise
    BR3 6SG Beckenham
    Kent
    Director
    28 Brabourne Rise
    BR3 6SG Beckenham
    Kent
    British57236570002
    WILLIAMS, Raymond Reginald
    4 Burran Avenue
    Mosman
    New South Wales
    Australia
    Director
    4 Burran Avenue
    Mosman
    New South Wales
    Australia
    Australian28558670001

    ¿Tiene NAMESHELL 2 LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Guarantee & debenture
    Creado el 17 dic 2003
    Entregado el 23 dic 2003
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to any of the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC as Security Trustee for the Secured Parties
    Transacciones
    • 23 dic 2003Registro de un cargo (395)
    Guarantee & debenture
    Creado el 29 feb 2000
    Entregado el 09 mar 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to any of the secured parties (as defined) pursuant to all or any of the secured documents (as defined), including the debenture
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 09 mar 2000Registro de un cargo (395)
    • 09 ene 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 16TH march 1998 and
    Creado el 29 ene 1998
    Entregado el 26 mar 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the senior finance documents
    Breve descripción
    All and whole that piece of ground along the north side of the road or street called carden place in the city parish of aberdeen and county of aberdeen.. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland(As Agent and Trustee)
    Transacciones
    • 26 mar 1998Registro de un cargo (395)
    • 05 may 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Third guarantee and debenture
    Creado el 31 dic 1997
    Entregado el 14 ene 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the senior finance documents and the debenture as defined therein
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Trustee for the Beneficiaries
    Transacciones
    • 14 ene 1998Registro de un cargo (395)
    • 05 may 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Second guarantee and debenture
    Creado el 03 dic 1997
    Entregado el 22 dic 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the senior finance documents and the debenture as defined therein
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Security Trustee for the Beneficiaries
    Transacciones
    • 22 dic 1997Registro de un cargo (395)
    • 28 feb 1998Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 05 may 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Assignment
    Creado el 13 sept 1991
    Entregado el 18 sept 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease dated 7/4/88
    Breve descripción
    All that 5TH floor goodbard house infirmary street leeds.
    Personas con derecho
    • Dunn & Wilson Limited
    Transacciones
    • 18 sept 1991Registro de una carga
    • 08 ago 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene NAMESHELL 2 LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    24 may 2011Fecha de disolución
    12 dic 2006Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Philip John Gorman
    Hazlewoods
    Windsor House
    Barnett Way
    Barnwood Gloucester
    Profesional
    Hazlewoods
    Windsor House
    Barnett Way
    Barnwood Gloucester

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0