SUTER ESTATES LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSUTER ESTATES LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00107150
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de SUTER ESTATES LIMITED?

    • (7020) /

    ¿Dónde se encuentra SUTER ESTATES LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Olympia House
    Armitage Road
    NW11 8RQ London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SUTER ESTATES LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    HERMETIC SECURITIES LIMITED26 ene 191026 ene 1910

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de SUTER ESTATES LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2011

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para SUTER ESTATES LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    2 páginas4.71

    Domicilio social registrado cambiado de Nations House 103 Wigmore Street London W1U 1AE el 08 mar 2012

    2 páginasAD01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 28 feb 2012

    LRESSP

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Cese del nombramiento de Vinod Bachulal Vaghela como director el 21 dic 2011

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2011

    10 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 03 may 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital03 may 2011

    Estado de capital el 03 may 2011

    • Capital: GBP 100,000
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2010

    11 páginasAA

    Cese del nombramiento de Philip Warner como director

    1 páginasTM01

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    Déclaration annuelle établie au 03 may 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2009

    11 páginasAA

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    4 páginas363a

    legacy

    1 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2008

    13 páginasAA

    legacy

    4 páginas363a

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2007

    15 páginasAA

    legacy

    3 páginas363a

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2006

    17 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de SUTER ESTATES LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    LANCHESTER, David James
    1 Holly Close
    IG9 6HT Buckhurst Hill
    Essex
    Secretario
    1 Holly Close
    IG9 6HT Buckhurst Hill
    Essex
    British7014460002
    GAME, Robert William
    Newbury Lane
    Cousley Wood
    TN5 6HD Wadhurst
    Rosemary Cottage
    East Sussex
    Director
    Newbury Lane
    Cousley Wood
    TN5 6HD Wadhurst
    Rosemary Cottage
    East Sussex
    United KingdomEnglish139555050001
    KEOGH, Mark William
    Norfolk House 28 Kidmore Road
    Caversham
    RG4 7LU Reading
    Director
    Norfolk House 28 Kidmore Road
    Caversham
    RG4 7LU Reading
    EnglandIrish62140690001
    BLYTHE-TINKER, Nigel Edwin
    Top Farm
    High Street
    PE19 6RX Toseland
    Cambs
    Secretario
    Top Farm
    High Street
    PE19 6RX Toseland
    Cambs
    British63851130001
    FOLGER, Susan
    12 Court Lane Gardens
    Dulwich
    SE21 7DZ London
    Secretario
    12 Court Lane Gardens
    Dulwich
    SE21 7DZ London
    British36525980001
    HENSON, Mark Richard
    5 Hazeland Steading
    PE10 0PW Morton
    Lincolnshire
    Secretario
    5 Hazeland Steading
    PE10 0PW Morton
    Lincolnshire
    British104630800001
    LOWES, Richard Phillip
    2 Westcott Keep
    RH6 9US Horley
    Surrey
    Secretario
    2 Westcott Keep
    RH6 9US Horley
    Surrey
    British5785520001
    PATON WALSH, Antony Edmund
    60 Mount Ararat Road
    TW10 6PJ Richmond
    Surrey
    Secretario
    60 Mount Ararat Road
    TW10 6PJ Richmond
    Surrey
    British43425770001
    WILLIAMS, John Benedict Alan
    16 Oakwood Road
    Golders Green
    NW11 6QY London
    Secretario
    16 Oakwood Road
    Golders Green
    NW11 6QY London
    British79419360001
    ASCOT CORPORATE SECRETARIES LIMITED
    2 Heathrow Boulevard
    284 Bath Road
    UB7 0DQ West Drayton
    Middlesex
    Secretario corporativo
    2 Heathrow Boulevard
    284 Bath Road
    UB7 0DQ West Drayton
    Middlesex
    69324550001
    ABELL, John David
    The Old Rectory Main Street
    Branston By Belvoir
    NG32 1RU Grantham
    Lincolnshire
    Director
    The Old Rectory Main Street
    Branston By Belvoir
    NG32 1RU Grantham
    Lincolnshire
    United KingdomBritish71975220001
    COLLINS, Peter William
    The Oaks
    23 Croft Road
    RG40 3HX Wokingham
    Berkshire
    Director
    The Oaks
    23 Croft Road
    RG40 3HX Wokingham
    Berkshire
    United KingdomBritish26086560001
    EDWARDS, John Nigel
    8b Avery Row
    Mayfair
    W1K 4AL London
    Director
    8b Avery Row
    Mayfair
    W1K 4AL London
    United KingdomBritish37742270003
    EDWARDS, John Nigel
    976b Garratt Lane
    SW17 0ND London
    Director
    976b Garratt Lane
    SW17 0ND London
    British37742270001
    FERGUSON, Daniel
    33 The Avenue
    EN6 1EG Potters Bar
    Hertfordshire
    Director
    33 The Avenue
    EN6 1EG Potters Bar
    Hertfordshire
    United KingdomBritish29071630001
    FIRTH, Arthur Gregory
    Westridge House
    Belvoir Close
    Colsterworth
    Lincolnshire
    Director
    Westridge House
    Belvoir Close
    Colsterworth
    Lincolnshire
    British17118450001
    FOLGER, Susan
    12 Court Lane Gardens
    Dulwich
    SE21 7DZ London
    Director
    12 Court Lane Gardens
    Dulwich
    SE21 7DZ London
    British36525980001
    GRANT, John Albert Martin
    The Malthouse Manor Lane
    Claverdon
    CV35 8NH Warwick
    Warwickshire
    Director
    The Malthouse Manor Lane
    Claverdon
    CV35 8NH Warwick
    Warwickshire
    EnglandBritish55161940001
    HEATHWOOD, Derek Kevin
    47 Fullarton Crescent
    KA10 6LL Troon
    South Ayrshire
    Director
    47 Fullarton Crescent
    KA10 6LL Troon
    South Ayrshire
    British85468580002
    HEWITT, Alan
    The White House Casthorpe Road
    Barrowby
    NG32 1DW Grantham
    Lincolnshire
    Director
    The White House Casthorpe Road
    Barrowby
    NG32 1DW Grantham
    Lincolnshire
    British572100002
    HOARE, Brian David
    The Old Barn 32 High Street
    LE14 4AH Waltham On The Wolds
    Leicestershire
    Director
    The Old Barn 32 High Street
    LE14 4AH Waltham On The Wolds
    Leicestershire
    British28340230001
    JONES, Morgan Lewis
    4 Camden Close
    BR7 5PH Chislehurst
    Kent
    Director
    4 Camden Close
    BR7 5PH Chislehurst
    Kent
    EnglandBritish10146340003
    MEADE, Karl Robert
    Holly Mount
    Penn Road
    HP9 2TS Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Director
    Holly Mount
    Penn Road
    HP9 2TS Beaconsfield
    Buckinghamshire
    EnglandBritish118074370001
    MOORE, Richard
    88 Alzey Gardens
    AL5 5SZ Harpenden
    Hertfordshire
    Director
    88 Alzey Gardens
    AL5 5SZ Harpenden
    Hertfordshire
    British73793650001
    REYNOLDS, Malcolm Stanley
    74 Scatterdells Lane
    Chipperfield
    WD4 9EX Kings Langley
    Hertfordshire
    Director
    74 Scatterdells Lane
    Chipperfield
    WD4 9EX Kings Langley
    Hertfordshire
    British10865710001
    RIDER, Stuart Granville
    3 Kesteven Court
    North Parade
    NG31 8FP Grantham
    Lincolnshire
    Director
    3 Kesteven Court
    North Parade
    NG31 8FP Grantham
    Lincolnshire
    British36675890002
    RILEY, Michael James
    16 Ladbroke Road
    W11 3NJ London
    Director
    16 Ladbroke Road
    W11 3NJ London
    British3055390001
    STEVENS, Michael John
    32 Woodfield Park
    HP6 5QH Amersham
    Buckinghamshire
    Director
    32 Woodfield Park
    HP6 5QH Amersham
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish60348780002
    VAGHELA, Vinod Bachulal
    99 Cathles Road
    Balham
    SW12 9LF London
    Director
    99 Cathles Road
    Balham
    SW12 9LF London
    EnglandBritish5689250001
    VINCENT, Michael
    23 Saint Aubyns's Avenue
    SW19 7BL London
    Director
    23 Saint Aubyns's Avenue
    SW19 7BL London
    EnglandBritish99258270001
    WARNER, Philip Courtenay Thomas, Sir
    Marden Grange
    Marden
    SN10 3RQ Devizes
    Wiltshire
    Director
    Marden Grange
    Marden
    SN10 3RQ Devizes
    Wiltshire
    United KingdomBritish7356840001
    WATSON, Ian Richard
    Old Dove House
    Annables Lane
    AL5 3PR Harpenden
    Hertfordshire
    Director
    Old Dove House
    Annables Lane
    AL5 3PR Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish68256540001
    WILLIAMS, John Benedict Alan
    16 Oakwood Road
    Golders Green
    NW11 6QY London
    Director
    16 Oakwood Road
    Golders Green
    NW11 6QY London
    British79419360001
    ASCOT CORPORATE DIRECTORS LIMIYED
    2 Heathrow Boulevard
    284 Bath Road
    UB7 0DQ West Drayton
    Middlesex
    Director corporativo
    2 Heathrow Boulevard
    284 Bath Road
    UB7 0DQ West Drayton
    Middlesex
    67372750003

    ¿Tiene SUTER ESTATES LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Security agreement
    Creado el 22 jul 2005
    Entregado el 04 ago 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC (The "Agent") as Agent and Trustee for the Finance Parties
    Transacciones
    • 04 ago 2005Registro de un cargo (395)
    • 01 jul 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Mezzanine security agreement
    Creado el 22 jul 2005
    Entregado el 01 ago 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each mezzanine obligor to the lender on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of fixed charge all estates or interest in any f/h or l/h property now or subsequently owned by it, by way of fixed charge its interests in all investments now or subsequently held by it. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Warner Estate, Limited
    Transacciones
    • 01 ago 2005Registro de un cargo (395)
    • 01 jul 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Deed of debenture
    Creado el 16 jul 2003
    Entregado el 21 jul 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    F/H property 2/22 yorkshire street, burnley t/n LA809118. F/h property the new inn roundabout, pontypool t/n WA583381, f/h property 15 fir tree road hastings t/n HT18815.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 21 jul 2003Registro de un cargo (395)
    • 05 ago 2004Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 19 jul 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 29 dic 1998
    Entregado el 07 ene 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the finance documents (as defined)
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC,as Trustee for the Beneficiaries (As Defined)
    Transacciones
    • 07 ene 1999Registro de un cargo (395)
    • 08 abr 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of admission
    Creado el 23 mar 1995
    Entregado el 10 abr 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 10 abr 1995Registro de un cargo (395)
    Omnibus debenture
    Creado el 25 may 1994
    Entregado el 01 jun 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 01 jun 1994Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 25 feb 1982
    Entregado el 05 mar 1982
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floaitng charges over undertaking and all property including property listed in schedule attached to doc M139 and assets present and future inlcuding uncalled capital with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 05 mar 1982Registro de una carga
    • 25 jun 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Letter of set-off
    Creado el 21 may 1981
    Entregado el 28 may 1981
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with lloyds bank limited.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 28 may 1981Registro de una carga
    Special omnibus letter of set off
    Creado el 30 jun 1980
    Entregado el 08 jul 1980
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sum of sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with lloyds bank limited.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 08 jul 1980Registro de una carga
    Special omnibus letter of set off
    Creado el 01 ene 1979
    Entregado el 08 ene 1979
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with lloyds bank limited.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 08 ene 1979Registro de una carga
    • 24 may 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene SUTER ESTATES LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    09 nov 2012Fecha de disolución
    28 feb 2012Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Stephen Gordon Franklin
    Panos Eliades Franklin & Co Olympia House
    Armitage Road
    NW11 8RQ London
    Profesional
    Panos Eliades Franklin & Co Olympia House
    Armitage Road
    NW11 8RQ London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0