MARSH MCLENNAN INDIA HOLDINGS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | MARSH MCLENNAN INDIA HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 00115332 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de MARSH MCLENNAN INDIA HOLDINGS LIMITED?
- Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo
¿Dónde se encuentra MARSH MCLENNAN INDIA HOLDINGS LIMITED?
| Dirección de la sede social | 1 Tower Place West Tower Place EC3R 5BU London United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de MARSH MCLENNAN INDIA HOLDINGS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| JLT EB HOLDINGS LIMITED | 04 ene 2011 | 04 ene 2011 |
| JARDINE LLOYD THOMPSON UK HOLDINGS LIMITED | 02 jul 2007 | 02 jul 2007 |
| JARDINE LLOYD THOMPSON UK LIMITED | 02 oct 2000 | 02 oct 2000 |
| JIB (1995) LIMITED | 29 dic 1995 | 29 dic 1995 |
| JARDINE INSURANCE BROKERS LIMITED | 03 nov 1986 | 03 nov 1986 |
| JARDINE GLANVILL (U.K.) LIMITED | 31 dic 1981 | 31 dic 1981 |
| JARDINE MATHESON INSURANCE BROKERS (U.K.) LIMITED | 31 dic 1978 | 31 dic 1978 |
| PICKFORD DAWSON & HOLLAND LIMITED | 18 abr 1911 | 18 abr 1911 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de MARSH MCLENNAN INDIA HOLDINGS LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para MARSH MCLENNAN INDIA HOLDINGS LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 15 feb 2027 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 01 mar 2027 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 15 feb 2026 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para MARSH MCLENNAN INDIA HOLDINGS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaración de confirmación presentada el 15 feb 2026 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2024 | 25 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Teresa Dawn Beach como director el 10 jul 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 15 feb 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2023 | 24 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 15 feb 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2022 | 23 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Balamurugan Viswanathan como director el 21 ago 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 31 mar 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Certificado de cambio de nombre Company name changed jlt eb holdings LIMITED\certificate issued on 14/11/22 | 3 páginas | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Cambio de datos del director Mr Balamurugan Viswanathan el 11 abr 2022 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2021 | 29 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 31 mar 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Balamurugan Viswanathan el 09 dic 2021 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Ms Teresa Dawn Beach el 15 feb 2022 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Tony O'dwyer el 15 sept 2021 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Thomas Mcdonald el 15 sept 2021 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Nombramiento de Ms Teresa Dawn Beach como director el 15 feb 2022 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Balamurugan Viswanathan como director el 09 dic 2021 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de The St Botolph Building 138 Houndsditch London EC3A 7AW a 1 Tower Place West Tower Place London EC3R 5BU el 15 sept 2021 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2020 | 32 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 31 mar 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Thomas Mcdonald el 21 dic 2020 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Connie Maccurrach como secretario el 30 nov 2020 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2019 | 32 páginas | AA | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de MARSH MCLENNAN INDIA HOLDINGS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCDONALD, Thomas | Director | Tower Place West Tower Place EC3R 5BU London 1 United Kingdom | England | British | 246169610002 | |||||||||
| O'DWYER, Tony | Director | Tower Place West Tower Place EC3R 5BU London 1 United Kingdom | United Kingdom | Irish | 244880160001 | |||||||||
| HICKMAN, David James | Secretario | 4b Sunningvale Avenue Biggin Hill TN16 3BT Westerham Kent | British | 6838480001 | ||||||||||
| JOHNSON, Stephanie | Secretario | 138 Houndsditch EC3A 7AW London The St Botolph Building England | British | 52711730001 | ||||||||||
| MACCURRACH, Connie | Secretario | Tower Place West Tower Place EC3R 5BU London 1 United Kingdom | 272748820001 | |||||||||||
| JARDINE INSURANCE SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | Jardine House 6 Crutched Friars EC3N 2HT London | 32432400001 | |||||||||||
| JLT SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | 138 Houndsditch EC3A 7AW London The St Botolph Building England |
| 198995020001 | ||||||||||
| BEACH, Teresa Dawn | Director | Tower Place West Tower Place EC3R 5BU London 1 United Kingdom | England | British | 177591260001 | |||||||||
| BEACH, Teresa Dawn | Director | 138 Houndsditch EC3A 7AW London The St Botolph Building England | England | British | 177591260001 | |||||||||
| BLOOMER, Jonathan William | Director | 138 Houndsditch EC3A 7AW London The St Botolph Building England | England | British | 115487540001 | |||||||||
| BROWN, Michael Terence | Director | The Lake House Cuttinglye Road RH10 4LR Crawley Down West Sussex | United Kingdom | British | 182187500001 | |||||||||
| BURKE, Dominic James | Director | Park Wood Farm GL8 8UO Leighterton Gloucestershire | British | 5824140003 | ||||||||||
| CLUTTERBUCK, Troy Adam | Director | 138 Houndsditch EC3A 7AW London The St Botolph Building England | United Kingdom | British | 150992120001 | |||||||||
| COLLINS, Andrew Dominic John Bucke | Director | Adlestrop GL56 0YN Moreton In Marsh Adlestrop Park Gloucestershire | United Kingdom | British | 139705290001 | |||||||||
| COUGHLAN, Ian David | Director | Crutched Friars EC3N 2PH London 6 England | England | British | 127908060001 | |||||||||
| COWLEY, David John | Director | Lower Wield House Lower Wield SO24 9RX Alresford Hampshire | British | 37963150001 | ||||||||||
| CURTIS, Simon | Director | Park Farmhouse Vicarage Lane Little Budworth CW6 9BP Tarporley Cheshire | British | 7624740003 | ||||||||||
| DAWSON, Paul Anthony | Director | Barrow Hill Cottage Old Malden Lane KT4 7PU Worcester Park Surrey | British | 6890430001 | ||||||||||
| FLANAGAN, Eamonn Michael | Director | 138 Houndsditch EC3A 7AW London The St Botolph Building England | United Kingdom | British | 247874040001 | |||||||||
| GALE, Patrick Nigel Christopher | Director | 138 Houndsditch EC3A 7AW London The St Botolph Building England | England | British | 149359970001 | |||||||||
| GIRLING, Adrian Brian | Director | 113 Andover Road SO22 6AX Winchester Hampshire | England | British | 44761310001 | |||||||||
| GOODINGS, Phillip Eric | Director | Crutched Friars EC3N 2PH London 6 England | England | British | 5542210002 | |||||||||
| GRIBBIN, Michael Christopher David | Director | Higher Ash Farm Ash TQ6 0LR Dartmouth Devon | United Kingdom | British | 6866190001 | |||||||||
| HARRIDINE, Martin Alfred | Director | 87 Egmont Road SM2 5JS Sutton Surrey | British | 53734440001 | ||||||||||
| HASTINGS BASS, John Peter | Director | Ashmansworth Manor Ashmansworth RG20 9SG Newbury Berkshire | British | 69550720001 | ||||||||||
| HOWORTH, Duncan Craig | Director | 138 Houndsditch EC3A 7AW London The St Botolph Building England | England | English | 34586390006 | |||||||||
| HOWORTH, Duncan Craig | Director | Little Bonchurch Arbrook Lane KT10 9EG Esher Surrey | England | British | 34586390005 | |||||||||
| JONES, David Lyndon | Director | 138 Houndsditch EC3A 7AW London The St Botolph Building | United Kingdom | British | 106668010004 | |||||||||
| JONES, David Lyndon | Director | Southfield House 58 Ledborough Lane HP9 2DF Beaconsfield Buckinghamshire | United Kingdom | British | 106668010001 | |||||||||
| JONES, Mark David | Director | 138 Houndsditch EC3A 7AW London The St Botolph Building England | United Kingdom | British | 131997610002 | |||||||||
| LEE, Nicholas John | Director | 31 St Clairs Road St Osyth CO16 8QQ Clacton On Sea Essex | England | British | 247726070001 | |||||||||
| LOVE, Samuel Andrew James | Director | Fairfields 109 Coxtie Green Road Pilgrims Hatch CM14 5PS Brentwood Essex | British | 23800480002 | ||||||||||
| NABARRO, William John Nunes | Director | Bishopton Grange HG4 2QL Ripon North Yorkshire | United Kingdom | British | 61240120001 | |||||||||
| OHANLON, Joseph Finbar | Director | 15 The Elms Mount Merrion Avenue Blackrock IRISH Dublin 4 County Dublin Ireland | Irish | 25922480002 | ||||||||||
| PAINE, Charles Michael Loder | Director | Basement Flat 21 Cornwall Gardens SW7 4AW London | England | British | 65383450001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de MARSH MCLENNAN INDIA HOLDINGS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mmc Uk Group Limited | 02 dic 2019 | Tower Place West Tower Place EC3R 5BU London 1 United Kingdom | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Mmc Holdings (Uk) Limited | 02 dic 2019 | Tower Place West Tower Place EC3R 5BU London 1 United Kingdom | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Mmc Treasury Holdings (Uk) Limited | 02 dic 2019 | Tower Place West Tower Place EC3R 5BU London 1 United Kingdom | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Marsh & Mclennan Companies Uk Limited | 02 dic 2019 | Tower Place West Tower Place EC3R 5BU London 1 United Kingdom | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Mmc International Limited | 02 dic 2019 | Tower Place West Tower Place EC3R 5BU London 1 United Kingdom | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Mercer Limited | 02 dic 2019 | Tower Place West Tower Place EC3R 5BU London 1 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Jlt Uk Investment Holdings Limited | 20 jul 2016 | 138 Houndsditch EC3A 7AW London The St Botolph Building England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0