CENTER BRAND LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | CENTER BRAND LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 00117003 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de CENTER BRAND LIMITED?
- (9999) /
¿Dónde se encuentra CENTER BRAND LIMITED?
| Dirección de la sede social | Parkview 1220 Arlington Business Park RG7 4GA Theale Reading |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CENTER BRAND LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| F.W. MCCONNEL (SALES) LIMITED | 31 dic 1980 | 31 dic 1980 |
| WEBB LAWNMOWERS LIMITED | 26 jul 1911 | 26 jul 1911 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de CENTER BRAND LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 jul 2009 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para CENTER BRAND LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 06 nov 2010 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Estado de capital el 08 sept 2010
| 4 páginas | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 3 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cese del nombramiento de Stephen Webster como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Robert Andrew Ross Smith como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 06 nov 2009 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||||||
Cambio de datos del director Stephen Paul Webster el 01 oct 2009 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Cambio de datos del secretario Alison Drew el 01 oct 2009 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||||||
Cuentas preparadas hasta el 31 jul 2009 | 5 páginas | AA | ||||||||||||||
Cuentas preparadas hasta el 31 jul 2008 | 5 páginas | AA | ||||||||||||||
legacy | 3 páginas | 363a | ||||||||||||||
legacy | 2 páginas | 363a | ||||||||||||||
Cuentas preparadas hasta el 31 jul 2007 | 5 páginas | AA | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | 288b | ||||||||||||||
legacy | 2 páginas | 288a | ||||||||||||||
legacy | 2 páginas | 363a | ||||||||||||||
Cuentas preparadas hasta el 31 jul 2006 | 6 páginas | AA | ||||||||||||||
legacy | 2 páginas | 363a | ||||||||||||||
Cuentas preparadas hasta el 31 jul 2005 | 6 páginas | AA | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | 288c | ||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de CENTER BRAND LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DREW, Alison | Secretario | Parkview 1220 Arlington Business Park RG7 4GA Theale Reading | British | 86845230002 | ||||||
| SMITH, Robert Andrew Ross | Director | Arlington Business Park Theale RG7 4GA Reading Parkview 1220 United Kingdom | United Kingdom | British | 150753930001 | |||||
| WOLSELEY DIRECTORS LIMITED | Director corporativo | Parkview 1220 Arlington Business Park, Theale RG7 4GA Reading | 122185200001 | |||||||
| BRANSON, David Anthony | Secretario | 32 Chestnut Drive Shenstone WS14 0JH Lichfield Staffordshire | British | 272310001 | ||||||
| BRANSON, David Anthony | Secretario | 32 Chestnut Drive Shenstone WS14 0JH Lichfield Staffordshire | British | 272310001 | ||||||
| BUSHNELL, Adrian John | Secretario | 138 Goddard Way CB10 2ED Saffron Walden Essex | British | 43046230002 | ||||||
| PARKER, Edward Geoffrey | Secretario | The Homestead 133 Malvern Road WR2 4LN Worcester | British | 37378570013 | ||||||
| WHITE, Mark Jonathan | Secretario | 38 Grange Close Church Road Nascot Wood WD17 4HQ Watford Hertfordshire | British | 82978250001 | ||||||
| BRANSON, David Anthony | Director | 32 Chestnut Drive Shenstone WS14 0JH Lichfield Staffordshire | British | 272310001 | ||||||
| BURTON, Ian Michael | Director | Five Oaks Green Meadows Homme Green HR9 7RE Ross On Wye Herefordshire | British | 31859330002 | ||||||
| BUSHNELL, Adrian John | Director | 138 Goddard Way CB10 2ED Saffron Walden Essex | British | 43046230002 | ||||||
| IRELAND, Richard | Director | 10 Catherine Drive B73 6AX Sutton Coldfield West Midlands | British | 272320001 | ||||||
| PARKER, Edward Geoffrey | Director | The Homestead 133 Malvern Road WR2 4LN Worcester | British | 37378570013 | ||||||
| POWELL, William Tudor | Director | Foye House Cliffords Mesne GL18 1JN Newent Gloucestershire | United Kingdom | British | 27960510001 | |||||
| WEBSTER, Stephen Paul | Director | Parkview 1220 Arlington Business Park RG7 4GA Theale Reading | United Kingdom | British | 40201730005 | |||||
| WHITE, Mark Jonathan | Director | Hawthorn House 2 Wards Drive, Sarratt WD3 6AE Rickmansworth Herts | England | British | 82978250002 |
¿Tiene CENTER BRAND LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Trust deed | Creado el 16 feb 1970 Entregado el 24 feb 1970 | Pendiente | Cantidad garantizada For securing debenture stock of wolseley-hughes limited amounting to sterling pounds 1,000,000 | |
Breve descripción First floating charge on the (see doc.111 For details). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Trust deed | Creado el 08 feb 1966 Entregado el 24 feb 1966 | Pendiente | Cantidad garantizada For securing debenture stock of wolseley-hughes limited amounting to sterling pounds 1,250,000 | |
Breve descripción First floating charge on the (see doc.102 For details). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Equitable charge without instrument | Creado el 10 dic 1965 Entregado el 29 dic 1965 | Pendiente | Cantidad garantizada For securing debenture stock of wolseley-hughes limited amounting to sterling pounds 1,250,000 | |
Breve descripción First floating charge on the undertaking & assets present & future (including any uncalled capital) of the company. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0