00118632 LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresa00118632 LIMITED
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00118632
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de 00118632 LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra 00118632 LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Yew Trees, Main Street North
    Aberford
    LS25 3AA West Yorkshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de 00118632 LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    BODDIS (OLD HILL) LIMITED17 nov 191117 nov 1911

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de 00118632 LIMITED?

    Vencido
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el30 sept 2012
    Próximas cuentas vencen el30 jun 2013
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 sept 2011

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para 00118632 LIMITED?

    Vencido
    Última declaración de confirmación cerrada hasta01 oct 2016
    Próxima declaración de confirmación vence15 oct 2016
    Vencido

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para 00118632 LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual
    Vencido

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para 00118632 LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Nombramiento de Mr Sean Christopher Wyndham-Quin como director el 15 dic 2017

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de John William Young Strachan Samuel como director el 17 dic 2017

    1 páginasTM01

    Restauración por orden judicial

    3 páginasAC92

    Certificado de cambio de nombre

    Company name changed bb engineering\certificate issued on 13/07/16
    páginasCERTNM

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Resoluciones

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Delete share cap restrictions 31/05/2013
    RES13
    capital

    Resolución de eliminación de derechos de suscripción preferente

    RES11
    capital

    Resolución de asignación de valores

    RES10

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 31 may 2013

    • Capital: GBP 3,688,749
    5 páginasSH01

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    Déclaration annuelle établie au 01 oct 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2011

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 oct 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2010

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 oct 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Nombramiento de John William Young Strachan Samuel como director

    3 páginasAP01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2009

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 01 oct 2009 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada

    2 páginasAD03

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado

    2 páginasAD02

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2008

    5 páginasAA

    legacy

    3 páginas363a

    legacy

    1 páginas353

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2007

    10 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de 00118632 LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    RENEW NOMINEES LIMITED
    Yew Trees
    Main Street North
    LS25 3AA Aberford
    West Yorkshire
    Secretario corporativo
    Yew Trees
    Main Street North
    LS25 3AA Aberford
    West Yorkshire
    41291250014
    WYNDHAM-QUIN, Sean Christopher
    Yew Trees, Main Street North
    Aberford
    LS25 3AA West Yorkshire
    Director
    Yew Trees, Main Street North
    Aberford
    LS25 3AA West Yorkshire
    EnglandBritish166903410002
    RENEW CORPORATE DIRECTOR LIMITED
    Yew Trees
    Main Street North
    LS25 3AA Aberford
    West Yorkshire
    Director corporativo
    Yew Trees
    Main Street North
    LS25 3AA Aberford
    West Yorkshire
    91993060004
    BARKER, James Alan
    20 Crabtree Park
    GL7 4LT Fairford
    Gloucestershire
    Secretario
    20 Crabtree Park
    GL7 4LT Fairford
    Gloucestershire
    British31113100001
    COOPER, David Lawrence
    29 Mercot Close
    Oakenshaw South
    B98 7YX Redditch
    Worcestershire
    Secretario
    29 Mercot Close
    Oakenshaw South
    B98 7YX Redditch
    Worcestershire
    British29904260001
    DARLINGTON, Stephen Jeffrey
    Ty Gwyn Mentone Avenue
    Aspley Guise
    MK17 8EQ Milton Keynes
    Bedfordshire
    Secretario
    Ty Gwyn Mentone Avenue
    Aspley Guise
    MK17 8EQ Milton Keynes
    Bedfordshire
    British43547190001
    HEWINS, Percy
    19 Lion Street
    DY8 1UE Stourbridge
    West Midlands
    Secretario
    19 Lion Street
    DY8 1UE Stourbridge
    West Midlands
    British4262210001
    ROGERS, Kevin Alan
    New Homage Cottage
    31 Brewood Road Coven
    WV9 5BY Wolverhampton
    Staffordshire
    Secretario
    New Homage Cottage
    31 Brewood Road Coven
    WV9 5BY Wolverhampton
    Staffordshire
    British39430340001
    SHAKESPEARE, Ann
    56 Ingatestone Drive
    Wordsley
    DY8 5PT Stourbridge
    West Midlands
    Secretario
    56 Ingatestone Drive
    Wordsley
    DY8 5PT Stourbridge
    West Midlands
    British21552870002
    WARD, Elizabeth Anne
    23 Chapel Road
    Earith
    PE17 3PU Huntingdon
    Cambridgeshire
    Secretario
    23 Chapel Road
    Earith
    PE17 3PU Huntingdon
    Cambridgeshire
    British32157210001
    BARKER, James Alan
    20 Crabtree Park
    GL7 4LT Fairford
    Gloucestershire
    Director
    20 Crabtree Park
    GL7 4LT Fairford
    Gloucestershire
    British31113100001
    BARRETT, Barrie Michael
    The Firs
    Spetchley Road
    WR5 2NL Worcester
    Worcestershire
    Director
    The Firs
    Spetchley Road
    WR5 2NL Worcester
    Worcestershire
    British4061200002
    BLACKBURN, Peter Edward
    20 Church Lane
    Downend
    BS16 6TB Bristol
    Avon
    Director
    20 Church Lane
    Downend
    BS16 6TB Bristol
    Avon
    British5531260001
    BREALEY, Graham Michael
    17 The Paddock
    Eaton Ford St Neots
    PE19 3SA Huntingdon
    Cambridgeshire
    Director
    17 The Paddock
    Eaton Ford St Neots
    PE19 3SA Huntingdon
    Cambridgeshire
    EnglandBritish61631390001
    COOPER, David Lawrence
    29 Mercot Close
    Oakenshaw South
    B98 7YX Redditch
    Worcestershire
    Director
    29 Mercot Close
    Oakenshaw South
    B98 7YX Redditch
    Worcestershire
    British29904260001
    DARLINGTON, Stephen Jeffrey
    Ty Gwyn Mentone Avenue
    Aspley Guise
    MK17 8EQ Milton Keynes
    Bedfordshire
    Director
    Ty Gwyn Mentone Avenue
    Aspley Guise
    MK17 8EQ Milton Keynes
    Bedfordshire
    British43547190001
    ERRINGTON, David John
    Foxstone House
    Fieldways
    GL6 0DY Nailsworth
    Gloucestershire
    Director
    Foxstone House
    Fieldways
    GL6 0DY Nailsworth
    Gloucestershire
    British83154330001
    HEWINS, Percy
    19 Lion Street
    DY8 1UE Stourbridge
    West Midlands
    Director
    19 Lion Street
    DY8 1UE Stourbridge
    West Midlands
    British4262210001
    HEWLETT, David
    Roseland 22 Aylsham Road
    NR11 6TE Tuttington
    Norfolk
    Director
    Roseland 22 Aylsham Road
    NR11 6TE Tuttington
    Norfolk
    EnglandBritish87102720001
    JOHNSON, Ronald James
    12 Summer Road
    Rowley Regis
    B65 9QQ Warley
    West Midlands
    Director
    12 Summer Road
    Rowley Regis
    B65 9QQ Warley
    West Midlands
    British21552860001
    MCARTHUR, Alexander Nigel
    39 Cornhill
    EC3V 3NU London
    Director
    39 Cornhill
    EC3V 3NU London
    British1571200002
    NELMES CROCKER, Michael
    Chartleys
    Box
    GL6 9HR Minchinhampton Stroud
    Gloucestershire
    Director
    Chartleys
    Box
    GL6 9HR Minchinhampton Stroud
    Gloucestershire
    British1729130003
    ROGERS, Kevin Alan
    New Homage Cottage
    31 Brewood Road Coven
    WV9 5BY Wolverhampton
    Staffordshire
    Director
    New Homage Cottage
    31 Brewood Road Coven
    WV9 5BY Wolverhampton
    Staffordshire
    British39430340001
    SAMUEL, John William Young Strachan
    Main Street North
    Aberford
    LS25 3AA Leeds
    Yew Trees
    Director
    Main Street North
    Aberford
    LS25 3AA Leeds
    Yew Trees
    EnglandBritish3909060002
    SELLARS, Paul
    White House
    Withyham
    TN7 4BT Hartfield
    East Sussex
    Director
    White House
    Withyham
    TN7 4BT Hartfield
    East Sussex
    EnglandBritish50761250001
    SHAKESPEARE, Ann
    56 Ingatestone Drive
    Wordsley
    DY8 5PT Stourbridge
    West Midlands
    Director
    56 Ingatestone Drive
    Wordsley
    DY8 5PT Stourbridge
    West Midlands
    British21552870002
    TROMANS, James
    14 Moat Road
    B68 8EB Oldbury
    West Midlands
    Director
    14 Moat Road
    B68 8EB Oldbury
    West Midlands
    British59715450001
    TWELLS, Paul Stephen
    158 Ingram Road
    NG6 9GQ Bulwell
    Nottingham
    Director
    158 Ingram Road
    NG6 9GQ Bulwell
    Nottingham
    British51937070001
    MONTPELLIER GROUP NOMINEES LIMITED
    39 Cornhill
    EC3V 3NU London
    Director corporativo
    39 Cornhill
    EC3V 3NU London
    41291250009

    ¿Tiene 00118632 LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 15 ago 1997
    Entregado el 02 sept 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    By way of legal mortgage l/h blenhiem industrial estate bennerley road bulwell nottinghamshire t/n-NT133280. F/h land on the south east side of great bath road padworth berkshire t/n-BK22551. F/h 63 and 65 london road sandy bedfordshire SG19 1DJ t/n-BD171704. (For other properties charged see form 395). by way of fixed charge all plant and machinery; goodwill and uncalled capital; all book and other debts; by way of floating charge all assets.. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 02 sept 1997Registro de un cargo (395)
    • 02 mar 2013Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Mortgage debenture
    Creado el 15 nov 1995
    Entregado el 21 nov 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 21 nov 1995Registro de un cargo (395)
    • 02 mar 2013Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Legal mortgage
    Creado el 05 nov 1993
    Entregado el 18 nov 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property k/a unit 5 bala industrial estate bala gwynedd t/no: wa 644562 and the proceeds of sale and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 18 nov 1993Registro de un cargo (395)
    • 02 oct 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 10 jun 1985
    Entregado el 10 jun 1985
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 10 jun 1985Registro de una carga

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0