LRUK (DORMANT NO.2) LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | LRUK (DORMANT NO.2) LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 00142234 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de LRUK (DORMANT NO.2) LIMITED?
- Venta al por menor por correo o por Internet (47910) / Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas
¿Dónde se encuentra LRUK (DORMANT NO.2) LIMITED?
| Dirección de la sede social | 2 Holdsworth Street BD1 4AH Bradford West Yorkshire |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de LRUK (DORMANT NO.2) LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| LRUK (HOLDINGS) LIMITED | 06 ago 2015 | 06 ago 2015 |
| REDCATS 2013 LIMITED | 18 abr 2013 | 18 abr 2013 |
| VERT BAUDET (UK) LIMITED | 07 ago 1996 | 07 ago 1996 |
| EMPIRE DIRECT LIMITED | 05 feb 1990 | 05 feb 1990 |
| BRADFORD TEXTILE COMPANY LIMITED(THE) | 25 nov 1915 | 25 nov 1915 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de LRUK (DORMANT NO.2) LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2022 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para LRUK (DORMANT NO.2) LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||
La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida | 1 páginas | SOAS(A) | ||
Cese del nombramiento de Michael Paul Truluck como director el 06 jul 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 1 páginas | DS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2022 | 8 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 22 oct 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2021 | 8 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 22 oct 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2020 | 8 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 22 oct 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2019 | 8 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 22 oct 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2018 | 8 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 22 oct 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cambio de datos del director Mr Michael Truluck el 14 sept 2018 | 2 páginas | CH01 | ||
Notification de Ginette Moulin en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 10 abr 2018 | 2 páginas | PSC01 | ||
Cessation de Eric Yvon Courteille en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 10 abr 2018 | 1 páginas | PSC07 | ||
Cessation de Nathalie Catherine Balla en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 10 abr 2018 | 1 páginas | PSC07 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2017 | 11 páginas | AA | ||
Modification des détails de Lruk (Holdings) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 07 nov 2017 | 2 páginas | PSC05 | ||
Notification de Nathalie Catherine Balla en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016 | 2 páginas | PSC01 | ||
Notification de Eric Yvon Courteille en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016 | 2 páginas | PSC01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 22 oct 2017 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016 | 10 páginas | AA | ||
¿Quiénes son los directivos de LRUK (DORMANT NO.2) LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURKE, Richard | Director | Holdsworth Street BD1 4AH Bradford 2 West Yorkshire | England | British | 197432680001 | |||||
| MCLAUGHLIN, Ellen | Secretario | 6 Wharfe Grove LS22 6HA Wetherby West Yorkshire | British | 125588610001 | ||||||
| OAKES, Frederick William, Mr. | Secretario | Tithe House Way HD2 1RD Huddersfield 18 West Yorkshire | British | 2304400001 | ||||||
| ATKINSON, Neil Gareth | Director | The Old Chapel Knaresborough Road Follifoot HG3 1DT Harrogate North Yorkshire | British | 72405410002 | ||||||
| BALLA, Nathalie Catherine | Director | Holdsworth Street BD1 4AH Bradford 2 West Yorkshire United Kingdom | France | French | 179486450001 | |||||
| BAZIN, Pascal | Director | 43 Bis, Avenue De La Marne Tourcoing 59200 France | French | 79523170001 | ||||||
| BOTT, Richard | Director | 49 Henley Avenue WF12 0LN Dewsbury West Yorkshire | British | 49293190001 | ||||||
| CAMPBELL, William James | Director | 2 Heather Gardens Scarcroft LS14 3HU Leeds West Yorkshire | British | 2303760001 | ||||||
| CHESHIRE, Mark | Director | Crossroads Farm Barton Le Willows YO60 7PD York North Yorkshire | United Kingdom | British | 149554830001 | |||||
| DEVE, Francoise Suzanne Marcelle | Director | Holdsworth Street BD1 4AH Bradford 2 West Yorkshire United Kingdom | France | French | 164987810001 | |||||
| FAINTRENY, Eric Robert | Director | 40 Woodvale Crescent BD16 4AL Bingley West Yorkshire | French | 46646970001 | ||||||
| GREEN, Marianne Mckenzie | Director | The Owl House 19 Eagle Row WA13 0PY Lymm Cheshire | British | 118854820001 | ||||||
| HARRIS, Michael John Charles | Director | The Deri Bramhope Manor Moor Road Bramhope LS16 9HJ Leeds West Yorkshire | British | 2307700001 | ||||||
| HAWKER, Michael Leslie | Director | Monkshorn East Boldre SO42 7WT Brockenhurst Hampshire | United Kingdom | British | 114261580001 | |||||
| HEAVISIDES, Henry John | Director | High Clere Villas 20 Margerison Road Ben Rhydding LS29 8QU Ilkley West Yorkshire | British | 57422610004 | ||||||
| HILL, Andrew Ratcliffe | Director | 43 Park Lane Roundhay LS8 2EH Leeds West Yorkshire | United Kingdom | British | 69640030001 | |||||
| IZARD, Olivier Jacques Georges | Director | Creskeld House Creskeld Lane Arthington LS21 1NU Otley West Yorkshire | French | 87658610002 | ||||||
| JONES, Robert Glyn | Director | 17 Wellington Lodge North Street Winkfield SL4 4TA Windsor Berkshire | British | 116871110002 | ||||||
| JONVILLE, Jean-Luc | Director | 594 Bois D'Achelles Bondues 59910 France | French | 65053520001 | ||||||
| MADELEY, Jane Elisabeth | Director | 102 Leeds Road Bramhope LS16 9AN Leeds West Yorkshire | England | British | 105516350002 | |||||
| MCAULAY, Janet | Director | Pavilion House Coldbath Road HG2 0PB Harrogate North Yorkshire | British | 87365970001 | ||||||
| OHLSSON, Hans | Director | Holdsworth Street BD1 4AH Bradford 2 West Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | Swedish | 133656790001 | |||||
| PALICH, Peter | Director | 33 Borrowdale Drive BB10 2SG Burnley Lancashire | British | 58037440001 | ||||||
| ROBERTS, Andrew William | Director | Holdsworth Street BD1 4AH Bradford 2 West Yorkshire United Kingdom | England | British | 68177770002 | |||||
| ROCHE, Stephane Marie Marcel | Director | Hilly Ridge Grosvenor Road Headingley Leeds West Yorkshire | French | 116192560002 | ||||||
| SKELSEY, Alistair James | Director | Bluebill Lodge 79 Lower Mill Bank Triangle HX6 3ED Sowerby Bridge Halifax West Yorkshire | British | 74013420001 | ||||||
| SMITH, Peter James | Director | Melville Margaret Avenue Bardsey LS17 9AT Leeds West Yorkshire | England | British | 17125140001 | |||||
| THOMSON, Alan | Director | Flat 3 Hamilton House, 4 Park Avenue HG2 9BQ Harrogate | United Kingdom | British | 122421940001 | |||||
| TRULUCK, Michael Paul | Director | Holdsworth Street BD1 4AH Bradford 2 West Yorkshire | England | British | 153010590002 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de LRUK (DORMANT NO.2) LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mrs Ginette Moulin | 10 abr 2018 | Holdsworth Street BD1 4AH Bradford 2 West Yorkshire | No | ||||||||||
Nacionalidad: French País de residencia: France | |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Monsieur Eric Yvon Courteille | 06 abr 2016 | Holdsworth Street BD1 4AH Bradford 2 West Yorkshire | Sí | ||||||||||
Nacionalidad: French País de residencia: France | |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Madame Nathalie Catherine Balla | 06 abr 2016 | Holdsworth Street BD1 4AH Bradford 2 West Yorkshire | Sí | ||||||||||
Nacionalidad: French País de residencia: Belgium | |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Lruk (Holdings) Limited | 06 abr 2016 | Holdsworth Street BD1 4AH Bradford 2 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene LRUK (DORMANT NO.2) LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Northern ireland deed of charge and assignment | Creado el 28 oct 2003 Entregado el 12 nov 2003 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción By way of first fixed charge all its right title and interest in and to the applicable charged monies and to the originator collection accounts. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Deed of charge and assignment | Creado el 28 oct 2003 Entregado el 12 nov 2003 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the chargor to the participant under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción All its right title and interest in and to the applicable charged monies; the originator collection accounts. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 27 nov 1990 Entregado el 11 dic 1990 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility agreement and or facility letter both dated 27/11/90 | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| A fourth supplemental trust deed | Creado el 27 nov 1990 Entregado el 06 dic 1990 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada Securing 6 3/8 per cent debenture stock 1985 90, 8 3/4 per cent debenture stock 1991/96 and 9 1/4 per cent debenture stock 1994/99 created under the various trust deeds and all other moneys due or to become due form the company and/or all or any of the other companies named therein to royal exchange trust company limited as secured by this deed. | |
Breve descripción See doc M93 for further details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Second supplemental trust deed | Creado el 06 jun 1972 Entregado el 06 jun 1972 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada Debenture stock of empire stores (bradford) LTD. Amounting to £4,202,615 outstanding under and secured by a trust deed dated 5TH may 1965 and deeds supplemental thereto | |
Breve descripci ón Floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Supplemental trust deed for securing debenture stock | Creado el 29 ene 1969 Entregado el 05 feb 1969 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada Debenture stock of empire stores (bradford) LTD. Amounting to £2,250,000 including £1,000,000 secured by a trust deed dated 5TH may 1965 | |
Breve descripción Floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Trust deed | Creado el 05 may 1965 Entregado el 14 may 1965 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £1,000,000 debenture stock of empire stores (bradford) LTD | |
Breve descripción Floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Equitable charge without instrument | Creado el 31 mar 1965 Entregado el 14 abr 1965 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £1,000,000 debenture stock of empire stores (bradford) LTD. | |
Breve descripción Floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0