H HEATON LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaH HEATON LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00143011
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de H HEATON LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra H HEATON LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Pearl Assurance House 319 Ballards Lane
    N12 8LY London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de H HEATON LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    HATTERSLEY HEATON LIMITED20 ene 198920 ene 1989
    F.H.T. OVERSEAS LIMITED14 mar 198614 mar 1986
    O.D.GUEST LIMITED14 feb 191614 feb 1916

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de H HEATON LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta03 ene 2015

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para H HEATON LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    10 páginasLIQ13

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 30 nov 2017

    10 páginasLIQ03

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 30 nov 2016

    8 páginas4.68

    Domicilio social registrado cambiado de 11 Old Jewry 7th Floor London EC2R 8DU a Pearl Assurance House 319 Ballards Lane London N12 8LY el 18 dic 2015

    2 páginasAD01

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 01 dic 2015

    LRESSP

    Cese del nombramiento de Coral Suzanne Bidel como director el 22 oct 2015

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 03 ene 2015

    6 páginasAA

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 23 sept 2015

    • Capital: GBP 125,000
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de modificación de los Artículos de Asociación

    RES01
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Nombramiento de Mr Maurice Kalsbeek como director el 01 jul 2015

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Daniel Marc Richard Jaffe como director el 30 jun 2015

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Thomas C. Reeve como director el 04 feb 2015

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 01 nov 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital18 nov 2014

    Estado de capital el 18 nov 2014

    • Capital: GBP 12,500,000
    SH01

    Cambio de datos del director Thomas C. Reeve el 01 ene 2013

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Nicolas Paul Wilkinson el 01 ene 2013

    2 páginasCH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2013

    6 páginasAA

    Cese del nombramiento de Elizabeth Honor Lewzey como director el 30 sept 2014

    1 páginasTM01

    Cambio de datos del director Miss Coral Bidel el 05 sept 2014

    2 páginasCH01

    Nombramiento de Mr Daniel Marc Richard Jaffe como director el 13 ago 2014

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Intertrust (Uk) Limited como secretario el 13 ago 2014

    2 páginasAP04

    ¿Quiénes son los directivos de H HEATON LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    INTERTRUST (UK) LIMITED
    7th Floor
    EC2R 8DU London
    11 Old Jewry
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    7th Floor
    EC2R 8DU London
    11 Old Jewry
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro06307550
    188126550001
    KALSBEEK, Maurice Alexander
    7th Floor
    EC2R 8DU London
    11 Old Jewry
    United Kingdom
    Director
    7th Floor
    EC2R 8DU London
    11 Old Jewry
    United Kingdom
    NetherlandsDutch198232870001
    WILKINSON, Nicolas Paul
    Ballards Lane
    N12 8LY London
    Pearl Assurance House 319
    Director
    Ballards Lane
    N12 8LY London
    Pearl Assurance House 319
    EnglandBritish48808690001
    BURTON, Denise Patricia
    Warren Close
    Coombe Hill Road
    KT2 7DY Kingston Upon Thames
    Surrey
    Secretario
    Warren Close
    Coombe Hill Road
    KT2 7DY Kingston Upon Thames
    Surrey
    British47432570004
    BURTON, Denise Patricia
    42 Windmill Rise
    Kingston Hill
    KT2 7TU Kingston Upon Thames
    Surrey
    Secretario
    42 Windmill Rise
    Kingston Hill
    KT2 7TU Kingston Upon Thames
    Surrey
    British47432570001
    HOPSTER, Michael John
    40 Brooksbys Walk
    E9 6DF London
    Flat B
    United Kingdom
    Secretario
    40 Brooksbys Walk
    E9 6DF London
    Flat B
    United Kingdom
    157102390001
    LEWZEY, Elizabeth Honor
    First Floor
    17-25 Hartfield Road
    SW19 3SE Wimbledon
    Pinnacle House
    London
    United Kingdom
    Secretario
    First Floor
    17-25 Hartfield Road
    SW19 3SE Wimbledon
    Pinnacle House
    London
    United Kingdom
    165833050001
    BAKER, Peter Robert
    Dumble Cottage Brookside
    Water Lane Oxton
    NG25 0SH Southwell
    Nottinghamshire
    Director
    Dumble Cottage Brookside
    Water Lane Oxton
    NG25 0SH Southwell
    Nottinghamshire
    British48243830002
    BIDEL, Coral Suzanne
    7th Floor
    EC2R 8DU London
    11 Old Jewry
    England
    Director
    7th Floor
    EC2R 8DU London
    11 Old Jewry
    England
    United KingdomBritish179297460002
    BOSS, Terence Steven James
    19 Bridle Road
    Bramcote
    NG9 3DH Nottingham
    Nottinghamshire
    Director
    19 Bridle Road
    Bramcote
    NG9 3DH Nottingham
    Nottinghamshire
    British33154590001
    BURTON, Denise Patricia
    Warren Close
    Coombe Hill Road
    KT2 7DY Kingston Upon Thames
    Surrey
    Director
    Warren Close
    Coombe Hill Road
    KT2 7DY Kingston Upon Thames
    Surrey
    United KingdomBritish47432570004
    CLARKSON, Antoni Raymond
    2 York Gardens Main Street
    Willerby
    HU10 6AQ Hull
    North Humberside
    Director
    2 York Gardens Main Street
    Willerby
    HU10 6AQ Hull
    North Humberside
    British95628860001
    DUNCAN, Ian Alexander
    Durham House
    Durham Place
    SW3 4ET London
    Director
    Durham House
    Durham Place
    SW3 4ET London
    United KingdomBritish27300002
    DYKES, Alan
    East Down Mill
    EX31 4LZ Bugford
    Devon
    Director
    East Down Mill
    EX31 4LZ Bugford
    Devon
    British72428380001
    FLANAGAN, Paul Edward
    Flat 9
    19 Holland Park
    W11 3TD London
    Director
    Flat 9
    19 Holland Park
    W11 3TD London
    United KingdomBritish69281780002
    HOPSTER, Michael John
    Flat B
    40 Brooksbys Walk
    E9 6DF London
    Director
    Flat B
    40 Brooksbys Walk
    E9 6DF London
    United KingdomBritish77921850004
    HOUGHTON, Paul David
    2 Mayfield Court
    Formby
    L37 7JL Liverpool
    Merseyside
    Director
    2 Mayfield Court
    Formby
    L37 7JL Liverpool
    Merseyside
    British95097460001
    HUMPRIES, Michael Rodney
    29 Manor Close
    Edwalton
    NG12 4BH Nottingham
    Notts
    Director
    29 Manor Close
    Edwalton
    NG12 4BH Nottingham
    Notts
    British33154600001
    JAFFE, Daniel Marc Richard
    7th Floor
    EC2R 8DU London
    11 Old Jewry
    England
    Director
    7th Floor
    EC2R 8DU London
    11 Old Jewry
    England
    United KingdomBritish140811810001
    JONES, Ronald Cadrex
    16 Martindale
    Swallow Street
    SL0 0HX Iver
    Buckinghamshire
    Director
    16 Martindale
    Swallow Street
    SL0 0HX Iver
    Buckinghamshire
    British53709390001
    LEWZEY, Elizabeth Honor
    First Floor
    17-25 Hartfield Road
    SW19 3SE Wimbledon
    Pinnacle House
    London
    United Kingdom
    Director
    First Floor
    17-25 Hartfield Road
    SW19 3SE Wimbledon
    Pinnacle House
    London
    United Kingdom
    EnglandBritish59381700003
    MARCHANT, Richard Norman
    60 The Mount
    Curdworth
    B76 9HR Sutton Coldfield
    West Midlands
    Director
    60 The Mount
    Curdworth
    B76 9HR Sutton Coldfield
    West Midlands
    British26880001
    O REILLY, Peter
    Mandalay Kemp Road
    Swanland
    HU14 3LZ North Ferriby
    North Humberside
    Director
    Mandalay Kemp Road
    Swanland
    HU14 3LZ North Ferriby
    North Humberside
    British39066360002
    PATON, Brian
    34 Bremeridge Road
    BA13 3UJ Westbury
    Wiltshire
    Director
    34 Bremeridge Road
    BA13 3UJ Westbury
    Wiltshire
    British33154610001
    PORTER, Norman Charles
    Farnham House 2 Beedingwood Drive
    Forest Road Colgate
    RH12 4TE Horsham
    West Sussex
    Director
    Farnham House 2 Beedingwood Drive
    Forest Road Colgate
    RH12 4TE Horsham
    West Sussex
    EnglandBritish445360034
    READING, Anthony John
    16 Heatherside Gardens
    Farnham Common
    SL2 3RR Slough
    Berkshire
    Director
    16 Heatherside Gardens
    Farnham Common
    SL2 3RR Slough
    Berkshire
    United KingdomBritish17110410001
    REEVE, Thomas C.
    7th Floor
    EC2R 8DU London
    11 Old Jewry
    England
    Director
    7th Floor
    EC2R 8DU London
    11 Old Jewry
    England
    United StatesAmerican161822390001
    SEDGWICK, Robert
    Hall Farm House
    Meen Street Eakring
    NG22 0DD Newark
    Nottinghamshire
    Director
    Hall Farm House
    Meen Street Eakring
    NG22 0DD Newark
    Nottinghamshire
    British33154630001
    SMITH, Brian Frederick
    14 Troutbeck Crescent
    Bramcote
    NG9 3BP Nottingham
    Nottinghamshire
    Director
    14 Troutbeck Crescent
    Bramcote
    NG9 3BP Nottingham
    Nottinghamshire
    British33154640001
    SOUTHALL, John Norman
    54 Hallfields
    Edwalton
    NG12 4AA Nottingham
    Nottinghamshire
    Director
    54 Hallfields
    Edwalton
    NG12 4AA Nottingham
    Nottinghamshire
    British33154650001
    STARK, John David Sinclair
    Tara 15 Copsem Drive
    KT10 9HD Esher
    Surrey
    Director
    Tara 15 Copsem Drive
    KT10 9HD Esher
    Surrey
    British27350001
    SWAIN, Malcolm Terence
    19 Meadow Way
    Rowledge
    GU10 4DY Farnham
    Surrey
    Director
    19 Meadow Way
    Rowledge
    GU10 4DY Farnham
    Surrey
    United KingdomBritish50333990001
    WAGSTAFF, Neil Philip
    49 Turnberry Drive
    Beckfield Lane Acomb
    YO2 5QP York
    Director
    49 Turnberry Drive
    Beckfield Lane Acomb
    YO2 5QP York
    British51804690001
    WALKER, John James
    6 Morris Park
    Hartford
    CW8 1SB Northwich
    Cheshire
    Director
    6 Morris Park
    Hartford
    CW8 1SB Northwich
    Cheshire
    British58424540001
    WATTS, Nigel James
    Little Tidnock Farm Gawsworth
    SK11 9JD Macclesfield
    Cheshire
    Director
    Little Tidnock Farm Gawsworth
    SK11 9JD Macclesfield
    Cheshire
    British48505250001

    ¿Tiene H HEATON LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A security agreement
    Creado el 30 sept 2010
    Entregado el 15 oct 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the issuers to any of the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge all property and assets present and future, including goodwill,uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Wilmington Trust Fsb (The Collateral Agent)
    Transacciones
    • 15 oct 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 03 ene 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Security agreement
    Creado el 30 sept 2010
    Entregado el 13 oct 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any loan party and its restricted subsidiaries and all monies due or to become due from holdings or any restricted subsidiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Citicorp Usa, Inc. (The Collateral Agent)
    Transacciones
    • 13 oct 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 03 ene 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Fixed and floating charge
    Creado el 07 may 1981
    Entregado el 12 may 1981
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over . including book debts and other debts. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • Midland Bank Limited
    Transacciones
    • 12 may 1981Registro de una carga
    Floating charge
    Creado el 23 mar 1976
    Entregado el 26 mar 1976
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • Midland Bank LTD
    Transacciones
    • 26 mar 1976Registro de una carga
    • 20 ago 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene H HEATON LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    01 dic 2015Inicio de la liquidación
    15 jun 2018Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Asher Miller
    David Rubin & Partners
    Pearl Assurance House
    N12 8LY 319 Ballards Lane
    London
    Profesional
    David Rubin & Partners
    Pearl Assurance House
    N12 8LY 319 Ballards Lane
    London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0