H HEATON LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | H HEATON LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 00143011 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de H HEATON LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra H HEATON LIMITED?
| Dirección de la sede social | Pearl Assurance House 319 Ballards Lane N12 8LY London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de H HEATON LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| HATTERSLEY HEATON LIMITED | 20 ene 1989 | 20 ene 1989 |
| F.H.T. OVERSEAS LIMITED | 14 mar 1986 | 14 mar 1986 |
| O.D.GUEST LIMITED | 14 feb 1916 | 14 feb 1916 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de H HEATON LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 03 ene 2015 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para H HEATON LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 10 páginas | LIQ13 | ||||||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 30 nov 2017 | 10 páginas | LIQ03 | ||||||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 30 nov 2016 | 8 páginas | 4.68 | ||||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 11 Old Jewry 7th Floor London EC2R 8DU a Pearl Assurance House 319 Ballards Lane London N12 8LY el 18 dic 2015 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||||||
Declaración de solvencia | 3 páginas | 4.70 | ||||||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 1 páginas | 600 | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cese del nombramiento de Coral Suzanne Bidel como director el 22 oct 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 03 ene 2015 | 6 páginas | AA | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||||||
Estado de capital el 23 sept 2015
| 4 páginas | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nombramiento de Mr Maurice Kalsbeek como director el 01 jul 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Daniel Marc Richard Jaffe como director el 30 jun 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Thomas C. Reeve como director el 04 feb 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 nov 2014 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cambio de datos del director Thomas C. Reeve el 01 ene 2013 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Cambio de datos del director Mr Nicolas Paul Wilkinson el 01 ene 2013 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2013 | 6 páginas | AA | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Elizabeth Honor Lewzey como director el 30 sept 2014 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cambio de datos del director Miss Coral Bidel el 05 sept 2014 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Daniel Marc Richard Jaffe como director el 13 ago 2014 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Intertrust (Uk) Limited como secretario el 13 ago 2014 | 2 páginas | AP04 | ||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de H HEATON LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERTRUST (UK) LIMITED | Secretario corporativo | 7th Floor EC2R 8DU London 11 Old Jewry United Kingdom |
| 188126550001 | ||||||||||
| KALSBEEK, Maurice Alexander | Director | 7th Floor EC2R 8DU London 11 Old Jewry United Kingdom | Netherlands | Dutch | 198232870001 | |||||||||
| WILKINSON, Nicolas Paul | Director | Ballards Lane N12 8LY London Pearl Assurance House 319 | England | British | 48808690001 | |||||||||
| BURTON, Denise Patricia | Secretario | Warren Close Coombe Hill Road KT2 7DY Kingston Upon Thames Surrey | British | 47432570004 | ||||||||||
| BURTON, Denise Patricia | Secretario | 42 Windmill Rise Kingston Hill KT2 7TU Kingston Upon Thames Surrey | British | 47432570001 | ||||||||||
| HOPSTER, Michael John | Secretario | 40 Brooksbys Walk E9 6DF London Flat B United Kingdom | 157102390001 | |||||||||||
| LEWZEY, Elizabeth Honor | Secretario | First Floor 17-25 Hartfield Road SW19 3SE Wimbledon Pinnacle House London United Kingdom | 165833050001 | |||||||||||
| BAKER, Peter Robert | Director | Dumble Cottage Brookside Water Lane Oxton NG25 0SH Southwell Nottinghamshire | British | 48243830002 | ||||||||||
| BIDEL, Coral Suzanne | Director | 7th Floor EC2R 8DU London 11 Old Jewry England | United Kingdom | British | 179297460002 | |||||||||
| BOSS, Terence Steven James | Director | 19 Bridle Road Bramcote NG9 3DH Nottingham Nottinghamshire | British | 33154590001 | ||||||||||
| BURTON, Denise Patricia | Director | Warren Close Coombe Hill Road KT2 7DY Kingston Upon Thames Surrey | United Kingdom | British | 47432570004 | |||||||||
| CLARKSON, Antoni Raymond | Director | 2 York Gardens Main Street Willerby HU10 6AQ Hull North Humberside | British | 95628860001 | ||||||||||
| DUNCAN, Ian Alexander | Director | Durham House Durham Place SW3 4ET London | United Kingdom | British | 27300002 | |||||||||
| DYKES, Alan | Director | East Down Mill EX31 4LZ Bugford Devon | British | 72428380001 | ||||||||||
| FLANAGAN, Paul Edward | Director | Flat 9 19 Holland Park W11 3TD London | United Kingdom | British | 69281780002 | |||||||||
| HOPSTER, Michael John | Director | Flat B 40 Brooksbys Walk E9 6DF London | United Kingdom | British | 77921850004 | |||||||||
| HOUGHTON, Paul David | Director | 2 Mayfield Court Formby L37 7JL Liverpool Merseyside | British | 95097460001 | ||||||||||
| HUMPRIES, Michael Rodney | Director | 29 Manor Close Edwalton NG12 4BH Nottingham Notts | British | 33154600001 | ||||||||||
| JAFFE, Daniel Marc Richard | Director | 7th Floor EC2R 8DU London 11 Old Jewry England | United Kingdom | British | 140811810001 | |||||||||
| JONES, Ronald Cadrex | Director | 16 Martindale Swallow Street SL0 0HX Iver Buckinghamshire | British | 53709390001 | ||||||||||
| LEWZEY, Elizabeth Honor | Director | First Floor 17-25 Hartfield Road SW19 3SE Wimbledon Pinnacle House London United Kingdom | England | British | 59381700003 | |||||||||
| MARCHANT, Richard Norman | Director | 60 The Mount Curdworth B76 9HR Sutton Coldfield West Midlands | British | 26880001 | ||||||||||
| O REILLY, Peter | Director | Mandalay Kemp Road Swanland HU14 3LZ North Ferriby North Humberside | British | 39066360002 | ||||||||||
| PATON, Brian | Director | 34 Bremeridge Road BA13 3UJ Westbury Wiltshire | British | 33154610001 | ||||||||||
| PORTER, Norman Charles | Director | Farnham House 2 Beedingwood Drive Forest Road Colgate RH12 4TE Horsham West Sussex | England | British | 445360034 | |||||||||
| READING, Anthony John | Director | 16 Heatherside Gardens Farnham Common SL2 3RR Slough Berkshire | United Kingdom | British | 17110410001 | |||||||||
| REEVE, Thomas C. | Director | 7th Floor EC2R 8DU London 11 Old Jewry England | United States | American | 161822390001 | |||||||||
| SEDGWICK, Robert | Director | Hall Farm House Meen Street Eakring NG22 0DD Newark Nottinghamshire | British | 33154630001 | ||||||||||
| SMITH, Brian Frederick | Director | 14 Troutbeck Crescent Bramcote NG9 3BP Nottingham Nottinghamshire | British | 33154640001 | ||||||||||
| SOUTHALL, John Norman | Director | 54 Hallfields Edwalton NG12 4AA Nottingham Nottinghamshire | British | 33154650001 | ||||||||||
| STARK, John David Sinclair | Director | Tara 15 Copsem Drive KT10 9HD Esher Surrey | British | 27350001 | ||||||||||
| SWAIN, Malcolm Terence | Director | 19 Meadow Way Rowledge GU10 4DY Farnham Surrey | United Kingdom | British | 50333990001 | |||||||||
| WAGSTAFF, Neil Philip | Director | 49 Turnberry Drive Beckfield Lane Acomb YO2 5QP York | British | 51804690001 | ||||||||||
| WALKER, John James | Director | 6 Morris Park Hartford CW8 1SB Northwich Cheshire | British | 58424540001 | ||||||||||
| WATTS, Nigel James | Director | Little Tidnock Farm Gawsworth SK11 9JD Macclesfield Cheshire | British | 48505250001 |
¿Tiene H HEATON LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| A security agreement | Creado el 30 sept 2010 Entregado el 15 oct 2010 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the issuers to any of the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charge all property and assets present and future, including goodwill,uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Security agreement | Creado el 30 sept 2010 Entregado el 13 oct 2010 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from any loan party and its restricted subsidiaries and all monies due or to become due from holdings or any restricted subsidiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Fixed and floating charge | Creado el 07 may 1981 Entregado el 12 may 1981 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charge over . including book debts and other debts. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Floating charge | Creado el 23 mar 1976 Entregado el 26 mar 1976 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene H HEATON LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0