SOCIETY OF BRITISH AEROSPACE COMPANIES (THE)

SOCIETY OF BRITISH AEROSPACE COMPANIES (THE)

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSOCIETY OF BRITISH AEROSPACE COMPANIES (THE)
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad privada sin límite de capital
    Número de empresa 00143447
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de SOCIETY OF BRITISH AEROSPACE COMPANIES (THE)?

    • Actividades de organizaciones de miembros empresariales y de empleadores (94110) / Otras actividades de servicios

    ¿Dónde se encuentra SOCIETY OF BRITISH AEROSPACE COMPANIES (THE)?

    Dirección de la sede social
    Salamanca Square
    9 Albert Embankment
    SE1 7SP London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SOCIETY OF BRITISH AEROSPACE COMPANIES (THE)?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    SOCIETY OF BRITISH AEROSPACE COMPANIES (THE) LIMITED10 sept 201010 sept 2010

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de SOCIETY OF BRITISH AEROSPACE COMPANIES (THE)?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2016

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para SOCIETY OF BRITISH AEROSPACE COMPANIES (THE)?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ2

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Declaración de confirmación presentada el 13 jul 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Declaración de confirmación presentada el 13 jul 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Declaración de confirmación presentada el 13 jul 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Declaración de confirmación presentada el 13 jul 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Declaración de confirmación presentada el 13 jul 2017 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016

    5 páginasAA

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015

    10 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 13 jul 2016 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014

    3 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 13 jul 2015 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital27 jul 2015

    Estado de capital el 27 jul 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2013

    3 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 13 jul 2014 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital30 jul 2014

    Estado de capital el 30 jul 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2012

    3 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 13 jul 2013 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital18 jul 2013

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 18 jul 2013

    SH01

    Nombramiento de Ms Beth Porter como secretario

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Robert Sayers como secretario

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Ian Godden como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Paul Brian Alfred Everitt como director

    2 páginasAP01

    Déclaration annuelle établie au 13 jul 2012 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01

    Cambio de datos del director Mr Ian Adam Godden el 16 jul 2012

    2 páginasCH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2011

    15 páginasAA

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2010

    18 páginasAA

    Nombramiento de Mr Ian Adam Godden como director

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de SOCIETY OF BRITISH AEROSPACE COMPANIES (THE)?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    PORTER, Beth
    E T P S Road
    GU14 6FD Farnborough
    Showcentre
    Hampshire
    England
    Secretario
    E T P S Road
    GU14 6FD Farnborough
    Showcentre
    Hampshire
    England
    179916010001
    EVERITT, Paul Brian Alfred
    Salamanca Square
    9 Albert Embankment
    SE1 7SP London
    Director
    Salamanca Square
    9 Albert Embankment
    SE1 7SP London
    EnglandBritish127067280001
    BATTEN, Kenneth Henry
    1 Welbeck Avenue
    Highfield
    SO17 1SW Southampton
    Hampshire
    Secretario
    1 Welbeck Avenue
    Highfield
    SO17 1SW Southampton
    Hampshire
    British14410550001
    BIRD, Katherine Evendra
    42 Baldock Road
    Stotfold
    SG5 4PB Hitchin
    Hertfordshire
    Secretario
    42 Baldock Road
    Stotfold
    SG5 4PB Hitchin
    Hertfordshire
    British79431470001
    CHAPMAN, Ian
    2 Palmerston House
    126 Westminster Bridge Rd
    SE1 7UW London
    Secretario
    2 Palmerston House
    126 Westminster Bridge Rd
    SE1 7UW London
    British73385590002
    SAYERS, Robert
    26 Dorian Drive
    Cheapside
    SL5 7QL Ascot
    Berkshire
    Secretario
    26 Dorian Drive
    Cheapside
    SL5 7QL Ascot
    Berkshire
    British30546490002
    SIDEBOTTOM, Trevor George
    7 The Wheatridge
    GL4 4DQ Gloucester
    Secretario
    7 The Wheatridge
    GL4 4DQ Gloucester
    British54601040001
    ANNETT, Richard John
    Nallers Farm Askerswell
    DT2 9EJ Dorchester
    Dorset
    Director
    Nallers Farm Askerswell
    DT2 9EJ Dorchester
    Dorset
    British63294730001
    ARENDT, Axel
    801 Westminster Green
    8 Dean Ryle Street Westminster
    SW1P 4DA London
    Director
    801 Westminster Green
    8 Dean Ryle Street Westminster
    SW1P 4DA London
    German113562590001
    BANHAM, Stephen James
    42 West Street
    RG26 3SX Tadley
    Hampshire
    Director
    42 West Street
    RG26 3SX Tadley
    Hampshire
    United KingdomBritish54822030002
    BARBER, Norman Victor
    Greylands 17 Merrow Croft
    Merrow
    GU1 2XH Guildford
    Surrey
    Director
    Greylands 17 Merrow Croft
    Merrow
    GU1 2XH Guildford
    Surrey
    EnglandBritish6210060001
    BEECH, Simon William
    9 Greytree Crescent
    Dorridge
    B93 8SL Solihull
    West Midlands
    Director
    9 Greytree Crescent
    Dorridge
    B93 8SL Solihull
    West Midlands
    British73297190001
    BELISARIO, Anthony Alfredo
    24 Coronation Road
    Prestbury
    GL52 3DA Cheltenham
    Gloucestershire
    Director
    24 Coronation Road
    Prestbury
    GL52 3DA Cheltenham
    Gloucestershire
    United KingdomBritish19258750001
    BENNETT, Katherine Susan
    Grovewood Cottage
    Horton
    BS37 6QN Bristol
    Avon
    Director
    Grovewood Cottage
    Horton
    BS37 6QN Bristol
    Avon
    British107026600001
    BLOGH, Julian, Doctor
    Malvern 83 Green Lane
    SL1 8EG Burnham Beeches
    Buckinghamshire
    Director
    Malvern 83 Green Lane
    SL1 8EG Burnham Beeches
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish36783690003
    BLUNDELL, Charles Edward
    Buckingham Gate
    SW1E 6AT London
    65
    Director
    Buckingham Gate
    SW1E 6AT London
    65
    British44158000002
    BROADHURST, Martin Tilston
    5 Chancellery Mews
    IP33 3EG Bury St Edmunds
    Suffolk
    Director
    5 Chancellery Mews
    IP33 3EG Bury St Edmunds
    Suffolk
    British26365720002
    BROWN, David Robert
    2 Wildwood Close
    GU22 8PL Woking
    Surrey
    Director
    2 Wildwood Close
    GU22 8PL Woking
    Surrey
    British70823740001
    BRUNDLE, Kenneth Sydney
    Carigullian Cottage
    27a Killyleagh Road
    BT23 6TD Newtownards
    County Down
    Director
    Carigullian Cottage
    27a Killyleagh Road
    BT23 6TD Newtownards
    County Down
    Northern IrelandBritish163918190001
    BRYSON, Marcus James Stirling
    1 Jura Close
    Cosham
    PO6 3UG Portsmouth
    Hampshire
    Director
    1 Jura Close
    Cosham
    PO6 3UG Portsmouth
    Hampshire
    EnglandBritish82769940001
    BUNDRED, David George
    31 Lindsey Crescent
    CV8 1FL Kenilworth
    Warwickshire
    Director
    31 Lindsey Crescent
    CV8 1FL Kenilworth
    Warwickshire
    United KingdomBritish70291370001
    BURNS, Christopher Robert, Dr
    66 Fairmile Lane
    Doonside
    KT11 2DE Cobham
    Surrey
    Director
    66 Fairmile Lane
    Doonside
    KT11 2DE Cobham
    Surrey
    British77008070001
    BURRIDGE, Harold James
    15 Oakley Road
    BH21 1QJ Wimborne
    Dorset
    Director
    15 Oakley Road
    BH21 1QJ Wimborne
    Dorset
    EnglandBritish72691890001
    BURROWS, Peter John
    Paddock Cottage
    East Coker
    BA22 9JP Yeovil
    Somerset
    Director
    Paddock Cottage
    East Coker
    BA22 9JP Yeovil
    Somerset
    British5107210001
    BURTON, Philip Frederick Jocelyn
    Meadowcroft Miz Maze
    Leigh
    DT9 6JJ Sherborne
    Dorset
    Director
    Meadowcroft Miz Maze
    Leigh
    DT9 6JJ Sherborne
    Dorset
    EnglandBritish65588520001
    BUSUTTIL, Walter Gerard Paul
    48 Fernside
    M26 1EQ Radcliffe
    Lancashire
    Director
    48 Fernside
    M26 1EQ Radcliffe
    Lancashire
    Maltese82769840001
    BUSUTTIL, Walter Gerard Paul
    Robecq Painswick Road
    Brockworth
    GL3 4RP Gloucester
    Director
    Robecq Painswick Road
    Brockworth
    GL3 4RP Gloucester
    Maltese58388590001
    CASE, Richard Ian
    Melchester House
    Horsington
    BA8 0EG Templecombe
    Somerset
    Director
    Melchester House
    Horsington
    BA8 0EG Templecombe
    Somerset
    EnglandBritish3618430001
    CASSIDY, Michael John
    De-Mar
    Aspen Holt Bassett Wood
    SO16 3QE Southampton
    Director
    De-Mar
    Aspen Holt Bassett Wood
    SO16 3QE Southampton
    British14410560001
    CHEFFINS, John Patrick
    65 Buckingham Gate
    SW1E 6AT London
    Director
    65 Buckingham Gate
    SW1E 6AT London
    British Canadian43529390003
    CHISHOLM, John Alexander Raymond, Sir
    Batchworth Hill House London Road
    WD3 1JS Rickmansworth
    Hertfordshire
    Director
    Batchworth Hill House London Road
    WD3 1JS Rickmansworth
    Hertfordshire
    United KingdomBritish52854760001
    CHISNALL, Graham
    10 Pear Tree Lane
    GU10 4DW Rowledge
    Little Orchard
    Surrey
    Director
    10 Pear Tree Lane
    GU10 4DW Rowledge
    Little Orchard
    Surrey
    United KingdomBritish135061600001
    CHOW, Chung Kong, Sir
    Flat 10
    20 Lowndes Square
    SW1X 9HD London
    Director
    Flat 10
    20 Lowndes Square
    SW1X 9HD London
    British37736600002
    CLARK, Robin Hartley Ledgerd
    Glebe Cottage
    Rockbourne
    SP6 3NA Fordingbridge
    Hampshire
    Director
    Glebe Cottage
    Rockbourne
    SP6 3NA Fordingbridge
    Hampshire
    British73934900001
    CLARK, Robin Hartley Ledgerd
    Glebe Cottage
    Rockbourne
    SP6 3NA Fordingbridge
    Hampshire
    Director
    Glebe Cottage
    Rockbourne
    SP6 3NA Fordingbridge
    Hampshire
    British73934900001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de SOCIETY OF BRITISH AEROSPACE COMPANIES (THE)?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    9 Albert Embankment
    SE1 7SP London
    Salamanca Square
    England
    06 abr 2016
    9 Albert Embankment
    SE1 7SP London
    Salamanca Square
    England
    No
    Forma jurídicaRegistered Legal Entity
    País de registroUk
    Autoridad legalEngland And Wales
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro07016635
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.

    ¿Tiene SOCIETY OF BRITISH AEROSPACE COMPANIES (THE) alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Security agreement
    Creado el 04 jul 2007
    Entregado el 25 jul 2007
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    L/H property k/a 9G albert embankment london (formerly k/a unit 7 9 albert embankment london) all buildings,fixtures,fittings and fixed plant and machienry. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • William Kenneth Maciver and Gordon Francis Page and Charles Nicholas Hall (Being Trustees Ofthe Society of British Aerospace Companies Limited Pension and Life Assurance Plan "the Scheme")
    Transacciones
    • 25 jul 2007Registro de un cargo (395)
    Mortgage
    Creado el 01 feb 2006
    Entregado el 04 feb 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H property k/a suite 7 salamanca square albert embankment london. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 04 feb 2006Registro de un cargo (395)
    • 10 nov 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Mortgage deed
    Creado el 12 feb 2003
    Entregado el 21 feb 2003
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The freehold property known as duxbury house 60 petty france victoria london SW1H 9EU title number NGL641010. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 21 feb 2003Registro de un cargo (395)
    Deposit agreement to secure own liabilities
    Creado el 24 abr 2002
    Entregado el 08 may 2002
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The deposit (as defined) and all such rights to the repayment thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 08 may 2002Registro de un cargo (395)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0