SOCIETY OF BRITISH AEROSPACE COMPANIES (THE)
Visión general
| Nombre de la empresa | SOCIETY OF BRITISH AEROSPACE COMPANIES (THE) |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad privada sin límite de capital |
| Número de empresa | 00143447 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de SOCIETY OF BRITISH AEROSPACE COMPANIES (THE)?
- Actividades de organizaciones de miembros empresariales y de empleadores (94110) / Otras actividades de servicios
¿Dónde se encuentra SOCIETY OF BRITISH AEROSPACE COMPANIES (THE)?
| Dirección de la sede social | Salamanca Square 9 Albert Embankment SE1 7SP London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SOCIETY OF BRITISH AEROSPACE COMPANIES (THE)?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| SOCIETY OF BRITISH AEROSPACE COMPANIES (THE) LIMITED | 10 sept 2010 | 10 sept 2010 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de SOCIETY OF BRITISH AEROSPACE COMPANIES (THE)?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2016 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para SOCIETY OF BRITISH AEROSPACE COMPANIES (THE)?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ1 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 13 jul 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 13 jul 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 13 jul 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 13 jul 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 13 jul 2017 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015 | 10 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 13 jul 2016 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 13 jul 2015 avec liste complète des actionnaires | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2013 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 13 jul 2014 avec liste complète des actionnaires | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2012 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 13 jul 2013 avec liste complète des actionnaires | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nombramiento de Ms Beth Porter como secretario | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Robert Sayers como secretario | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Ian Godden como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Paul Brian Alfred Everitt como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 13 jul 2012 avec liste complète des actionnaires | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Ian Adam Godden el 16 jul 2012 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2011 | 15 páginas | AA | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2010 | 18 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Ian Adam Godden como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de SOCIETY OF BRITISH AEROSPACE COMPANIES (THE)?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTER, Beth | Secretario | E T P S Road GU14 6FD Farnborough Showcentre Hampshire England | 179916010001 | |||||||
| EVERITT, Paul Brian Alfred | Director | Salamanca Square 9 Albert Embankment SE1 7SP London | England | British | 127067280001 | |||||
| BATTEN, Kenneth Henry | Secretario | 1 Welbeck Avenue Highfield SO17 1SW Southampton Hampshire | British | 14410550001 | ||||||
| BIRD, Katherine Evendra | Secretario | 42 Baldock Road Stotfold SG5 4PB Hitchin Hertfordshire | British | 79431470001 | ||||||
| CHAPMAN, Ian | Secretario | 2 Palmerston House 126 Westminster Bridge Rd SE1 7UW London | British | 73385590002 | ||||||
| SAYERS, Robert | Secretario | 26 Dorian Drive Cheapside SL5 7QL Ascot Berkshire | British | 30546490002 | ||||||
| SIDEBOTTOM, Trevor George | Secretario | 7 The Wheatridge GL4 4DQ Gloucester | British | 54601040001 | ||||||
| ANNETT, Richard John | Director | Nallers Farm Askerswell DT2 9EJ Dorchester Dorset | British | 63294730001 | ||||||
| ARENDT, Axel | Director | 801 Westminster Green 8 Dean Ryle Street Westminster SW1P 4DA London | German | 113562590001 | ||||||
| BANHAM, Stephen James | Director | 42 West Street RG26 3SX Tadley Hampshire | United Kingdom | British | 54822030002 | |||||
| BARBER, Norman Victor | Director | Greylands 17 Merrow Croft Merrow GU1 2XH Guildford Surrey | England | British | 6210060001 | |||||
| BEECH, Simon William | Director | 9 Greytree Crescent Dorridge B93 8SL Solihull West Midlands | British | 73297190001 | ||||||
| BELISARIO, Anthony Alfredo | Director | 24 Coronation Road Prestbury GL52 3DA Cheltenham Gloucestershire | United Kingdom | British | 19258750001 | |||||
| BENNETT, Katherine Susan | Director | Grovewood Cottage Horton BS37 6QN Bristol Avon | British | 107026600001 | ||||||
| BLOGH, Julian, Doctor | Director | Malvern 83 Green Lane SL1 8EG Burnham Beeches Buckinghamshire | United Kingdom | British | 36783690003 | |||||
| BLUNDELL, Charles Edward | Director | Buckingham Gate SW1E 6AT London 65 | British | 44158000002 | ||||||
| BROADHURST, Martin Tilston | Director | 5 Chancellery Mews IP33 3EG Bury St Edmunds Suffolk | British | 26365720002 | ||||||
| BROWN, David Robert | Director | 2 Wildwood Close GU22 8PL Woking Surrey | British | 70823740001 | ||||||
| BRUNDLE, Kenneth Sydney | Director | Carigullian Cottage 27a Killyleagh Road BT23 6TD Newtownards County Down | Northern Ireland | British | 163918190001 | |||||
| BRYSON, Marcus James Stirling | Director | 1 Jura Close Cosham PO6 3UG Portsmouth Hampshire | England | British | 82769940001 | |||||
| BUNDRED, David George | Director | 31 Lindsey Crescent CV8 1FL Kenilworth Warwickshire | United Kingdom | British | 70291370001 | |||||
| BURNS, Christopher Robert, Dr | Director | 66 Fairmile Lane Doonside KT11 2DE Cobham Surrey | British | 77008070001 | ||||||
| BURRIDGE, Harold James | Director | 15 Oakley Road BH21 1QJ Wimborne Dorset | England | British | 72691890001 | |||||
| BURROWS, Peter John | Director | Paddock Cottage East Coker BA22 9JP Yeovil Somerset | British | 5107210001 | ||||||
| BURTON, Philip Frederick Jocelyn | Director | Meadowcroft Miz Maze Leigh DT9 6JJ Sherborne Dorset | England | British | 65588520001 | |||||
| BUSUTTIL, Walter Gerard Paul | Director | 48 Fernside M26 1EQ Radcliffe Lancashire | Maltese | 82769840001 | ||||||
| BUSUTTIL, Walter Gerard Paul | Director | Robecq Painswick Road Brockworth GL3 4RP Gloucester | Maltese | 58388590001 | ||||||
| CASE, Richard Ian | Director | Melchester House Horsington BA8 0EG Templecombe Somerset | England | British | 3618430001 | |||||
| CASSIDY, Michael John | Director | De-Mar Aspen Holt Bassett Wood SO16 3QE Southampton | British | 14410560001 | ||||||
| CHEFFINS, John Patrick | Director | 65 Buckingham Gate SW1E 6AT London | British Canadian | 43529390003 | ||||||
| CHISHOLM, John Alexander Raymond, Sir | Director | Batchworth Hill House London Road WD3 1JS Rickmansworth Hertfordshire | United Kingdom | British | 52854760001 | |||||
| CHISNALL, Graham | Director | 10 Pear Tree Lane GU10 4DW Rowledge Little Orchard Surrey | United Kingdom | British | 135061600001 | |||||
| CHOW, Chung Kong, Sir | Director | Flat 10 20 Lowndes Square SW1X 9HD London | British | 37736600002 | ||||||
| CLARK, Robin Hartley Ledgerd | Director | Glebe Cottage Rockbourne SP6 3NA Fordingbridge Hampshire | British | 73934900001 | ||||||
| CLARK, Robin Hartley Ledgerd | Director | Glebe Cottage Rockbourne SP6 3NA Fordingbridge Hampshire | British | 73934900001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de SOCIETY OF BRITISH AEROSPACE COMPANIES (THE)?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ads | 06 abr 2016 | 9 Albert Embankment SE1 7SP London Salamanca Square England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene SOCIETY OF BRITISH AEROSPACE COMPANIES (THE) alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Security agreement | Creado el 04 jul 2007 Entregado el 25 jul 2007 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción L/H property k/a 9G albert embankment london (formerly k/a unit 7 9 albert embankment london) all buildings,fixtures,fittings and fixed plant and machienry. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Mortgage | Creado el 01 feb 2006 Entregado el 04 feb 2006 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción L/H property k/a suite 7 salamanca square albert embankment london. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Mortgage deed | Creado el 12 feb 2003 Entregado el 21 feb 2003 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción The freehold property known as duxbury house 60 petty france victoria london SW1H 9EU title number NGL641010. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Deposit agreement to secure own liabilities | Creado el 24 abr 2002 Entregado el 08 may 2002 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción The deposit (as defined) and all such rights to the repayment thereof. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0