MARSH BROKERS LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | MARSH BROKERS LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 00149013 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | Sí |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de MARSH BROKERS LIMITED?
- Actividades de agentes y corredores de seguros (66220) / Actividades financieras y de seguros
¿Dónde se encuentra MARSH BROKERS LIMITED?
Dirección de la sede social | Devonshire House 60 Goswell Road EC1M 7AD London |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de MARSH BROKERS LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
HSBC INSURANCE BROKERS LIMITED | 01 jun 1999 | 01 jun 1999 |
HSBC GIBBS LIMITED | 02 ene 1996 | 02 ene 1996 |
GIBBS HARTLEY COOPER LIMITED | 01 ene 1984 | 01 ene 1984 |
GIBBS SAGE LIMITED | 01 ene 1982 | 01 ene 1982 |
ANTONY GIBBS, SAGE LIMITED | 31 dic 1976 | 31 dic 1976 |
LIONEL SAGE & CO.LIMITED | 29 nov 1917 | 29 nov 1917 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de MARSH BROKERS LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2019 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para MARSH BROKERS LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 10 páginas | LIQ13 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 20 oct 2021 | 11 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 1 Tower Place West London EC3R 5BU a Devonshire House 60 Goswell Road London EC1M 7AD el 09 dic 2020 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 3 páginas | 600 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 1 Tower Place West Tower Place London EC3R 5BU a 1 Tower Place West London EC3R 5BU el 30 nov 2020 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de solvencia | 7 páginas | LIQ01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2019 | 24 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Jane Victoria Barker como director el 24 jul 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 19 feb 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado a The St Botolph Building 138 Houndsditch London EC3A 7AW | 1 páginas | AD02 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2018 | 26 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 28 feb 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Peter John Box como director el 31 dic 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Sally Angela Helen Williams como director el 21 dic 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2017 | 24 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Mark Anthony Weil como director el 04 may 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 28 feb 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016 | 23 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 28 feb 2017 con actualizaciones | 6 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Adrianne Helen Marie Abbott como secretario el 08 feb 2017 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de Miss Claire Margaret Valentine como secretario el 08 feb 2017 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
Estado de capital el 07 dic 2016
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de MARSH BROKERS LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALENTINE, Claire Margaret | Secretario | 60 Goswell Road EC1M 7AD London Devonshire House | 224369930001 | |||||||
BAKER, Marcus Newton | Director | Tower Place West Tower Place EC3R 5BU London 1 United Kingdom | England | British | Managing Director | 136350420001 | ||||
CHESSHER, Mark Christopher | Director | Tower Place West Tower Place EC3R 5BU London 1 United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 164148230004 | ||||
ABBOTT, Adrianne Helen Marie | Secretario | Tower Place West Tower Place EC3R 5BU London 1 United Kingdom | 186925590001 | |||||||
BARKER, Nigel | Secretario | 7 Monoux Grove Walthamstow E17 5BS London | British | 5551730001 | ||||||
HARVEY, Peter James | Secretario | 82 Frankfurt Road SE24 9NY London | Other | Company Secretary | 67026460002 | |||||
HUDSON, Kate Elizabeth | Secretario | Level 14 8 Canada Square E14 5HQ London Hsbc United Kingdom | 146807700001 | |||||||
JENKINSON, Louisa Jane | Secretario | 80 Mysore Road Battersea SW11 5SA London | British | 61994950001 | ||||||
LEDSAM, Charles Edmund Royden | Secretario | 75 Ware Road SG13 7ED Hertford Hertfordshire | British | 8453110001 | ||||||
MCQUILLAN, Pauline Louise | Secretario | 8 Canada Square E14 5HQ London | British | 109247130002 | ||||||
NAHER, Polly | Secretario | Tower Place West Tower Place EC3R 5BU London 1 United Kingdom | British | 150623170001 | ||||||
AHLAS, Lars Peter Richard | Director | Pettys Farm Rectory Lane RH3 7BL Buckland Surrey | United Kingdom | Swedish | Insurance Broker | 24881600002 | ||||
ANDREWS, Gary John | Director | The Bradings Church Road, Hartley DA3 8DL Longfield Kent | England | British | Insurance Broker | 92530390001 | ||||
BANNISTER, Clive Christopher Roger | Director | 95 Clarendon Road W11 4JG London | England | British | Banker | 38206210004 | ||||
BARKER, Jane Victoria | Director | Tower Place West Tower Place EC3R 5BU London 1 United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 4552270004 | ||||
BARNETT, John Francis | Director | 15 William Covell Road EN2 8HP Enfield Middlesex | England | British | Insurance Broker | 24888390001 | ||||
BISHOP, Michael Edward | Director | Thorncroft Sunnydale Farnborough Park BR6 8AL Orpington Kent | British | Insurance Broker | 24685250002 | |||||
BONYNGE, Steven Richard | Director | Villa No. 113 Street 22 Jumeirah Mohammed Bakhit Villas United Arab Emirates | United Arab Emirates | British | Insurance Broker And Consultant | 133526960002 | ||||
BOOSEY, David John | Director | 13 Nelson Gardens SS6 8HD Rayleigh Essex | British | Insurance Broker | 102552410001 | |||||
BOX, Peter John | Director | Tower Place West Tower Place EC3R 5BU London 1 United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 146189110001 | ||||
BRIGHT, Robert Stewart | Director | 12 Grove Road HP9 1UP Beaconsfield Buckinghamshire | British | Insurance Broker | 24692350003 | |||||
BURR, Christopher James | Director | Rose Cottage Shop Lane, East Mersea CO5 8TR Colchester Essex | England | British | Accountant | 51653350007 | ||||
CAMERON, Angus Kenneth | Director | Tower Place West Tower Place EC3R 5BU London 1 United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 134082550001 | ||||
CARLILE, David Thomas | Director | 25 Alcester Road M33 3GW Sale Manchester | England | British | Company Director | 121839580001 | ||||
CAZEAUX, Paul Sebastian | Director | The Dolls House 166 Straight Road Old Windsor SL4 2SG Windsor Berkshire | England | British | Insurance Broker | 5580020001 | ||||
CLARKE, Ian | Director | Gayhurst Court Gayhurst MK16 8LG Newport Pagnell 26 Bucks | United Kingdom | British | Accountant | 127503340001 | ||||
COOK, Roger Walter | Director | 9 The Woodlands Brightlingsea CO7 0RY Colchester Essex | British | Insurance Broker | 24888400001 | |||||
CURRIE, William Graham | Director | 41 Gildale Werrington PE4 6QY Peterborough | British | Technical Services Director | 30233530002 | |||||
DICK, Andrew John | Director | Tower Place West Tower Place EC3R 5BU London 1 United Kingdom | United Kingdom | New Zealand | Chief Financial Officer | 155172330001 | ||||
DIXON, Andrew Michael Morley | Director | Southward 2 Upper Rose Hill RH4 2EB Dorking Surrey | Gb-Eng | British | Ceo Hsbc Insurance Brokers Ltd | 37045200003 | ||||
ELMS, Janet Ann | Director | 46 Reckitt Road Chiswick W4 2BT London | British | Human Resources | 36647680004 | |||||
EMMERSON, Stephen Colin Edward | Director | 1 Westcott Close Bickley BR1 2TU Bromley Kent | British | Company Director | 121839590001 | |||||
EVANS, John Stafford | Director | Manor Farmhouse East Kennett SN8 4EY Marlborough Wiltshire | British | Insurance Broker | 6554950001 | |||||
FAUX, Graham Alan | Director | The Limes East Hanningfield Road CM2 7TQ Chelmsford Essex | England | British | Chartered Accountant | 125907390001 | ||||
FISHMAN, Alan Seymour | Director | Sandalwood 1 The Sycamores WO7 7LJ Radlett Hertfordshire | British | Actuary | 38997140004 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de MARSH BROKERS LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mmc Uk Group Limited | 06 abr 2016 | Tower Place West Tower Place EC3R 5BU London 1 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene MARSH BROKERS LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Deed of variation made in addition to and modifying the security and trust deed dated 21ST september 1989 (the "principal deed") issued by the company | Creado el 14 oct 1999 Entregado el 29 oct 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada The payment of all costs, charges, expenses and other liabilities due or to become due from the company to the chargee under the terms of the security and trust deed (as modified); and the payments of all debts and obligations due or to become due from the company to the chargee in respect of insurance transactions | |
Breve descripción All monies (including brokerage) for the time being standing to the credit of or pursuant to the byelaw or otherwise required to be paid into an insurance broking account of the company.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Security & trust deed | Creado el 21 sept 1989 Entregado el 14 oct 1989 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Breve descripción All monies for the time being standing to the credit of or pursuant to lloyds brokers byelaw (no. 5 of 1988) (see 395 refm: 512 for full details). | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Trust deed | Creado el 24 feb 1983 Entregado el 04 mar 1983 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Breve descripción All that the company's right, title & interest in the monies standing, to the credit of the company's "c" account at the date of the trust deed & in the monies & investments at the date of the trust deed standing to the credit of or held in other iba accounts of the company from any scource. (See doc M189 for full details). | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
¿Tiene MARSH BROKERS LIMITED algún caso de insolvencia?
Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0