NCN 7 LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaNCN 7 LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00149576
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de NCN 7 LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra NCN 7 LIMITED?

    Dirección de la sede social
    2 Gregory Street
    SK14 4TH Hyde
    Cheshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de NCN 7 LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    PHILIP HARRIS EDUCATION AND SCIENTIFIC LIMITED06 ago 199306 ago 1993
    PHILIP HARRIS LIMITED07 mar 198707 mar 1987
    SCIENTIFIC SUPPLIES COMPANY LIMITED08 feb 191808 feb 1918

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de NCN 7 LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta29 mar 2013

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para NCN 7 LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para NCN 7 LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Cambio de datos del director Mr Timothy John Kowalski el 02 sept 2014

    2 páginasCH01

    Déclaration annuelle établie au 07 ago 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital28 ago 2014

    Estado de capital el 28 ago 2014

    • Capital: GBP 2,000
    SH01

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 29 mar 2013

    1 páginasAA

    Cese del nombramiento de Ivan Bolton como director

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 07 ago 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital07 ago 2013

    Estado de capital el 07 ago 2013

    • Capital: GBP 2,000
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 mar 2012

    1 páginasAA

    Certificado de cambio de nombre

    Company name changed philip harris education and scientific LIMITED\certificate issued on 08/08/12
    3 páginasCERTNM
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name08 ago 2012

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 27 jun 2012

    RES15
    change-of-name08 ago 2012

    Cambio de nombre por resolución

    NM01

    Déclaration annuelle établie au 07 ago 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cambio de datos del director Mr Timothy John Kowalski el 27 jul 2012

    2 páginasCH01

    Resoluciones

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Agreement 27/06/2012
    RES13

    Nombramiento de Mark Ashcroft como secretario

    2 páginasAP03

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 01 abr 2011

    1 páginasAA

    Cese del nombramiento de Ivan Bolton como secretario

    1 páginasTM02

    Déclaration annuelle établie au 07 ago 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Resoluciones

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Credit and supplemental agreement 08/02/2011
    RES13

    Domicilio social registrado cambiado de * Church Bridge House Henry Street Church Accrington Lancashire BB5 4EH* el 20 ene 2011

    1 páginasAD01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 02 abr 2010

    1 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 07 ago 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cese del nombramiento de un director

    1 páginasTM01

    Cambio de datos del secretario Dr Ivan Joseph Bolton el 07 ago 2010

    1 páginasCH03

    Nombramiento de Mr Timothy John Kowalski como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Christopher Hinton como director

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de NCN 7 LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    ASHCROFT, Mark
    Gregory Street
    SK14 4TH Hyde
    2
    Cheshire
    United Kingdom
    Secretario
    Gregory Street
    SK14 4TH Hyde
    2
    Cheshire
    United Kingdom
    165368580001
    KOWALSKI, Timothy John
    Gregory Street
    SK14 4TH Hyde
    2
    Cheshire
    England
    Director
    Gregory Street
    SK14 4TH Hyde
    2
    Cheshire
    England
    UkBritishDirector153335190003
    MAUDSLEY, Philip Binns
    Gregory Street
    SK14 4TH Hyde
    2
    Cheshire
    England
    Director
    Gregory Street
    SK14 4TH Hyde
    2
    Cheshire
    England
    United KingdomBritishCompany Director15967010001
    BOLTON, Ivan Joseph, Dr
    Gregory Street
    SK14 4TH Hyde
    2
    Cheshire
    England
    Secretario
    Gregory Street
    SK14 4TH Hyde
    2
    Cheshire
    England
    British14333000007
    DIGHTON, Simon Gerald
    28 Lightwoods Hill
    Bearwood
    B67 5EA Warley
    West Midlands
    Secretario
    28 Lightwoods Hill
    Bearwood
    B67 5EA Warley
    West Midlands
    BritishCompany Director78151560001
    PIGGOTT, Richard Courtney
    Church House
    Crown Street Harbury
    CV33 9HE Leamington Spa
    Warwickshire
    Secretario
    Church House
    Crown Street Harbury
    CV33 9HE Leamington Spa
    Warwickshire
    British112085820001
    TAYLOR, Frank Brownrigg
    Arden Lodge Station Lane
    Lapworth
    B94 6LT Solihull
    West Midlands
    Secretario
    Arden Lodge Station Lane
    Lapworth
    B94 6LT Solihull
    West Midlands
    British57228790001
    BOLTON, Ivan Joseph, Dr
    Gregory Street
    SK14 4TH Hyde
    2
    Cheshire
    England
    Director
    Gregory Street
    SK14 4TH Hyde
    2
    Cheshire
    England
    United KingdomBritishDirector14333000007
    CHAPMAN, Keith
    Flasby
    BD23 3PX Skipton
    Flasby Hall
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Director
    Flasby
    BD23 3PX Skipton
    Flasby Hall
    North Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector143093130001
    CHAPMAN, Richard Jonathan Edward
    Fir Trees Elloughton Dale
    Elloughton
    HU15 1QB Brough
    North Humberside
    Director
    Fir Trees Elloughton Dale
    Elloughton
    HU15 1QB Brough
    North Humberside
    BritishDivisional Scientific Sales Di14871980001
    DIGHTON, Simon Gerald
    28 Lightwoods Hill
    Bearwood
    B67 5EA Warley
    West Midlands
    Director
    28 Lightwoods Hill
    Bearwood
    B67 5EA Warley
    West Midlands
    United KingdomBritishCo Director78151560001
    EADEN, William George
    The Birches Main Road
    Anslow
    DE13 9QD Burton On Trent
    Staffordshire
    Director
    The Birches Main Road
    Anslow
    DE13 9QD Burton On Trent
    Staffordshire
    BritishDirector15637730001
    FISHER, Paul Howard
    32 Needwood Grange
    Abbots Bromley
    WS15 3AU Rugeley
    Staffordshire
    Director
    32 Needwood Grange
    Abbots Bromley
    WS15 3AU Rugeley
    Staffordshire
    BritishDirector15753610001
    FOLEY, William John
    12 Redfern Drive
    Hammerwich
    WS7 8TA Walsall
    West Midlands
    Director
    12 Redfern Drive
    Hammerwich
    WS7 8TA Walsall
    West Midlands
    BritishDirector2191830001
    FORGHAM, John Anthony
    15 Main Street
    Cranswick
    YO25 9QR Driffield
    North Humberside
    Director
    15 Main Street
    Cranswick
    YO25 9QR Driffield
    North Humberside
    BritishDirector33338170001
    HALLER, Bernard John Frederick
    54 Tudor Hill
    Sutton Coldfield
    B73 6BH Birmingham
    West Midlands
    Director
    54 Tudor Hill
    Sutton Coldfield
    B73 6BH Birmingham
    West Midlands
    BritishDirector49202520001
    HERRIOT, Peter Reid
    2 Trinity Mansions
    Atlantic Road
    BS23 2DQ Weston-Super-Mare
    Avon
    Director
    2 Trinity Mansions
    Atlantic Road
    BS23 2DQ Weston-Super-Mare
    Avon
    BritishDirector10050940001
    HINTON, Christopher David
    Henry Street
    Church
    BB5 4EH Accrington
    Church Bridge House
    Lancashire
    Director
    Henry Street
    Church
    BB5 4EH Accrington
    Church Bridge House
    Lancashire
    EnglandBritishDirector68474940001
    HINTON, Christopher David
    Henry Street
    Church
    BB5 4EH Accrington
    Church Bridge House
    Lancashire
    Director
    Henry Street
    Church
    BB5 4EH Accrington
    Church Bridge House
    Lancashire
    EnglandBritishDirector68474940001
    JOHNSON, Dvid Anthony
    Cold Knoll Farm
    Stanbury
    BD22 0HH Haworth
    West Yorkshire
    Director
    Cold Knoll Farm
    Stanbury
    BD22 0HH Haworth
    West Yorkshire
    BritishDirector76537490001
    LINNEY, David
    Lyndene Cottage Sytchampton
    DY13 9TA Stourport On Severn
    Worcestershire
    Director
    Lyndene Cottage Sytchampton
    DY13 9TA Stourport On Severn
    Worcestershire
    BritishDirector14695590001
    MACEY, David Charles
    Apartment Number 9 Bishops House
    42 Four Oaks Road
    B74 2UP Sutton Coldfield
    West Midlands
    Director
    Apartment Number 9 Bishops House
    42 Four Oaks Road
    B74 2UP Sutton Coldfield
    West Midlands
    EnglandBritishDirector91745430001
    NEWCOMBE, David Keith
    Middlecroft
    Bredons Norton
    GL20 7HB Tewkesbury
    Gloucestershire
    Director
    Middlecroft
    Bredons Norton
    GL20 7HB Tewkesbury
    Gloucestershire
    EnglandBritishDirector14695610001
    SHEPHERD, Brian
    22 Furlong Lane
    Alrewas
    DE13 7EE Burton On Trent
    Staffordshire
    Director
    22 Furlong Lane
    Alrewas
    DE13 7EE Burton On Trent
    Staffordshire
    BritishDirector14862820001
    STOYEL, Rodney
    Hambro House
    Treville Street Roehampton
    SW15 4JX London
    Director
    Hambro House
    Treville Street Roehampton
    SW15 4JX London
    BritishCompany Director81630780001
    WOOD, Stephen
    The Willows Oldmixon Road Hutton
    BS24 9QB Weston Super Mare
    Avon
    Director
    The Willows Oldmixon Road Hutton
    BS24 9QB Weston Super Mare
    Avon
    BritishDirector33636730001
    YOUNG, Robert Alan
    39 Leofric Close
    DE13 7JP Kings Bromley
    Staffordshire
    Director
    39 Leofric Close
    DE13 7JP Kings Bromley
    Staffordshire
    EnglandBritishDirector73770080001

    ¿Tiene NCN 7 LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Supplemental security agreement
    Creado el 28 jul 2010
    Entregado el 06 ago 2010
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    £204,038 inter-group loan agreeement.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 06 ago 2010Registro de un cargo (MG01)
    Deed of accession to the security agreement
    Creado el 16 jul 2010
    Entregado el 29 jul 2010
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery, investments, shares, credit balances, insurances, other contracts see image for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC (The Security Agent)
    Transacciones
    • 29 jul 2010Registro de un cargo (MG01)
    Debenture
    Creado el 31 jul 1986
    Entregado el 05 ago 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Including trade fixtures. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 05 ago 1986Registro de una carga
    • 17 feb 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0