NCN 7 LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | NCN 7 LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 00149576 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de NCN 7 LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra NCN 7 LIMITED?
Dirección de la sede social | 2 Gregory Street SK14 4TH Hyde Cheshire |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de NCN 7 LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
PHILIP HARRIS EDUCATION AND SCIENTIFIC LIMITED | 06 ago 1993 | 06 ago 1993 |
PHILIP HARRIS LIMITED | 07 mar 1987 | 07 mar 1987 |
SCIENTIFIC SUPPLIES COMPANY LIMITED | 08 feb 1918 | 08 feb 1918 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de NCN 7 LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 29 mar 2013 |
¿Cuál es el estado de la última declaración anual para NCN 7 LIMITED?
Declaración anual |
|
---|
¿Cuáles son las últimas presentaciones para NCN 7 LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Cambio de datos del director Mr Timothy John Kowalski el 02 sept 2014 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 07 ago 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 29 mar 2013 | 1 páginas | AA | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Ivan Bolton como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 07 ago 2013 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 mar 2012 | 1 páginas | AA | ||||||||||||||
Certificado de cambio de nombre Company name changed philip harris education and scientific LIMITED\certificate issued on 08/08/12 | 3 páginas | CERTNM | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 07 ago 2012 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||||||
Cambio de datos del director Mr Timothy John Kowalski el 27 jul 2012 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 3 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nombramiento de Mark Ashcroft como secretario | 2 páginas | AP03 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 01 abr 2011 | 1 páginas | AA | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Ivan Bolton como secretario | 1 páginas | TM02 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 07 ago 2011 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 3 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de * Church Bridge House Henry Street Church Accrington Lancashire BB5 4EH* el 20 ene 2011 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 02 abr 2010 | 1 páginas | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 07 ago 2010 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de un director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cambio de datos del secretario Dr Ivan Joseph Bolton el 07 ago 2010 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Timothy John Kowalski como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Christopher Hinton como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de NCN 7 LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASHCROFT, Mark | Secretario | Gregory Street SK14 4TH Hyde 2 Cheshire United Kingdom | 165368580001 | |||||||
KOWALSKI, Timothy John | Director | Gregory Street SK14 4TH Hyde 2 Cheshire England | Uk | British | Director | 153335190003 | ||||
MAUDSLEY, Philip Binns | Director | Gregory Street SK14 4TH Hyde 2 Cheshire England | United Kingdom | British | Company Director | 15967010001 | ||||
BOLTON, Ivan Joseph, Dr | Secretario | Gregory Street SK14 4TH Hyde 2 Cheshire England | British | 14333000007 | ||||||
DIGHTON, Simon Gerald | Secretario | 28 Lightwoods Hill Bearwood B67 5EA Warley West Midlands | British | Company Director | 78151560001 | |||||
PIGGOTT, Richard Courtney | Secretario | Church House Crown Street Harbury CV33 9HE Leamington Spa Warwickshire | British | 112085820001 | ||||||
TAYLOR, Frank Brownrigg | Secretario | Arden Lodge Station Lane Lapworth B94 6LT Solihull West Midlands | British | 57228790001 | ||||||
BOLTON, Ivan Joseph, Dr | Director | Gregory Street SK14 4TH Hyde 2 Cheshire England | United Kingdom | British | Director | 14333000007 | ||||
CHAPMAN, Keith | Director | Flasby BD23 3PX Skipton Flasby Hall North Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 143093130001 | ||||
CHAPMAN, Richard Jonathan Edward | Director | Fir Trees Elloughton Dale Elloughton HU15 1QB Brough North Humberside | British | Divisional Scientific Sales Di | 14871980001 | |||||
DIGHTON, Simon Gerald | Director | 28 Lightwoods Hill Bearwood B67 5EA Warley West Midlands | United Kingdom | British | Co Director | 78151560001 | ||||
EADEN, William George | Director | The Birches Main Road Anslow DE13 9QD Burton On Trent Staffordshire | British | Director | 15637730001 | |||||
FISHER, Paul Howard | Director | 32 Needwood Grange Abbots Bromley WS15 3AU Rugeley Staffordshire | British | Director | 15753610001 | |||||
FOLEY, William John | Director | 12 Redfern Drive Hammerwich WS7 8TA Walsall West Midlands | British | Director | 2191830001 | |||||
FORGHAM, John Anthony | Director | 15 Main Street Cranswick YO25 9QR Driffield North Humberside | British | Director | 33338170001 | |||||
HALLER, Bernard John Frederick | Director | 54 Tudor Hill Sutton Coldfield B73 6BH Birmingham West Midlands | British | Director | 49202520001 | |||||
HERRIOT, Peter Reid | Director | 2 Trinity Mansions Atlantic Road BS23 2DQ Weston-Super-Mare Avon | British | Director | 10050940001 | |||||
HINTON, Christopher David | Director | Henry Street Church BB5 4EH Accrington Church Bridge House Lancashire | England | British | Director | 68474940001 | ||||
HINTON, Christopher David | Director | Henry Street Church BB5 4EH Accrington Church Bridge House Lancashire | England | British | Director | 68474940001 | ||||
JOHNSON, Dvid Anthony | Director | Cold Knoll Farm Stanbury BD22 0HH Haworth West Yorkshire | British | Director | 76537490001 | |||||
LINNEY, David | Director | Lyndene Cottage Sytchampton DY13 9TA Stourport On Severn Worcestershire | British | Director | 14695590001 | |||||
MACEY, David Charles | Director | Apartment Number 9 Bishops House 42 Four Oaks Road B74 2UP Sutton Coldfield West Midlands | England | British | Director | 91745430001 | ||||
NEWCOMBE, David Keith | Director | Middlecroft Bredons Norton GL20 7HB Tewkesbury Gloucestershire | England | British | Director | 14695610001 | ||||
SHEPHERD, Brian | Director | 22 Furlong Lane Alrewas DE13 7EE Burton On Trent Staffordshire | British | Director | 14862820001 | |||||
STOYEL, Rodney | Director | Hambro House Treville Street Roehampton SW15 4JX London | British | Company Director | 81630780001 | |||||
WOOD, Stephen | Director | The Willows Oldmixon Road Hutton BS24 9QB Weston Super Mare Avon | British | Director | 33636730001 | |||||
YOUNG, Robert Alan | Director | 39 Leofric Close DE13 7JP Kings Bromley Staffordshire | England | British | Director | 73770080001 |
¿Tiene NCN 7 LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Supplemental security agreement | Creado el 28 jul 2010 Entregado el 06 ago 2010 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción £204,038 inter-group loan agreeement. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Deed of accession to the security agreement | Creado el 16 jul 2010 Entregado el 29 jul 2010 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery, investments, shares, credit balances, insurances, other contracts see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 31 jul 1986 Entregado el 05 ago 1986 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Including trade fixtures. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0