SIMPLE TOILETRIES LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | SIMPLE TOILETRIES LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 00154677 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | Sí |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de SIMPLE TOILETRIES LIMITED?
- Comercio al por mayor de perfumes y cosméticos (46450) / Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas
¿Dónde se encuentra SIMPLE TOILETRIES LIMITED?
Dirección de la sede social | 1 More London Place SE1 2AF London |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SIMPLE TOILETRIES LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
ACCANTIA TOILETRIES LIMITED | 10 jul 2000 | 10 jul 2000 |
SMITH & NEPHEW TOILETRIES LIMITED | 06 oct 1988 | 06 oct 1988 |
HINDERS LIMITED | 29 abr 1919 | 29 abr 1919 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de SIMPLE TOILETRIES LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2012 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para SIMPLE TOILETRIES LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 11 páginas | LIQ13 | ||||||||||
Destitución del liquidador por orden judicial | 10 páginas | LIQ10 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 2 páginas | 600 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 14 dic 2017 | 9 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 14 dic 2016 | 8 páginas | 4.68 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 1 páginas | 600 | ||||||||||
Orden judicial de insolvencia Court order insolvency:C.O. To remove/replace Liquidator | 11 páginas | LIQ MISC OC | ||||||||||
Aviso de cese de funciones como liquidador voluntario | 1 páginas | 4.40 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 1 páginas | 600 | ||||||||||
Orden judicial de insolvencia Court order INSOLVENCY:co to remove/replace liquidator | 13 páginas | LIQ MISC OC | ||||||||||
Aviso de cese de funciones como liquidador voluntario | 1 páginas | 4.40 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Julian Thurston como secretario el 23 feb 2016 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 14 dic 2015 | 8 páginas | 4.68 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Amarjit Kaur Conway como secretario el 31 dic 2015 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado a Unilever House 100 Victoria Embankment London EC4Y 0DY | 2 páginas | AD02 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Unilever House Springfield Drive Leatherhead KT22 7GR a 1 More London Place London SE1 2AF el 05 ene 2015 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de solvencia | 3 páginas | 4.70 | ||||||||||
Resolución de insolvencia Resolution INSOLVENCY:Special Resolution ;- "In Specie" | 1 páginas | LIQ MISC RES | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||
| ||||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 1 páginas | 600 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Paul David Logan el 02 dic 2014 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Judith Knox como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 abr 2014 avec liste complète des actionnaires | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nombramiento de Richard Clive Hazell como secretario | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de SIMPLE TOILETRIES LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAZELL, Richard Clive | Secretario | 100 Victoria Embankment EC4Y 0DY London Unilever House England England | 186167790001 | |||||||||||
LOGAN, Paul David | Director | Springfield Drive KT22 7GR Leatherhead Unilever House United Kingdom | England | British | Company Director | 154765460001 | ||||||||
MUNDEN, Timothy John | Director | 100 Victoria Embankment EC4Y 0DY London Unilever House United Kingdom | England | British | Vp Human Resources | 166934330001 | ||||||||
CONWAY, Amarjit Kaur | Secretario | 100 Victoria Embankment EC4Y 0DY London Unilever House England England | 183067140001 | |||||||||||
HATHERLY, Peter John | Secretario | 4th Floor Chadwick House Blenheim Court B91 2AA Solihull West Midlands | British | Accountant | 47843570005 | |||||||||
O'CONNOR, Michael John | Secretario | 5 The Brambles Walmley B76 1NF Sutton Coldfield West Midlands | British | 57132340001 | ||||||||||
OLLIS, David | Secretario | 43 Lowbrook Road Tidbury Green B90 1QR Solihull | British | 113470820001 | ||||||||||
THURSTON, Julian | Secretario | 100 Victoria Embankment EC4Y 0DY London Unilever House England England | 186167700001 | |||||||||||
THE NEW HOVEMA LIMITED | Secretario corporativo | 100 Victoria Embankment EC4Y 0DY London Unilever House United Kingdom |
| 162931070001 | ||||||||||
BALDI, Duccio | Director | 22 Hawkshead Drive Knowle B93 9QE Solihull West Midlands | British | Sales Director | 71508110001 | |||||||||
BRUCE, William James Martin, Mr. | Director | 100 Victoria Embankment EC4Y 0DY London Unilever House England England | England | British | Finance Director | 259195990001 | ||||||||
COUCH, David Richardson | Director | Hobnail Plough Road, Tibberton WR9 7NL Droitwich Worcestershire | British | Production & Tech. Director | 71508280001 | |||||||||
EVANS, Richard Jenkin | Director | Strand House Ford Lane Langley CV37 0HN Stratford Upon Avon Warwickshire | British | Company Director | 112249150001 | |||||||||
FRYER, Alan Richmond | Director | Hampton Barn Snitterfield Road CV35 8AU Hampton Lucy Warwickshire | British | Company Director | 9290001 | |||||||||
GREENE, John | Director | 244 Dower Road B75 6SU Sutton Coldfield West Midlands | British | Supply Chain Cit Director | 53833820002 | |||||||||
HALLIWELL, Martin Paul | Director | Hampshire International Business Park RG24 8ER Basingstoke Lime Tree Way Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | Executive,Personal Care Products Manufacturer | 110194090001 | ||||||||
HATHERLY, Peter John | Director | 4th Floor Chadwick House Blenheim Court B91 2AA Solihull West Midlands | England | British | Accountant | 47843570005 | ||||||||
KINDER, Eric | Director | Revishaw Simonstone Lane BB12 7PN Burnley Lancashire | British | Company Director | 9300001 | |||||||||
KNOX, Judith Amanda Sourry | Director | 100 Victoria Embankment EC4Y 0DY London Unilever House England England | United Kingdom | British | None | 151747620002 | ||||||||
MONAGHAN, Thomas | Director | Hampshire International Business Park RG24 8ER Basingstoke Lime Tree Way Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | Executive,Personal Care Products Manufacturer | 72615120002 | ||||||||
O'CONNOR, Michael John | Director | 5 The Brambles Walmley B76 1NF Sutton Coldfield West Midlands | British | Director | 57132340001 | |||||||||
PERCY, Geoffrey Michael | Director | 4th Floor Chadwick House Blenheim Court B91 2AA Solihull West Midlands | United Kingdom | British | Company Director | 33707480004 | ||||||||
POTTER, Iain Alexander | Director | 100 Victoria Embankment EC4Y 0DY London Unilever House England England | United Kingdom | British | Manager | 168733170001 | ||||||||
ROBINSON, John Harris | Director | 20 Mill Lane Elloughton HU15 1JL Brough East Yorkshire | England | British | Company Director | 77984900001 | ||||||||
SCHMIDT, Gary Peter | Director | Hampshire International Business Park RG24 8ER Basingstoke Lime Tree Way Hampshire United Kingdom | United States | American | Executive,Personal Care Products Manufacturer | 72615240001 | ||||||||
SIDDLE, Graham Henry | Director | 37 Broad Oaks Road B91 1JA Solihull West Midlands | British | Company Director | 21019380002 | |||||||||
SPRENT, David John | Director | Devon TQ9 6DN Harberton Dosley Barton England England | United Kingdom | British | Company Director | 242043620001 | ||||||||
WALTERS, Alan David | Director | 100 Victoria Embankment EC4Y 0DY London Unilever House England England | United Kingdom | British | Hr Director | 124268420002 |
¿Tiene SIMPLE TOILETRIES LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creado el 29 mar 2007 Entregado el 17 abr 2007 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from any member of the group to any security beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Supplemental deed to a debenture dated 21 november 2003 and | Creado el 22 ene 2004 Entregado el 06 feb 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from any member of the group to any security beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed charge all business intellectual property rights, all charged shares together with all related rights. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
A debenture dated 30TH june 2000 between the company, certain other UK resident companies specified therein and the security trustee (as defined) | Creado el 30 jun 2000 Entregado el 17 jul 2000 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company formerly known as smith & nephew toiletries limited to the chargee under or pursuant to a common terms agreement dated 28 june 2000, a £103,200,000 senior facilities agreement dated 28 june 2000, a £12,000,000 mezzanine facility agreement dated 28 june 2000, a wcf anciliary facilities letter dated 30 june 2000, a senior fee letter dated 28 june 2000, a mezzanine fee letter dated 28 june 2000, a compulsory hedging strategy letter dated 28 june 2000-07-18 | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
¿Tiene SIMPLE TOILETRIES LIMITED algún caso de insolvencia?
Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0