L.R.RUSSELL LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaL.R.RUSSELL LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00156981
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de L.R.RUSSELL LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra L.R.RUSSELL LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Wyevale Garden Centres Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Middlesex
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de L.R.RUSSELL LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta27 dic 2015

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para L.R.RUSSELL LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cese del nombramiento de Justin Matthew King como director el 31 oct 2016

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 27 dic 2015

    8 páginasAA

    Segunda presentación para la terminación de Nils Olin Steinmeyer como director

    4 páginasRP04TM01

    Segunda presentación para la terminación de Kevin Michael Bradshaw como director

    4 páginasRP04TM01

    Nombramiento de Mr Justin Matthew King como director el 18 ago 2016

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Stephen Thomas Murphy como director el 18 ago 2016

    1 páginasTM01

    Cambio de datos del director Mr Anthony Gerald Jones el 22 jul 2016

    2 páginasCH01

    Déclaration annuelle établie au 28 abr 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital18 may 2016

    Estado de capital el 18 may 2016

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Nombramiento de Mr Stephen Thomas Murphy como director el 06 abr 2016

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Roger Mclaughlan como director el 10 mar 2016

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Nils Olin Steinmeyer como director el 06 abr 2016

    2 páginasTM01
    Anotaciones
    FechaAnotación
    22 sept 2016Clarification A second filed TM01 was registered on 22/09/2016

    Nombramiento de Mr Anthony Gerald Jones como director el 06 abr 2016

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Kevin Michael Bradshaw como director el 10 mar 2016

    2 páginasTM01
    Anotaciones
    FechaAnotación
    22 sept 2016Clarification A second filed TM01 was registered on 22/09/2016.

    Domicilio social registrado cambiado de Wyevale Garden Centres Syon Park London Road Brentford Middlesex TW8 8JF a Wyevale Garden Centres Syon Park London Road Brentford Middlesex TW8 8JF el 23 feb 2016

    1 páginasAD01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 28 dic 2014

    8 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 28 abr 2015 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital22 may 2015

    Estado de capital el 22 may 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Domicilio social registrado cambiado de The Garden Centre Group Syon Park Brentford Middlesex TW8 8JF a Wyevale Garden Centres Syon Park London Road Brentford Middlesex TW8 8JF el 22 may 2015

    1 páginasAD01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 29 dic 2013

    8 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 28 abr 2014 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital19 may 2014

    Estado de capital el 19 may 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 dic 2012

    8 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 28 abr 2013 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01

    Nombramiento de Mr Kevin Michael Bradshaw como director

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de L.R.RUSSELL LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    JONES, Anthony Gerald
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Director
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    EnglandBritishCfo212265950001
    MCLAUGHLAN, Roger
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Director
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    EnglandBritishCeo206428840001
    FORREST, David Mervyn
    Clouds Farm
    Drayton
    TA10 0JT Langport
    Somerset
    Secretario
    Clouds Farm
    Drayton
    TA10 0JT Langport
    Somerset
    British50457500001
    JONES, Anthony David
    14 Brownhill Crescent
    LE7 7LA Rothley
    Leicestershire
    Secretario
    14 Brownhill Crescent
    LE7 7LA Rothley
    Leicestershire
    BritishChartered Accountant73622510001
    MURFIN, Stephen
    The Kymin
    Westhide
    HR1 3RG Hereford
    Herefordshire
    Secretario
    The Kymin
    Westhide
    HR1 3RG Hereford
    Herefordshire
    BritishCompany Director8690590001
    PEARCE, Patrick John
    Blue Cedars Bunces Lane
    Burghfield Common
    RG7 3DL Reading
    Berkshire
    Secretario
    Blue Cedars Bunces Lane
    Burghfield Common
    RG7 3DL Reading
    Berkshire
    British28975060001
    RATCLIFFE, Sarah Elizabeth
    59b Grange Road
    SM2 6SP Sutton
    Surrey
    Secretario
    59b Grange Road
    SM2 6SP Sutton
    Surrey
    BritishFinance Director76162020001
    SPENCER SMITH, Thomas Peter
    The Old Rectory
    Llanvetherine
    NP7 8RG Abergavenny
    Gwent
    Secretario
    The Old Rectory
    Llanvetherine
    NP7 8RG Abergavenny
    Gwent
    British1470160001
    BRADSHAW, Kevin Michael
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Director
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    EnglandBritishCompany Director124019940001
    BRIGDEN, Peter
    16 Woodstock Gardens
    Appleton
    WA4 5HN Warrington
    Cheshire
    Director
    16 Woodstock Gardens
    Appleton
    WA4 5HN Warrington
    Cheshire
    United KingdomBritishDirector Of Retail Operation195802400001
    CAUNCE, John Geoffrey
    16 Beaconsfield Road
    Claygate
    KT10 0PW Esher
    Surrey
    Director
    16 Beaconsfield Road
    Claygate
    KT10 0PW Esher
    Surrey
    BritishCompany Director1470170001
    FAVELL, Gary Alan
    Yates House Foldshaw Lane
    Braithwaite
    HG3 4AN Harrogate
    Yorks
    Director
    Yates House Foldshaw Lane
    Braithwaite
    HG3 4AN Harrogate
    Yorks
    United KingdomBritishChief Executive107699240001
    FORREST, David Mervyn
    Clouds Farm
    Drayton
    TA10 0JT Langport
    Somerset
    Director
    Clouds Farm
    Drayton
    TA10 0JT Langport
    Somerset
    BritishCompany Director50457500001
    HEWITT, Robert John
    The Old Cider Mill 2 Cotts Farm
    Cotts Lane
    HR1 3ND Lugwardine
    Herefordshire
    Director
    The Old Cider Mill 2 Cotts Farm
    Cotts Lane
    HR1 3ND Lugwardine
    Herefordshire
    United KingdomBritishCompany Director15486070002
    HODKINSON, James Clifford
    29b Western Avenue
    Branksome Park
    BH13 7AN Poole
    Dorset
    Director
    29b Western Avenue
    Branksome Park
    BH13 7AN Poole
    Dorset
    EnglandBritishCompany Director606430001
    JENKINSON, Antonia Scarlett
    Syon Park
    TW8 8JF Brentford
    The Garden Centre Group
    Middlesex
    England
    Director
    Syon Park
    TW8 8JF Brentford
    The Garden Centre Group
    Middlesex
    England
    United KingdomBritishInvestment Banker72128340003
    KING, Justin Matthew
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Director
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    United KingdomBritishDirector213157990001
    KOZLOWSKI, Richard Leon
    34 Stubbs Wood
    HP6 6EX Amersham
    Buckinghamshire
    Director
    34 Stubbs Wood
    HP6 6EX Amersham
    Buckinghamshire
    EnglandBritishDirector124967710001
    LIVINGSTON, William Andrew
    3 Barnes Close
    St Cross
    SO23 9QX Winchester
    Hampshire
    Director
    3 Barnes Close
    St Cross
    SO23 9QX Winchester
    Hampshire
    EnglandBritishCommercial Director111439220001
    MARSHALL, Nicholas Charles Gilmour
    Syon Park
    TW8 8JF Brentford
    The Garden Centre Group
    Middlesex
    England
    Director
    Syon Park
    TW8 8JF Brentford
    The Garden Centre Group
    Middlesex
    England
    WalesBritishCompany Director1470180001
    MARSHALL, Nicholas Charles Gilmour
    Glan Honddu House
    Llandefaelog Fach
    LD3 9PP Brecon
    Powys
    Director
    Glan Honddu House
    Llandefaelog Fach
    LD3 9PP Brecon
    Powys
    WalesBritishCompany Director1470180001
    MURFIN, Stephen
    The Kymin
    Westhide
    HR1 3RG Hereford
    Herefordshire
    Director
    The Kymin
    Westhide
    HR1 3RG Hereford
    Herefordshire
    BritishCompany Director8690590001
    MURPHY, Stephen Thomas
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Director
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    United KingdomBritishChairman207509410001
    PRICE, Glyn John
    Mill End
    Ash Ingen Mews Bridstow
    HR9 6QA Ross On Wye
    Herefordshire
    Director
    Mill End
    Ash Ingen Mews Bridstow
    HR9 6QA Ross On Wye
    Herefordshire
    United KingdomBritishCompany Director73470720001
    RATCLIFFE, Sarah Elizabeth
    59b Grange Road
    SM2 6SP Sutton
    Surrey
    Director
    59b Grange Road
    SM2 6SP Sutton
    Surrey
    EnglandBritishFinance Director76162020001
    SPENCER SMITH, Thomas Peter
    The Old Rectory
    Llanvetherine
    NP7 8RG Abergavenny
    Gwent
    Director
    The Old Rectory
    Llanvetherine
    NP7 8RG Abergavenny
    Gwent
    BritishCompany Director1470160001
    STEINMEYER, Nils Olin
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Director
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    United KingdomGermanFinancial Director126422100002
    STEVENSON, Barry John
    Cherry Trees
    Cane End
    RG4 9HG Reading
    Berkshire
    Director
    Cherry Trees
    Cane End
    RG4 9HG Reading
    Berkshire
    EnglandBritishCompany Director102595670001
    VAUGHAN, David John
    Bryn Cain
    Penpergwm
    NP7 9AE Abergavenny
    Gwent
    Director
    Bryn Cain
    Penpergwm
    NP7 9AE Abergavenny
    Gwent
    United KingdomBritishSolicitor44521810001

    ¿Tiene L.R.RUSSELL LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Security agreement
    Creado el 24 feb 2009
    Entregado el 04 mar 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All of its mortgaged property,investments,plant and machinery,credit balances see image for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC (The “Security Agent”)
    Transacciones
    • 04 mar 2009Registro de un cargo (395)
    • 04 may 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Legal mortgage
    Creado el 13 ene 1995
    Entregado el 26 ene 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property descrided as land on the north west side of london road windlesham surrey t/n SY252220 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 26 ene 1995Registro de un cargo (395)
    • 12 abr 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 13 ene 1995
    Entregado el 25 ene 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property described as lavershot court north west side of london road windlesham surrey and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 25 ene 1995Registro de un cargo (395)
    • 12 abr 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 13 ene 1995
    Entregado el 25 ene 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property described as land adjoining lavershot hall on the north west side of london road windlesham surrey and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 25 ene 1995Registro de un cargo (395)
    • 12 abr 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 08 dic 1992
    Entregado el 23 dic 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H property k/a lavershot court on the north west side of london road (formerly k/a high road) windlesham surrey tog with fixed plant machinery and other fixtures title no SY252220 and the goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transacciones
    • 23 dic 1992Registro de un cargo (395)
    • 12 abr 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Composite guarantee and mortgage debenture
    Creado el 08 dic 1992
    Entregado el 23 dic 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys due or to become due from the company to national westminster bank PLC as security trustee for itself and the secured parties (as defined) on any account whatsoever under the terms of the charge
    Breve descripción
    Please see doc M3 for further details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 23 dic 1992Registro de un cargo (395)
    • 12 abr 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 23 mar 1988
    Entregado el 05 abr 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or country gardens PLC to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land on north west side of london road windlesham, surrey heath, together with floating charge over all plant machinery & other fixtures (not being personal chattels within bills of sale acts 1878-1882) of the goodwill of the business.
    Personas con derecho
    • Hill Samuel & Co Limited.
    Transacciones
    • 05 abr 1988Registro de una carga
    • 30 nov 1991Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    Legal mortgage
    Creado el 23 mar 1988
    Entregado el 05 abr 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or country gardens PLC to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land on the north west side of london road windlesham and 1 & 2 homestead cottages london road, together with floating charge over all plant machinery & other fixtures (not being personal chattels within the bills of sale acts 1878-1882) and the goodwill of the business.
    Personas con derecho
    • Hill Samuel & Co Limited
    Transacciones
    • 05 abr 1988Registro de una carga
    • 30 nov 1991Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge
    Creado el 29 sept 1982
    Entregado el 11 oct 1982
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H richmond nurseries london road, windlesham, surrey title no sy 252220.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 11 oct 1982Registro de una carga
    • 12 abr 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 12 mar 1980
    Entregado el 26 mar 1980
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land on N.W. side of london road, windlesham, surrey tog with land on the N.W. side of the basingstoke to staines road, windlesham surrey. Title nos: sy 252220 sy 220671.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 26 mar 1980Registro de una carga
    Debenture
    Creado el 27 nov 1972
    Entregado el 14 dic 1972
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets and present and future including goodwill uncalled capital by way of first fixed & floating charge. See doc 99.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 14 dic 1972Registro de una carga
    • 12 abr 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Inst of charge
    Creado el 16 feb 1959
    Entregado el 04 mar 1959
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys due etc.
    Breve descripción
    Land in parish of windlesham surrey, on n/w side of load leading from basingstoke to staines formerly forming part of property comprised in title no sy 208127 known as elsinore estate.
    Personas con derecho
    • Westminster Bank LTD
    Transacciones
    • 04 mar 1959Registro de una carga
    • 12 abr 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Series of debentures
    Creado el 16 abr 1936
    Entregado el 16 abr 1936
    Satisfecho en su totalidad
    Transacciones
    • 16 abr 1936Registro de una carga
    • 12 abr 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0