TRONOX PIGMENT UK LIMITED

TRONOX PIGMENT UK LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTRONOX PIGMENT UK LIMITED
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00162303
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de TRONOX PIGMENT UK LIMITED?

    • fabricación de tintes y pigmentos (20120) / Industrias manufactureras

    ¿Dónde se encuentra TRONOX PIGMENT UK LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Laporte Road
    Stallingborough
    DN40 2PR Grimsby
    North East Lincolnshire
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TRONOX PIGMENT UK LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    CRISTAL PIGMENT UK LIMITED20 sept 201220 sept 2012
    MILLENNIUM INORGANIC CHEMICALS LIMITED06 mar 199706 mar 1997
    SCM CHEMICALS LIMITED04 sept 198404 sept 1984
    HOWARDS & SONS,LIMITED01 ene 192001 ene 1920

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de TRONOX PIGMENT UK LIMITED?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 dic 2024
    Próximas cuentas vencen el30 sept 2025
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2023

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para TRONOX PIGMENT UK LIMITED?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta20 jun 2025
    Próxima declaración de confirmación vence04 jul 2025
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta20 jun 2024
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para TRONOX PIGMENT UK LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2023

    57 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 20 jun 2024 con actualizaciones

    3 páginasCS01

    Declaración de confirmación presentada el 20 mar 2024 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2022

    59 páginasAA

    Cancelación total de la carga 001623030011

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 001623030017

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 001623030016

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 001623030015

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 001623030012

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 001623030013

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 001623030014

    1 páginasMR04

    Registro de la carga 001623030018, creada el 07 jun 2023

    25 páginasMR01

    Registro de la carga 001623030019, creada el 07 jun 2023

    34 páginasMR01

    Declaración de confirmación presentada el 20 mar 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Paul Andrew Hannington Barnett como director el 10 ene 2023

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Stephen Anthony Box como director el 10 ene 2023

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2021

    57 páginasAA

    Nombramiento de Mr Machiel Kristen Keegel como director el 01 jun 2022

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 20 mar 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2020

    59 páginasAA

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado a 54 Portland Place London W1B 1DY

    1 páginasAD02

    Nombramiento de Broughton Secretaries Limited como secretario el 29 abr 2021

    2 páginasAP04

    Cese del nombramiento de Intertrust (Uk) Limited como secretario el 29 abr 2021

    1 páginasTM02

    Declaración de confirmación presentada el 20 mar 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Registro de la carga 001623030016, creada el 31 mar 2021

    27 páginasMR01

    ¿Quiénes son los directivos de TRONOX PIGMENT UK LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BROUGHTON SECRETARIES LIMITED
    Portland Place
    W1B 1DY London
    54
    England
    Secretario corporativo
    Portland Place
    W1B 1DY London
    54
    England
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registro04569914
    86181860001
    BARNETT, Paul Andrew Hannington
    Stallingborough
    DN40 2PR Grimsby
    Laporte Road
    North East Lincolnshire
    England
    Director
    Stallingborough
    DN40 2PR Grimsby
    Laporte Road
    North East Lincolnshire
    England
    EnglandEnglishAccountant304080950001
    FODOR, Shirley
    Stallingborough
    DN40 2PR Grimsby
    Laporte Road
    North East Lincolnshire
    England
    Director
    Stallingborough
    DN40 2PR Grimsby
    Laporte Road
    North East Lincolnshire
    England
    South AfricaSouth AfricanGeneral Counsel275639510001
    KAYE, Steven Andrew
    Stallingborough
    DN40 2PR Grimsby
    Laporte Road
    North East Lincolnshire
    England
    Director
    Stallingborough
    DN40 2PR Grimsby
    Laporte Road
    North East Lincolnshire
    England
    United StatesAmericanDirector237611780001
    KEEGEL, Machiel Kristen
    Stallingborough
    DN40 2PR Grimsby
    Laporte Road
    North East Lincolnshire
    England
    Director
    Stallingborough
    DN40 2PR Grimsby
    Laporte Road
    North East Lincolnshire
    England
    NetherlandsDutchManaging Director297951870001
    BARNETT, Paul Andrew Hannington
    Stallingborough
    DN40 2PR Grimsby
    Laporte Road
    North East Lincolnshire
    England
    Secretario
    Stallingborough
    DN40 2PR Grimsby
    Laporte Road
    North East Lincolnshire
    England
    British162525310001
    CAMPBELL, Nicola
    4 The Coppice School Lane
    HP9 2SH Seer Green
    Buckinghamshire
    Secretario
    4 The Coppice School Lane
    HP9 2SH Seer Green
    Buckinghamshire
    BritishSenior European Counsel104418770001
    CAMPBELL, Nicola
    4 The Coppice School Lane
    HP9 2SH Seer Green
    Buckinghamshire
    Secretario
    4 The Coppice School Lane
    HP9 2SH Seer Green
    Buckinghamshire
    BritishSenior European Counsel104418770001
    FURLING, Jean Herve
    23 Rue Du Haut Point
    Riedisheim
    68400
    France
    Secretario
    23 Rue Du Haut Point
    Riedisheim
    68400
    France
    France69664070003
    FURLING, Jean-Herve Gustave
    Stallingborough
    DN40 2PR Grimsby
    Laporte Road
    North East Lincolnshire
    England
    Secretario
    Stallingborough
    DN40 2PR Grimsby
    Laporte Road
    North East Lincolnshire
    England
    British169878660001
    FURLING, Jean-Herve Gustave
    Stallingborough
    DN40 2PR Grimsby
    Laporte Road
    North East Lincolnshire
    England
    Secretario
    Stallingborough
    DN40 2PR Grimsby
    Laporte Road
    North East Lincolnshire
    England
    FrenchLegal Counsel127752720001
    HARDJOMOHAMAD, Nancy Julianie Fatima
    Claes De Vrieselaan 131 A
    FOREIGN 3021 Jj
    Rotterdam
    The Netherlands
    Secretario
    Claes De Vrieselaan 131 A
    FOREIGN 3021 Jj
    Rotterdam
    The Netherlands
    DutchEuropean Corporate Secretary109911890001
    HERRING, George William
    Carramore
    Church Hill
    DN38 6JL Barnetby
    North Lincolnshire
    Secretario
    Carramore
    Church Hill
    DN38 6JL Barnetby
    North Lincolnshire
    British85983960001
    JEGHER, Maria
    Great St. Helen's
    EC3A 6AP London
    35
    Secretario
    Great St. Helen's
    EC3A 6AP London
    35
    250522440001
    THOMAS, David Kenneth
    Edinburgh Drive
    Holton Le Clay
    DN36 5DG Grimsby
    32
    England
    Secretario
    Edinburgh Drive
    Holton Le Clay
    DN36 5DG Grimsby
    32
    England
    British138299630001
    WARD, Stephen
    41 Marapana Road
    6015 City Beach
    Australia
    Secretario
    41 Marapana Road
    6015 City Beach
    Australia
    AustralianBusinessman122389150001
    INTERTRUST (UK) LIMITED
    Great St. Helen's
    EC3A 6AP London
    35
    England
    Secretario corporativo
    Great St. Helen's
    EC3A 6AP London
    35
    England
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registro06307550
    188126550001
    ABBOTT, Donald
    903 Hillstead Drive
    Lutherville
    Maryland 21093
    Usa
    Director
    903 Hillstead Drive
    Lutherville
    Maryland 21093
    Usa
    AmericanVp Millennium Chemicals Inc26577100001
    ALEXANDER, Samuel Ray
    Stallingborough
    DN40 2PR Grimsby
    Laporte Road
    North East Lincolnshire
    England
    Director
    Stallingborough
    DN40 2PR Grimsby
    Laporte Road
    North East Lincolnshire
    England
    UsaAmericanBusinessman120943450001
    ANDERSON, Thomas
    The Old School House
    Manton
    DN21 4JT Gainsborough
    Lincolnshire
    Director
    The Old School House
    Manton
    DN21 4JT Gainsborough
    Lincolnshire
    AmericanSite Director77574270001
    BARNETT, Paul Andrew Hannington
    Stallingborough
    DN40 2PR Grimsby
    Laporte Road
    North East Lincolnshire
    Director
    Stallingborough
    DN40 2PR Grimsby
    Laporte Road
    North East Lincolnshire
    EnglandEnglishAccountant304080950001
    BEACH, Anthony John
    19 Meadow Drive
    Healing
    DN37 7RU Grimsby
    North East Lincolnshire
    Director
    19 Meadow Drive
    Healing
    DN37 7RU Grimsby
    North East Lincolnshire
    EnglandBritishDirector Of Project Engineerin153413600001
    BEARD, John
    Wassenaarseweg 12
    2596 Ch Den Haag
    FOREIGN The Netherlands
    Director
    Wassenaarseweg 12
    2596 Ch Den Haag
    FOREIGN The Netherlands
    AmericanSenior Vice President104420580001
    BORST, Donald
    12 Glen Lyon Court
    Phoenix
    Maryland 21131
    Usa
    Director
    12 Glen Lyon Court
    Phoenix
    Maryland 21131
    Usa
    AmericanPresident And Ceo26577090001
    BOX, Stephen Anthony
    Stallingborough
    DN40 2PR Grimsby
    Laporte Road
    North East Lincolnshire
    England
    Director
    Stallingborough
    DN40 2PR Grimsby
    Laporte Road
    North East Lincolnshire
    England
    EnglandBritishFinancial Controller127739900007
    BOX, Stephen Anthony
    34 Links Road
    DN35 0HX Cleethorpes
    North East Lincolnshire
    Director
    34 Links Road
    DN35 0HX Cleethorpes
    North East Lincolnshire
    EnglandBritishFinance Manager127739900007
    BRESLOW, Stuart
    6452 Sundown Trail
    21044 Columbia
    Maryland
    Usa
    Director
    6452 Sundown Trail
    21044 Columbia
    Maryland
    Usa
    AmericanAttorney66513240001
    CARLSON, Timothy Craig
    Stallingborough
    DN40 2PR Grimsby
    Laporte Road
    North East Lincolnshire
    England
    Director
    Stallingborough
    DN40 2PR Grimsby
    Laporte Road
    North East Lincolnshire
    England
    United StatesAmericanDirector237611750001
    CARMEAN, William
    121 East Delaware Avenue
    FOREIGN Pennington
    New Jersey 80534
    Usa
    Director
    121 East Delaware Avenue
    FOREIGN Pennington
    New Jersey 80534
    Usa
    AmericanAttorney At Law77516290001
    CIAN FICHI, Gary Louis
    8 Halbright Court
    Timonium
    21093
    Usa
    Director
    8 Halbright Court
    Timonium
    21093
    Usa
    AmericanVice President Marketing & Sal105326780001
    DOCX, Koen Felix Lodewijk
    Great St. Helen's
    EC3A 6AP London
    35
    Director
    Great St. Helen's
    EC3A 6AP London
    35
    BelgiumBelgianFinance Manager162523910004
    ESLER, Stuart Donald
    10 Welholme Road
    DN32 0DU Grimsby
    North East Lincolnshire
    Director
    10 Welholme Road
    DN32 0DU Grimsby
    North East Lincolnshire
    BritishSales And Marketing Director26577120001
    ESLER, Stuart Donald
    10 Welholme Road
    DN32 0DU Grimsby
    North East Lincolnshire
    Director
    10 Welholme Road
    DN32 0DU Grimsby
    North East Lincolnshire
    BritishSales And Marketing Director26577120001
    EVANS, David Geoffrey
    Stallingborough
    DN40 2PR Grimsby
    Laporte Road
    North East Lincolnshire
    England
    Director
    Stallingborough
    DN40 2PR Grimsby
    Laporte Road
    North East Lincolnshire
    England
    BelgiumBritishVp Human Resources148979580001
    FRIEDMAN, Samuel
    11111 Hidden Trail Drive
    Owings Mills
    Maryland 21117
    Usa
    Director
    11111 Hidden Trail Drive
    Owings Mills
    Maryland 21117
    Usa
    AmericanVice President And General Cou26577140001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de TRONOX PIGMENT UK LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Laporte Road
    Stallingbourough
    DN40 2PR Grimsby
    United Kingdom
    25 may 2018
    Laporte Road
    Stallingbourough
    DN40 2PR Grimsby
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaPrivate Unlimited Company
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalEngland And Wales
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro02362264
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.
    Laporte Road
    DN40 2PR Stallingborough
    Cristal Pigment Uk Limited
    England
    27 sept 2016
    Laporte Road
    DN40 2PR Stallingborough
    Cristal Pigment Uk Limited
    England
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalIncorporated In England And Wales
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro03095524
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene TRONOX PIGMENT UK LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 07 jun 2023
    Entregado el 07 jun 2023
    Pendiente
    Breve descripción
    None.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Emirates Nbd Bank (P.J.S.C), London Branch
    Transacciones
    • 07 jun 2023Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 07 jun 2023
    Entregado el 07 jun 2023
    Pendiente
    Breve descripción
    None.
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Emirates Nbd Bank (P.J.S.C), London Branch
    Transacciones
    • 07 jun 2023Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 31 mar 2021
    Entregado el 08 abr 2021
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    None.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Emirates Nbd Bank (P.J.S.C), London Branch
    Transacciones
    • 08 abr 2021Registro de una carga (MR01)
    • 08 jun 2023Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 31 mar 2021
    Entregado el 08 abr 2021
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    None.
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Emirates Nbd Bank (P.J.S.C), London Branch
    Transacciones
    • 08 abr 2021Registro de una carga (MR01)
    • 08 jun 2023Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 09 jul 2019
    Entregado el 16 jul 2019
    Satisfecho en su totalidad
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Emirates Nbd Bank (P.J.S.C), London Branch
    Transacciones
    • 16 jul 2019Registro de una carga (MR01)
    • 08 jun 2023Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 15 jul 2015
    Entregado el 21 jul 2015
    Satisfecho en su totalidad
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Emirates Bank Nbd Pjsc, London Branch
    Transacciones
    • 21 jul 2015Registro de una carga (MR01)
    • 08 jun 2023Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 15 jul 2015
    Entregado el 21 jul 2015
    Satisfecho en su totalidad
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Emirates Bank Nbd Pjsc, London Branch
    Transacciones
    • 21 jul 2015Registro de una carga (MR01)
    • 08 jun 2023Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 30 jun 2015
    Entregado el 10 jul 2015
    Satisfecho en su totalidad
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Emirates Bank Nbd Pjsc, London Branch
    Transacciones
    • 10 jul 2015Registro de una carga (MR01)
    • 08 jun 2023Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 30 jun 2015
    Entregado el 10 jul 2015
    Satisfecho en su totalidad
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Emirates Bank Nbd Pjsc, London Branch
    Transacciones
    • 10 jul 2015Registro de una carga (MR01)
    • 08 jun 2023Satisfacción de una carga (MR04)
    A second lien mortgage
    Creado el 15 may 2007
    Entregado el 31 may 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The mortgaged property being laporte road stallingborough grimsby t/no hs 301319. lease of part of the land at laporte road stallingborough grimsby (t/no HS301319) dated 20 october 1993. lease of part of the land at laporte road stallingborough grimsby (t/no HS301319) dated 17 march 1994. for details of further property charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank Usa, National Association as Administrative Agent for the Secured Parties (The Secondlien Administrative Agent)
    Transacciones
    • 31 may 2007Registro de un cargo (395)
    • 19 mar 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    A first lien mortgage
    Creado el 15 may 2007
    Entregado el 31 may 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The mortgaged property being laporte road stallingborough grimsby t/no hs 301319. lease of part of the land at laporte road stallingborough grimsby (t/no HS301319) dated 20 october 1993. lease of part of the land at laporte road stallingborough grimsby (t/no HS301319) dated 17 march 1994. for details of further property charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank Usa, National Association as Administrative Agent for the Secured Parties (The Firstlien Administrative Agent)
    Transacciones
    • 31 may 2007Registro de un cargo (395)
    • 19 mar 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    A second lien debenture
    Creado el 15 may 2007
    Entregado el 31 may 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of first fixed charge the real property, the accounts, the intellectual P. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank Usa, National Association as Administrative Agent for the Secured Parties (The Secondlien Administrative Agent)
    Transacciones
    • 31 may 2007Registro de un cargo (395)
    • 19 mar 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    A first lien debenture
    Creado el 15 may 2007
    Entregado el 31 may 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of first fixed charge the real property, the accounts, the intellectual property, any goodwill, uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank Usa, National Association as Administrative Agent for the Secured Parties (The Firstlien Administrative Agent)
    Transacciones
    • 31 may 2007Registro de un cargo (395)
    • 19 mar 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Bank account pledge agreement
    Creado el 13 mar 2006
    Entregado el 24 mar 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the beneficiaries (or to one of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The credit balance at any time of the pledged account including all interest and ancilliary rights deriving from the pledged account,. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of America, National Association (Agent)
    Transacciones
    • 24 mar 2006Registro de un cargo (395)
    • 18 may 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Account pledge agreement
    Creado el 20 feb 2006
    Entregado el 06 mar 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    (A) all present and future credit balances, including without limitation any daily current account balance and any balancing of accounts, including all interest payable, from time to time standing to the credit of the collection account: (b) all savings bonds, including all interest payable, associated with the collection account which are pledged by the chargor surrendering the relevant deeds and documents. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of America, National Association
    Transacciones
    • 06 mar 2006Registro de un cargo (395)
    • 18 may 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Pledge agreement
    Creado el 20 feb 2006
    Entregado el 06 mar 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge not exceeding 66,000,000 euros
    Breve descripción
    The chargor granted a pledge over all its rights relating to the account opened in the name of the chargor: bank account no. 0007031792 abi 03595, cab 32460, iban IT80G0359532460000007031792 held with fortis bank (the "bank account") as well as all sums from time to time standing to the credit of the bank account held in the name of the chargor. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of America, National Association
    Transacciones
    • 06 mar 2006Registro de un cargo (395)
    • 18 may 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of disclosed pledge
    Creado el 31 ene 2006
    Entregado el 17 feb 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    A first ranking right of disclosed pledge over any and all present and future clains or rights. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of America National Association
    Transacciones
    • 17 feb 2006Registro de un cargo (395)
    • 18 may 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    An inventory and non-vesting debts charge
    Creado el 31 ene 2006
    Entregado el 15 feb 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    First floating charge all present and future inventory,all present and future related intellectual property and all present and future non-vesting receivables and the ancillary rights. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of America, National Association
    Transacciones
    • 15 feb 2006Registro de un cargo (395)
    • 18 may 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Bank account pledge agreement
    Creado el 31 ene 2006
    Entregado el 15 feb 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Right, title and interest in respect of the account being account number 0167-0222-30-3043031001 (iban code: ES2301670222303043031001). See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of America, National Association
    Transacciones
    • 15 feb 2006Registro de un cargo (395)
    • 18 may 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0