NATIONWIDE ACCIDENT REPAIR CENTRES LIMITED

NATIONWIDE ACCIDENT REPAIR CENTRES LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaNATIONWIDE ACCIDENT REPAIR CENTRES LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00163614
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de NATIONWIDE ACCIDENT REPAIR CENTRES LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra NATIONWIDE ACCIDENT REPAIR CENTRES LIMITED?

    Dirección de la sede social
    17a Thorney Leys Park
    Witney
    OX28 4GE Oxfordshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de NATIONWIDE ACCIDENT REPAIR CENTRES LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    PERRY GROUP QUEST TRUSTEES LIMITED14 jul 199714 jul 1997
    ROCAR (GAINSBOROUGH) LIMITED31 dic 197931 dic 1979
    BAINES BROS.,LIMITED03 feb 192003 feb 1920

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de NATIONWIDE ACCIDENT REPAIR CENTRES LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2018

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para NATIONWIDE ACCIDENT REPAIR CENTRES LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 29 mar 2021

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Exercice comptable précédent raccourci du 31 dic 2019 au 30 dic 2019

    1 páginasAA01

    Cese del nombramiento de David Richard Pugh como director el 17 jul 2020

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 02 ene 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cessation de David Richard Pugh en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 ene 2019

    1 páginasPSC07

    Notification de Nationwide Accident Repair Services Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 ene 2019

    2 páginasPSC02

    Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 dic 2018

    2 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 02 ene 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Declaración de confirmación presentada el 02 ene 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 dic 2017

    2 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 10 abr 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 dic 2016

    2 páginasAA

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2015

    3 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 10 abr 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital14 abr 2016

    Estado de capital el 14 abr 2016

    • Capital: GBP 12,192
    SH01

    Déclaration annuelle établie au 10 abr 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital10 abr 2015

    Estado de capital el 10 abr 2015

    • Capital: GBP 12,192
    SH01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2014

    3 páginasAA

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2013

    3 páginasAA

    Cambio de datos del director Mr Michael Alfred Wilmshurst el 12 sept 2014

    2 páginasCH01

    Déclaration annuelle établie au 14 may 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital28 may 2014

    Estado de capital el 28 may 2014

    • Capital: GBP 12,192
    SH01

    ¿Quiénes son los directivos de NATIONWIDE ACCIDENT REPAIR CENTRES LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    WILMSHURST, Michael Alfred
    17a Thorney Leys Park
    Witney
    OX28 4GE Oxfordshire
    Director
    17a Thorney Leys Park
    Witney
    OX28 4GE Oxfordshire
    EnglandBritish82302420002
    HICKMAN-ASHBY, Martin James
    7 High Elms Close
    HA6 2DG Northwood
    Middlesex
    Secretario
    7 High Elms Close
    HA6 2DG Northwood
    Middlesex
    British1841480001
    ALLAN, Richard Ronald
    Mornington House 1 High Trees
    CM4 9DQ Stock
    Essex
    Director
    Mornington House 1 High Trees
    CM4 9DQ Stock
    Essex
    United KingdomBritish1841490001
    HICKMAN-ASHBY, Martin James
    7 High Elms Close
    HA6 2DG Northwood
    Middlesex
    Director
    7 High Elms Close
    HA6 2DG Northwood
    Middlesex
    EnglandBritish1841480001
    HOGG, David John
    Parklands Hall
    Church Hill, Middleton On The Wolds
    YO25 9UG Driffield
    East Yorkshire
    Director
    Parklands Hall
    Church Hill, Middleton On The Wolds
    YO25 9UG Driffield
    East Yorkshire
    British113013220001
    JAY, Peter Harry
    Fetter Lane
    EC4A 1BN London
    100
    Director
    Fetter Lane
    EC4A 1BN London
    100
    United KingdomBritish34963720001
    LANE, Martin William
    Churchfields 6 New Road
    Great Chishill
    SG8 8ST Royston
    Hertfordshire
    Director
    Churchfields 6 New Road
    Great Chishill
    SG8 8ST Royston
    Hertfordshire
    British1841500001
    PUGH, David Richard
    17a Thorney Leys Park
    Witney
    OX28 4GE Oxfordshire
    Director
    17a Thorney Leys Park
    Witney
    OX28 4GE Oxfordshire
    EnglandBritish108788360001
    TURNER, Lesley Bridget
    68 Grovedale Close
    EN7 5NE Cheshunt
    Herts
    Director
    68 Grovedale Close
    EN7 5NE Cheshunt
    Herts
    British1762570003

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de NATIONWIDE ACCIDENT REPAIR CENTRES LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Nationwide Accident Repair Services Ltd
    Thorney Leys Park
    OX28 4GE Witney
    17
    England
    01 ene 2019
    Thorney Leys Park
    OX28 4GE Witney
    17
    England
    No
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroEngland And Wales
    Número de registro966807
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    Mr David Richard Pugh
    17a Thorney Leys Park
    Witney
    OX28 4GE Oxfordshire
    06 abr 2016
    17a Thorney Leys Park
    Witney
    OX28 4GE Oxfordshire
    Nacionalidad: British
    País de residencia: England
    Naturaleza del control
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre la empresa.

    ¿Tiene NATIONWIDE ACCIDENT REPAIR CENTRES LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Fixed and floating charge
    Creado el 21 ene 1986
    Entregado el 24 ene 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A fixed charge on all book and other debts owing to the company floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital. Excluding (those mentioned above).
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 24 ene 1986Registro de una carga
    • 26 jun 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge
    Creado el 15 feb 1980
    Entregado el 25 feb 1980
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Floating charge on the undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts uncalled capital. (See doc M120 for details).
    Personas con derecho
    • Mercantile Credit Company LTD
    Transacciones
    • 25 feb 1980Registro de una carga
    Floating charge
    Creado el 19 jun 1978
    Entregado el 23 jun 1978
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Floating charge over the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • Midland Bank PLC
    Transacciones
    • 23 jun 1978Registro de una carga
    • 26 jun 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 04 may 1977
    Entregado el 17 may 1977
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    For securing sums not exceeding £15,000 which the chargee may be called upon to pay to the bank of new york under the terms of a guarantee dated 4TH may 1977 and all other monies due or to become due from the company to the chargee in connection with the property charged or business carried on thereat
    Breve descripción
    Land at situate at gainsborough, lincoln having a frontage to north street and church street, together with all buildings erected thereon.
    Personas con derecho
    • Texaco LTD
    Transacciones
    • 17 may 1977Registro de una carga
    • 26 jun 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 09 jul 1975
    Entregado el 16 jul 1975
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Property known as 1 works offices and show rooms, north street, gainsborough & dwellinghouse 32 & 34 north street gainsborough. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 16 jul 1975Registro de una carga
    • 26 jun 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 09 jul 1975
    Entregado el 16 jul 1975
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/Hold property known as house, fractory buildings and approximately 1689 sq yards land in all, wintern house and wintern works carlisle street, gainsborugh.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 16 jul 1975Registro de una carga
    Legal mortgage
    Creado el 09 jul 1975
    Entregado el 16 jul 1975
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    28 north street, gainsborough. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 16 jul 1975Registro de una carga
    • 26 jun 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 25 jul 1973
    Entregado el 08 ago 1973
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    Sums n/e £25,000 which the chargee may be called upon to pay to the bank of new york pursuant to a guarantee entered into by the chargee and any other monies due from the co. To the chargee in connection with property thereby charged on this business carried on.
    Breve descripción
    Land fronting to north street/church street gainsborough, lincs together with all buildings erected thereon.
    Personas con derecho
    • Texaco LTD.
    Transacciones
    • 08 ago 1973Registro de una carga
    • 26 jun 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0