TDG OVERSEAS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTDG OVERSEAS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00171035
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de TDG OVERSEAS LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra TDG OVERSEAS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Two Snowhill
    B4 6GA Birmingham
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TDG OVERSEAS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    TDG NORTHERN LIMITED02 nov 198702 nov 1987
    HARRIS-RELIANCE LIMITED26 ago 198626 ago 1986
    TDG NORTHERN LIMITED01 mar 198501 mar 1985
    FREIGHT TRANSPORT HOLDINGS LIMITED26 oct 192026 oct 1920

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de TDG OVERSEAS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2013

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para TDG OVERSEAS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 03 sept 2016

    7 páginas4.68

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    7 páginas4.71

    Domicilio social registrado cambiado de 125 Colmore Row Birmingham B3 3SD a Two Snowhill Birmingham B4 6GA el 03 ene 2016

    2 páginasAD01

    Domicilio social registrado cambiado de Xpo House Lodge Way New Duston Northampton NN5 7SL United Kingdom a 125 Colmore Row Birmingham B3 3SD el 22 sept 2015

    2 páginasAD01

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 04 sept 2015

    LRESSP

    Nombramiento de Mr Patrick Bataillard como director el 26 ago 2015

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Gaultier De La Rochebrochard como director el 25 ago 2015

    1 páginasTM01

    Domicilio social registrado cambiado de Norbert Dentressangle House Lodge Way New Duston Northampton NN5 7SL a Xpo House Lodge Way New Duston Northampton NN5 7SL el 26 jun 2015

    1 páginasAD01

    Déclaration annuelle établie au 08 may 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital10 may 2015

    Estado de capital el 10 may 2015

    • Capital: GBP 500,000
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013

    13 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 08 may 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital08 may 2014

    Estado de capital el 08 may 2014

    • Capital: GBP 500,000
    SH01

    Déclaration annuelle établie au 08 may 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2012

    16 páginasAA

    Cese del nombramiento de David Lynch como director

    2 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Francois Bertreau como director

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2011

    15 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 08 may 2012 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01

    Nombramiento de Ms Lyndsay Gillian Navid Lane como director

    3 páginasAP01

    Nombramiento de Gaultier De La Rochebrochard como director

    3 páginasAP01

    Resoluciones

    Resolutions
    27 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución del Memorándum de Asociación

    RES01

    Declaración de los objetos de la sociedad

    2 páginasCC04

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Section 175(5)(a) 01/12/2011
    RES13

    ¿Quiénes son los directivos de TDG OVERSEAS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    NAVID LANE, Lyndsay
    Lodge Way
    New Duston
    NN5 7SL Northampton
    Norbert Dentressangle House
    United Kingdom
    Secretario
    Lodge Way
    New Duston
    NN5 7SL Northampton
    Norbert Dentressangle House
    United Kingdom
    British163253090001
    BATAILLARD, Patrick
    Lodge Way
    New Duston
    NN5 7SL Northampton
    Xpo House
    Northamptonshire
    United Kingdom
    Director
    Lodge Way
    New Duston
    NN5 7SL Northampton
    Xpo House
    Northamptonshire
    United Kingdom
    FranceFrenchChief Financial Officer199314850001
    NAVID LANE, Lyndsay Gillian
    Lodge Way
    New Duston
    NN5 7SL Northampton
    Norbert Dentressangle House
    Uk
    Director
    Lodge Way
    New Duston
    NN5 7SL Northampton
    Norbert Dentressangle House
    Uk
    EnglandBritishSolicitor177674310001
    GRAYSTON, Robert
    Ambergayne The Paddock
    Heswall
    L60 1XJ Wirral
    Merseyside
    Secretario
    Ambergayne The Paddock
    Heswall
    L60 1XJ Wirral
    Merseyside
    British10092300001
    HUI, Carol
    GU8
    Secretario
    GU8
    British72371980001
    HUTCHINSON, Katherine Anna
    52 Pentney Road
    SW12 0NY London
    Secretario
    52 Pentney Road
    SW12 0NY London
    BritishCompany Secretary9289720002
    JONES, Matthew David Alexander
    24 Dalmally Road
    CR0 6LS Croydon
    Surrey
    Secretario
    24 Dalmally Road
    CR0 6LS Croydon
    Surrey
    British65657530001
    KINLEY, John
    The Birches
    South Park
    TN13 1EL Sevenoaks
    Kent
    Secretario
    The Birches
    South Park
    TN13 1EL Sevenoaks
    Kent
    British9811620001
    TSAPPIS, Neil John Alfred
    Burfield 85 Church Green Road
    Bletchley
    MK3 6DA Milton Keynes
    Secretario
    Burfield 85 Church Green Road
    Bletchley
    MK3 6DA Milton Keynes
    British49019640001
    MAWLAW SECRETARIES LIMITED
    Bishopsgate
    EC2M 3AF London
    201
    Secretario corporativo
    Bishopsgate
    EC2M 3AF London
    201
    39182980003
    TDG SECRETARIES LIMITED
    Tdg Headquarters, Westinghouse Road
    Trafford Park
    M17 1PY Manchester
    Euroterminal
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    Tdg Headquarters, Westinghouse Road
    Trafford Park
    M17 1PY Manchester
    Euroterminal
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro00171035
    54728830004
    BENTLEY, Stephen Graham
    Airedale
    Grassy Lane
    TN13 1PN Sevenoaks
    Kent
    Director
    Airedale
    Grassy Lane
    TN13 1PN Sevenoaks
    Kent
    BritishCompany Director10013370002
    BERTREAU, François Louis, André
    Lodge Way
    New Duston
    NN5 7SL Northampton
    Norbert Dentressangle House
    Northamptonshire
    United Kingdom
    Director
    Lodge Way
    New Duston
    NN5 7SL Northampton
    Norbert Dentressangle House
    Northamptonshire
    United Kingdom
    FranceFrenchPresident Of Executive Board193103110001
    BICKNELL, Geoffrey James
    Floor
    Derby House 64 Athol Street
    IM1 1JD Douglas
    4th
    Isle Of Man
    Director
    Floor
    Derby House 64 Athol Street
    IM1 1JD Douglas
    4th
    Isle Of Man
    Isle Of ManBritishDirector133906340001
    BRANIGAN, Michael Jordan
    Westinghouse Road
    Trafford Park
    M17 1PY Manchester
    Tdg Headquarters, Euroterminal
    United Kingdom
    Director
    Westinghouse Road
    Trafford Park
    M17 1PY Manchester
    Tdg Headquarters, Euroterminal
    United Kingdom
    EnglandBritishManaging Director48198600002
    COLE, Alan Jack
    57 Hugh Street
    SW1V 4HR London
    Director
    57 Hugh Street
    SW1V 4HR London
    United KingdomBritishCompany Director9811630006
    COLE, John Robert
    Winston House
    Winston Green
    IP14 6BG Debenham
    Suffolk
    Director
    Winston House
    Winston Green
    IP14 6BG Debenham
    Suffolk
    BritishCompany Director49591410002
    DE LA ROCHEBROCHARD, Gaultier
    Lodge Way
    New Duston
    NN5 7SL Northampton
    Norbert Denstressangle House
    Uk
    Director
    Lodge Way
    New Duston
    NN5 7SL Northampton
    Norbert Denstressangle House
    Uk
    FranceFrenchSolicitor168893170001
    DUNCAN, James Blair, Sir
    17 Kingston House South
    Ennismore Gardens
    SW7 1NF London
    Director
    17 Kingston House South
    Ennismore Gardens
    SW7 1NF London
    EnglandBritishCompany Director3477810001
    DYE, Iain Roger
    Beechwood House Henley Road
    SL7 2DF Marlow
    Buckinghamshire
    Director
    Beechwood House Henley Road
    SL7 2DF Marlow
    Buckinghamshire
    BritishFinance Director44532410001
    GARMAN, David Noel Christopher
    Oakwood
    Church Lane, Welford On Avon
    CV37 8EL Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Director
    Oakwood
    Church Lane, Welford On Avon
    CV37 8EL Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    EnglandBritishCompany Director177736170001
    HUME, Jeffrey
    38 Burdon Lane
    SM2 7PT Cheam
    Surrey
    Director
    38 Burdon Lane
    SM2 7PT Cheam
    Surrey
    United KingdomBritishAccountant58948740002
    KINLEY, John
    The Birches
    South Park
    TN13 1EL Sevenoaks
    Kent
    Director
    The Birches
    South Park
    TN13 1EL Sevenoaks
    Kent
    BritishCompany Secretary9811620001
    LYNCH, David Paul
    Lodge Way
    New Duston
    NN5 7SL Northampton
    Norbert Dentressangle House
    United Kingdom
    Director
    Lodge Way
    New Duston
    NN5 7SL Northampton
    Norbert Dentressangle House
    United Kingdom
    EnglandBritishAccountant52425370006
    MAINWARING, Paul Richard
    7 Woodlands Park
    Merrow
    GU1 2TH Guildford
    Surrey
    Director
    7 Woodlands Park
    Merrow
    GU1 2TH Guildford
    Surrey
    EnglandBritishAccountant116302540001
    ROONEY, Graeme William
    Chesham Road
    SK9 6HA Wilmslow
    18
    Cheshire
    Director
    Chesham Road
    SK9 6HA Wilmslow
    18
    Cheshire
    BritishManaging Director135540120001
    THOMAS, Geoffrey Graham
    24 Kerris Way
    Lower Earley
    RG6 5UW Reading
    Director
    24 Kerris Way
    Lower Earley
    RG6 5UW Reading
    BritishAccountant10040620002
    TDG DIRECTORS NO 1 LIMITED
    Westinghouse Road
    Trafford Park
    M17 1PY Manchester
    Tdg Headquarters Euroterminal
    United Kingdom
    Director corporativo
    Westinghouse Road
    Trafford Park
    M17 1PY Manchester
    Tdg Headquarters Euroterminal
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro589092
    159274800001

    ¿Tiene TDG OVERSEAS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A supplemental debenture
    Creado el 30 ene 2009
    Entregado el 10 feb 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each chargor and each obligor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of first fixed and floating charge all of its present and future right, title and interest in and to: the argos receivables, vita receivables, corus, ici receivables all rights, securities and guarantees of whatsoever nature see image for full details.
    Personas con derecho
    • Burdale Financial Limited as Trustee for the Beneficiaries (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 10 feb 2009Registro de un cargo (395)
    • 15 jun 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    A spanish law share pledge of company quotas
    Creado el 13 oct 2008
    Entregado el 27 oct 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    As security for the full and timely fulfilment of the secured liabilities the plegor pledged the whole of the quotas in favour of the pledgee. See image for full details.
    Personas con derecho
    • Burdale Financial Limited (The Pledgee)
    Transacciones
    • 27 oct 2008Registro de un cargo (395)
    • 15 jun 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    A belgian law share pledge agreement
    Creado el 13 oct 2008
    Entregado el 24 oct 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The 14,562 registered shares in the share capital any and all rights to acquire shares any and all other rights pertaining to the shares see image for full details.
    Personas con derecho
    • Burdale Financial Limited
    Transacciones
    • 24 oct 2008Registro de un cargo (395)
    • 15 jun 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    A belgian law share pledge agreement
    Creado el 13 oct 2008
    Entregado el 24 oct 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The 2,740 registered shares in the share capital any and all rights to acquire shares and any and all other rights pertaining to the shares see image for full details.
    Personas con derecho
    • Burdale Financial Limited
    Transacciones
    • 24 oct 2008Registro de un cargo (395)
    • 15 jun 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    An irish law charge of shares
    Creado el 13 oct 2008
    Entregado el 24 oct 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All its rights title benefit and interest to or in or in respect of the shares and the related assets see image for full details.
    Personas con derecho
    • Burdale Financial Limited (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 24 oct 2008Registro de un cargo (395)
    • 15 jun 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 13 oct 2008
    Entregado el 24 oct 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the barclays documents, from tdg LTD to the pension scheme (and/or the pension trustee on behalf of the pension scheme) and from each obligor to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Burdale Financial Limited as Trustee for the Beneficiaries (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 24 oct 2008Registro de un cargo (395)
    • 15 jun 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)

    ¿Tiene TDG OVERSEAS LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    27 dic 2016Fecha de disolución
    04 sept 2015Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Christopher Kim Rayment
    Bdo Llp
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    Profesional
    Bdo Llp
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0