J.D. WILLIAMS & COMPANY LIMITED

J.D. WILLIAMS & COMPANY LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaJ.D. WILLIAMS & COMPANY LIMITED
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00178367
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenesNo
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de J.D. WILLIAMS & COMPANY LIMITED?

    • Venta al por menor por correo o por Internet (47910) / Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas

    ¿Dónde se encuentra J.D. WILLIAMS & COMPANY LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Griffin House
    40 Lever Street
    M60 6ES Manchester
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de J.D. WILLIAMS & COMPANY LIMITED?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el26 feb 2025
    Próximas cuentas vencen el26 feb 2026
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta02 mar 2024

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para J.D. WILLIAMS & COMPANY LIMITED?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta21 ago 2026
    Próxima declaración de confirmación vence04 sept 2026
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta21 ago 2025
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para J.D. WILLIAMS & COMPANY LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Declaración de confirmación presentada el 21 ago 2025 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Segunda presentación para el nombramiento de Mr Malcolm Lemay como director

    3 páginasRP04AP01

    Nombramiento de Mr Ashraf Piranie como director el 26 may 2025

    2 páginasAP01

    Memorándum y Estatutos

    7 páginasMA

    Nombramiento de Mr Malcom Lemay como director el 01 abr 2025

    3 páginasAP01
    Anotaciones
    FechaAnotación
    02 jul 2025Clarification A second filed AP01 was registered on 02/07/2025.

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de modificación de los Artículos de Asociación

    RES01

    Registro de la carga 001783670007, creada el 04 abr 2025

    38 páginasMR01

    Registro de la carga 001783670008, creada el 04 abr 2025

    13 páginasMR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 02 mar 2024

    67 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 21 ago 2024 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 04 mar 2023

    66 páginasAA

    Cese del nombramiento de Sarah Victoria Welsh como director el 31 oct 2023

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Alyson Tracey Fadil como director el 31 oct 2023

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Nuno Miguel Da Cruz Miller como director el 31 oct 2023

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 21 ago 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Dominic Appleton como director el 07 jun 2023

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Rachel Izzard como director el 06 jun 2023

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Kenyatte Nelson como director el 14 oct 2022

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 26 feb 2022

    64 páginasAA

    Nombramiento de Mr Christian Henry Wells como secretario el 15 ago 2022

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Michael William Mustard como secretario el 15 ago 2022

    1 páginasTM02

    Declaración de confirmación presentada el 21 ago 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Nuno Miguel Da Cruz Miller como director el 01 nov 2021

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Michael William Mustard como secretario el 01 mar 2022

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Christian Wells como secretario el 01 mar 2022

    1 páginasTM02

    ¿Quiénes son los directivos de J.D. WILLIAMS & COMPANY LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    WELLS, Christian Henry
    Griffin House
    40 Lever Street
    M60 6ES Manchester
    Secretario
    Griffin House
    40 Lever Street
    M60 6ES Manchester
    299541980001
    APPLETON, Dominic
    Griffin House
    40 Lever Street
    M60 6ES Manchester
    Director
    Griffin House
    40 Lever Street
    M60 6ES Manchester
    EnglandBritish309875970001
    JOHNSON, Stephen
    40 Lever Street
    M60 6ES Manchester
    Griffin House
    United Kingdom
    Director
    40 Lever Street
    M60 6ES Manchester
    Griffin House
    United Kingdom
    EnglandBritish187780370002
    JOY, Daniel Barry
    Griffin House
    40 Lever Street
    M60 6ES Manchester
    Director
    Griffin House
    40 Lever Street
    M60 6ES Manchester
    EnglandBritish129988500003
    LEMAY, Malcolm
    Griffin House
    40 Lever Street
    M60 6ES Manchester
    Director
    Griffin House
    40 Lever Street
    M60 6ES Manchester
    EnglandBritish335866550001
    PIRANIE, Ashraf
    Griffin House
    40 Lever Street
    M60 6ES Manchester
    Director
    Griffin House
    40 Lever Street
    M60 6ES Manchester
    EnglandBritish327790800001
    BEAT, Stephanie Louise
    40 Lever Street
    M60 6ES Manchester
    Griffin House
    United Kingdom
    Secretario
    40 Lever Street
    M60 6ES Manchester
    Griffin House
    United Kingdom
    202510500001
    CASEY, Theresa
    40 Lever Street
    M60 6ES Manchester
    Griffin House
    United Kingdom
    Secretario
    40 Lever Street
    M60 6ES Manchester
    Griffin House
    United Kingdom
    209391700001
    MUSTARD, Michael William
    Griffin House
    40 Lever Street
    M60 6ES Manchester
    Secretario
    Griffin House
    40 Lever Street
    M60 6ES Manchester
    295316200001
    TYNAN, Peter John
    Griffin House
    40 Lever Street
    M60 6ES Manchester
    Secretario
    Griffin House
    40 Lever Street
    M60 6ES Manchester
    British4953640001
    WELLS, Christian
    Griffin House
    40 Lever Street
    M60 6ES Manchester
    Secretario
    Griffin House
    40 Lever Street
    M60 6ES Manchester
    289070080001
    ALLIANCE, Nigel
    Carrwood
    Hale Barns
    WA15 0EN Altrincham
    55
    Cheshire
    United Kingdom
    Director
    Carrwood
    Hale Barns
    WA15 0EN Altrincham
    55
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish6512380002
    ALLIANCE, Nigel
    Cringle The Downs
    Schools Hill
    SK8 1JD Cheadle
    Cheshire
    Director
    Cringle The Downs
    Schools Hill
    SK8 1JD Cheadle
    Cheshire
    British6512380001
    ARMITAGE, Mark Adrian
    Cornerstone House
    Coningsby Lane
    SL6 2PF Fifield Maidenhead
    Berkshire
    Director
    Cornerstone House
    Coningsby Lane
    SL6 2PF Fifield Maidenhead
    Berkshire
    United KingdomBritish97856320001
    BASNETT, Keith
    8 Millbrook Close
    Shaw
    OL2 8QA Oldham
    Lancashire
    Director
    8 Millbrook Close
    Shaw
    OL2 8QA Oldham
    Lancashire
    United KingdomBritish113438030001
    BEVERIDGE, Iain Anderson
    6 Ashcroft Close
    SK9 1RB Wilmslow
    Cheshire
    Director
    6 Ashcroft Close
    SK9 1RB Wilmslow
    Cheshire
    British39085890001
    BULLAS, Michael Stuart
    Lumb House Farm
    Greenside Road, Thurstonland
    HD4 6XA Huddersfield
    West Yorkshire
    Director
    Lumb House Farm
    Greenside Road, Thurstonland
    HD4 6XA Huddersfield
    West Yorkshire
    British86392570001
    BURGIN, Judith Margaret
    Shore Mill
    Lawton Square
    OL3 5DT Delph
    Director
    Shore Mill
    Lawton Square
    OL3 5DT Delph
    EnglandBritish126867490001
    CARR, Ian
    40 Lever Street
    M60 6ES Manchester
    Griffin House
    United Kingdom
    Director
    40 Lever Street
    M60 6ES Manchester
    Griffin House
    United Kingdom
    United KingdomBritish163141230001
    CHESHIRE, Mark
    Griffin House
    40 Lever Street
    M60 6ES Manchester
    Director
    Griffin House
    40 Lever Street
    M60 6ES Manchester
    United KingdomBritish149554830001
    CLARK, Richard John
    Griffin House
    40 Lever Street
    M60 6ES Manchester
    Director
    Griffin House
    40 Lever Street
    M60 6ES Manchester
    EnglandBritish186604810001
    COOK, Gerald
    The Farmhouse Ainsworth Farm
    Back Lane Heath Charnock
    PR6 9DJ Chorley
    Lancashire
    Director
    The Farmhouse Ainsworth Farm
    Back Lane Heath Charnock
    PR6 9DJ Chorley
    Lancashire
    British40093030002
    CUNNINGHAM, Robert Michael
    5 Highbanks
    Southport Road
    L31 2PJ Lydiate
    Merseyside
    Director
    5 Highbanks
    Southport Road
    L31 2PJ Lydiate
    Merseyside
    British57840310001
    DA CRUZ MILLER, Nuno Miguel
    Griffin House
    40 Lever Street
    M60 6ES Manchester
    Director
    Griffin House
    40 Lever Street
    M60 6ES Manchester
    EnglandPortuguese295714850001
    FADIL, Alyson Tracey
    40 Lever Street
    M60 6ES Manchester
    Griffin House
    United Kingdom
    Director
    40 Lever Street
    M60 6ES Manchester
    Griffin House
    United Kingdom
    EnglandBritish178110770001
    FOGWILL, Jonathan Harry Cecil
    40 Lever Street
    M60 6ES Manchester
    Griffin House
    United Kingdom
    Director
    40 Lever Street
    M60 6ES Manchester
    Griffin House
    United Kingdom
    United KingdomBritish175851190001
    GREEN, Graham
    17 Sandringham Road
    PR8 2JZ Southport
    Merseyside
    Director
    17 Sandringham Road
    PR8 2JZ Southport
    Merseyside
    EnglandBritish123494770001
    GREEN, Nigel Ferguson
    Rose Cottage Bullhill Lane
    Rainow
    SK10 5TQ Macclesfield
    Cheshire
    Director
    Rose Cottage Bullhill Lane
    Rainow
    SK10 5TQ Macclesfield
    Cheshire
    British27007440001
    GREENWOOD, Michael Irvine
    1 Rock Terrace Leeds Road
    Lightcliffe
    HX3 8PB Halifax
    West Yorkshire
    Director
    1 Rock Terrace Leeds Road
    Lightcliffe
    HX3 8PB Halifax
    West Yorkshire
    British80165570001
    HAYWOOD, Andrew Paul
    Griffin House
    40 Lever Street
    M60 6ES Manchester
    Director
    Griffin House
    40 Lever Street
    M60 6ES Manchester
    United KingdomBritish190080590001
    HIGGINSON, Andrew Thomas
    Delamare Road
    Cheshunt
    EN8 9SL Waltham Cross
    Heldrew House
    Hertfordshire
    England
    Director
    Delamare Road
    Cheshunt
    EN8 9SL Waltham Cross
    Heldrew House
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritish57637410003
    HINCHCLIFFE, John
    Old Oxenhope Hall
    Old Oxenhope Lane Oxenhope
    BD22 9RL Keighley
    Director
    Old Oxenhope Hall
    Old Oxenhope Lane Oxenhope
    BD22 9RL Keighley
    EnglandBritish69021080003
    IZZARD, Rachel
    Griffin House
    40 Lever Street
    M60 6ES Manchester
    Director
    Griffin House
    40 Lever Street
    M60 6ES Manchester
    United KingdomBritish268748050003
    KENDRICK, Paul Robert
    Griffin House
    40 Lever Street
    M60 6ES Manchester
    Director
    Griffin House
    40 Lever Street
    M60 6ES Manchester
    United KingdomBritish129956520001
    KOWALSKI, Timothy John
    Cherry Trees
    Chelford Road
    SK9 7TL Alderley Edge
    Cheshire
    Director
    Cherry Trees
    Chelford Road
    SK9 7TL Alderley Edge
    Cheshire
    EnglandBritish64229200003

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de J.D. WILLIAMS & COMPANY LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    40 Lever Street
    M60 6ES Manchester
    Griffin House
    England
    06 abr 2016
    40 Lever Street
    M60 6ES Manchester
    Griffin House
    England
    No
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro00927506
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0