ESSEX CHRONICLE MEDIA GROUP LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | ESSEX CHRONICLE MEDIA GROUP LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 00184465 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de ESSEX CHRONICLE MEDIA GROUP LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra ESSEX CHRONICLE MEDIA GROUP LIMITED?
| Dirección de la sede social | Northcliffe Accounting Centre PO BOX 6795 St George Street LE1 1ZP Leicester |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ESSEX CHRONICLE MEDIA GROUP LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| ESSEX CHRONICLE SERIES LIMITED(THE) | 20 sept 1922 | 20 sept 1922 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de ESSEX CHRONICLE MEDIA GROUP LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 02 oct 2011 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para ESSEX CHRONICLE MEDIA GROUP LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Nombramiento de Mr Paul Simon Collins como director el 30 dic 2012 | 3 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Stephen Andrew Auckland como director el 30 dic 2012 | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 02 oct 2011 | 27 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 21 feb 2012 avec liste complète des actionnaires | 14 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Alan Oliver Geere como director el 01 feb 2012 | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Elizabeth Paterson como director el 01 feb 2012 | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Richard Alan Karn como director el 01 feb 2012 | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Stephen Andrew Auckland como director | 3 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Michael Pelosi como director | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Richard Alan Karn el 16 mar 2011 | 3 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Alan Oliver Geere el 16 mar 2011 | 3 páginas | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 21 feb 2011 avec liste complète des actionnaires | 16 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 03 oct 2010 | 22 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 21 feb 2010 avec liste complète des actionnaires | 18 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 04 oct 2009 | 22 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del director Michael Paul Pelosi el 06 nov 2009 | 3 páginas | CH01 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 288b | ||||||||||
legacy | 7 páginas | 363a | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 28 sept 2008 | 22 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 2 páginas | 288a | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 288b | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 288b | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de ESSEX CHRONICLE MEDIA GROUP LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLLINS, Paul Simon | Secretario | 5 Weare Close Billesdon LE7 9DY Leicester | British | 44213280003 | ||||||
| COLLINS, Paul Simon | Director | Weare Close Billesdon LE7 9DY Leicester 5 United Kingdom | England | English | 172172370001 | |||||
| GLASS, Roland Edmondson | Secretario | 24 Martin Dene DA6 8NA Bexleyheath Kent | British | 2756690001 | ||||||
| AUCKLAND, Stephen Andrew | Director | 2 Derry Street Kensington W8 5TT London Northcliffe House United Kingdom | England | British | 271190100001 | |||||
| BARING, Vivian John Rowland, The Honourable | Director | The Stone House Lower Swell GL54 1LQ Stow On The Wold Gloucestershire | United Kingdom | British | 6846960001 | |||||
| BATES, Paul Steven | Director | 62 Queensberry Avenue Copford CO6 1YN Colchester Essex | British | 41692200002 | ||||||
| BEATTY, Kevin Joseph | Director | 1 Lansdowne Copse Off Lansdowne Court The Avenue KT4 7FB Worcester Park Surrey | United Kingdom | British | 51345160003 | |||||
| COATES, Richard Michael | Director | Lilac House The Street, High Ongar CM5 9NH Ongar Essex | British | 70782470001 | ||||||
| CURRALL, Duncan James Steel | Director | Four Bridges Stud Hedingham Road Blackmore End CM7 4EN Braintree Essex | British | 52502190002 | ||||||
| DAVIDSON, Alexander Lindsay | Director | 19 Hyde Park Gardens Mews W2 2NU London | British | 30544090003 | ||||||
| DYER, Anthony Neville | Director | 92 Pickhurst Park BR2 0TW Bromley Kent | British | 25381690001 | ||||||
| EDWARDS, Sonia Maxine | Director | 57 Sandleford Drive Elstow MK42 9GL Bedford Bedfordshire | British | 108012050001 | ||||||
| EVANS, Brian Leighton | Director | 41 Egret Crescent Longridge Park CO4 3FP Colchester Essex | British | 8763840001 | ||||||
| GEERE, Alan Oliver | Director | Victoria Road Writtle CM1 3PA Chelmsford 20 England United Kingdom | United Kingdom | British | 135464740002 | |||||
| HINDLEY, Martyn John | Director | Upper Wield SO24 9RT Arlesford The Barn Hampshire | England | British | 134332760001 | |||||
| HOLDER, Matthew | Director | 49a Meadow Rise Billericay CM13 1QD Essex | British | 110115440002 | ||||||
| KARN, Richard Alan, Mr. | Director | Sheepsetting Lane Cross In Hand TN21 0XG Heathfield Meadowside East Sussex England | United Kingdom | British | 88386360002 | |||||
| KEARNEY, Paul Kevin Michael | Director | 4 Clifton High Grove Stoke Bishop BS9 1TU Bristol Avon | England | British | 34347890005 | |||||
| KEETCH, Penny Caroline | Director | Lower Cemetery Lodge Bayham Road TN2 5HX Tunbridge Wells | England | British | 62637260005 | |||||
| LEVY, Harry | Director | 95 Evelyn Drive Hatch End HA5 4RN Pinner Middlesex | British | 8763850001 | ||||||
| LEYS, Alexander William | Director | 67 Thorndon Hall Thorndon Park CM13 3RJ Brentwood Essex | British | 69383820002 | ||||||
| MANWARING, Colin James | Director | 10 Hawlmark End Marks Tey CO6 1NF Colchester Essex | British | 8763860001 | ||||||
| NEWMAN, Paul Godfrey | Director | 4 Woodhill Park Pembury TN2 4NN Tunbridge Wells Kent | British | 25381710001 | ||||||
| PARK, Ian Grahame | Director | 6 Cheyne Row SW3 5HL London | United Kingdom | British | 2756710001 | |||||
| PATERSON, Elizabeth | Director | 19 Town Acres TN10 4NG Tonbridge Kent | United Kingdom | British | 124115910001 | |||||
| PELOSI, Michael Paul | Director | 2 Derry Street W8 5TT Kensington Northcliffe House London | United Kingdom | British | 43743750001 | |||||
| RAWLINS, Stuart | Director | 72 Back Road Writtle CM1 3PD Chelmsford Essex | British | 41384240001 | ||||||
| SAUNDERS, Peter John | Director | Little Willows 45 West Common Way AL5 2LQ Harpenden Hertfordshire | British | 1995550001 | ||||||
| SMITH, Peter | Director | 17 Lawrence Road CO4 4LQ Colchester Essex | British | 8763870001 | ||||||
| STORRER, Dale James | Director | Oxford Drive IP7 6AW Hadleigh 67 Suffolk | England | British | 206054010001 | |||||
| WATKINS, Roger John | Director | 13 Peartrees Ingrave CM13 3RP Brentwood Essex | British | 86425740001 | ||||||
| WHITE, Malcolm Roy | Director | 28 Walsingham Way CM12 0YE Billericay Essex | England | British | 34599000004 |
¿Tiene ESSEX CHRONICLE MEDIA GROUP LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Mortgage | Creado el 19 ago 1939 Entregado el 02 sept 1939 | Pendiente | Cantidad garantizada £1041 | |
Breve descripción Freehold land warehouse & other buildings in st thomas rd, brentwood, essex. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0