CLEVELAND SCIENTIFIC INSTITUTION
Visión general
Nombre de la empresa | CLEVELAND SCIENTIFIC INSTITUTION |
---|---|
Estado de la empresa | Activa |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social |
Número de empresa | 00191037 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | No |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de CLEVELAND SCIENTIFIC INSTITUTION?
- Otros alojamientos (55900) / Actividades de alojamiento y de servicios de comida
- Otras actividades de ingeniería (71129) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
- Servicios de apoyo a la educación (85600) / Educación
- Actividades de organizaciones profesionales de miembros (94120) / Otras actividades de servicios
¿Dónde se encuentra CLEVELAND SCIENTIFIC INSTITUTION?
Dirección de la sede social | 128 High Street High Street Great Broughton TS9 7HA Middlesbrough England |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de CLEVELAND SCIENTIFIC INSTITUTION?
Vencido | No |
---|---|
Próximas cuentas | |
Próximo período contable finaliza el | 30 jun 2025 |
Próximas cuentas vencen el | 31 mar 2026 |
Últimas cuentas | |
Últimas cuentas cerradas hasta | 30 jun 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para CLEVELAND SCIENTIFIC INSTITUTION?
Última declaración de confirmación cerrada hasta | 30 nov 2025 |
---|---|
Próxima declaración de confirmación vence | 14 dic 2025 |
Última declaración de confirmación | |
Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 30 nov 2024 |
Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para CLEVELAND SCIENTIFIC INSTITUTION?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Domicilio social registrado cambiado de Orchard House Newton Under Roseberry Middlesbrough TS9 6QR England a 128 High Street High Street Great Broughton Middlesbrough TS9 7HA el 02 jun 2025 | 1 páginas | AD01 | ||
Cese del nombramiento de Isabel Angelica Reeve como director el 02 jun 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Cambio de datos del director Mr Adrian Paul Northey el 02 jun 2025 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Mr Christopher Nigel Heslop el 02 jun 2025 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Mr Colin Raymond Howard el 02 jun 2025 | 2 páginas | CH01 | ||
Cese del nombramiento de William Suthers como director el 02 jun 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de William Suthers como secretario el 02 jun 2025 | 1 páginas | TM02 | ||
Nombramiento de Ms Isabel Angelica Reeve como secretario el 19 feb 2025 | 2 páginas | AP03 | ||
Nombramiento de Ms Isabel Angelica Reeve como director el 19 feb 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 jun 2024 | 18 páginas | AA | ||
Cambio de datos del director Susan Margaret Parker el 15 dic 2024 | 2 páginas | CH01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 30 nov 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr Stephen Pallant como director el 15 jul 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 jun 2023 | 18 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 30 nov 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de C/O Azets Holdings Ltd Wynyard Park House Wynyard Avenue Wynyard TS22 5TB United Kingdom a Orchard House Newton Under Roseberry Middlesbrough TS9 6QR el 13 dic 2023 | 1 páginas | AD01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de New Garth House Upper Garth Gardens Guisborough TS14 6HA a C/O Azets Holdings Ltd Wynyard Park House Wynyard Avenue Wynyard TS22 5TB el 15 nov 2023 | 1 páginas | AD01 | ||
Cese del nombramiento de Paul William Shelton como director el 26 jun 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Derek Arthur Mills como director el 26 jun 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de John Noon como director el 26 jun 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Austin Teague Mcglynn como director el 26 jun 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Donald Atkinson como director el 26 jun 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 jun 2022 | 17 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 30 nov 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Scott Alexander Taylor como director el 01 dic 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
¿Quiénes son los directivos de CLEVELAND SCIENTIFIC INSTITUTION?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | Pa ís de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REEVE, Isabel Angelica | Secretario | High Street Great Broughton TS9 7HA Middlesbrough 128 England | 332602270001 | |||||||
BRABBS, Alexandra Claire, Dr | Director | Portland Place W1B 1NT London 76 England | England | British | Manager | 178278320001 | ||||
BRADLEY, Thomas Bowman | Director | The Poplars Wolviston TS22 5LY Billingham 28 Cleveland England | United Kingdom | British | Retired | 93756950001 | ||||
DAWOOD, Nash, Prof | Director | Borough Road TS1 3BA Middlesbrough Teesside University England | England | British | Scientist | 263084320001 | ||||
HESLOP, Christopher Nigel | Director | West Dyke Road TS10 4QL Redcar 495 England | England | British | Loss Adjustor | 195725770001 | ||||
HOWARD, Colin Raymond | Director | The Paddock Stokesley TS9 5PN Middlesbrough 87 England | England | British | Consultant Engineer | 77689330002 | ||||
KELLERMAN, Sarah Jane | Director | Morton Carr Lane Nunthorpe TS7 0JU Middlesbrough 17 Cleveland England | England | British | Civil Engineering Consultant | 199529290001 | ||||
KIRK, Anthony | Director | Eston Road TS6 6US Middlesbrough Teeside Technology Centre United Kingdom | United Kingdom | British | Quality Manager | 160508080001 | ||||
LEWIS, Mark Allison | Director | Stokesley Road Hutton Rudby TS15 0JJ Yarm The Range England | England | British | Consultant | 216146300001 | ||||
MCGINNIS, Joseph, Dr | Director | Borough Road TS1 3BA Middlesbrough Teesside University Sse Cleveland England | England | British | University Lecturer | 176356600001 | ||||
NORTHEY, Adrian Paul | Director | Newton Road Great Ayton TS9 6DT Middlesbrough 33 England | England | British | Regulatory Manager | 174939640001 | ||||
PALLANT, Stephen | Director | Boar Lane Ingleby Barwick TS17 0RX Stockton-On-Tees 22 England | England | British | Business Manager | 325256550001 | ||||
PARKER, Susan Margaret | Director | Manor Drive Hilton TS15 9LE Yarm Balgownie Cleveland United Kingdom | England | British | Ipr Manager | 135193070002 | ||||
ROUT, Joanne | Director | Embleton Grove Wynyard TS22 5SY Billingham 4 England | England | British | Business Development And Project Manager | 262819290001 | ||||
TICKNER, Alan Charles | Director | The Grove TS14 8BG Guisborough 16 | United Kingdom | British | Insurance Broker | 8723880001 | ||||
YOUNG, David | Director | Rushmere Marton-In-Cleveland TS8 9XL Middlesbrough 52 Cleveland England | England | British | Consulting Engineer | 184468260001 | ||||
RODGER, Alan Hunter | Secretario | Kirkdale TS14 8EX Guisborough 6 Cleveland | British | Retired | 14694660001 | |||||
SUTHERS, William | Secretario | Newton Under Roseberry TS9 6QR Middlesbrough Orchard House England | 218881560001 | |||||||
ATKINSON, Donald | Director | Mulgrave Road TS5 6PU Middlesbrough 9 Cleveland England | England | British | Regional Account Manager | 181604260001 | ||||
ATKINSON, Thomas Andrew | Director | West Pastures Farm Claxton TS22 5PN Billingham Cleveland | British | Chartered Accountant | 60914640001 | |||||
AUSTIN, Leonard Pearce | Director | 7 Hillside Ingleby Arncliffe DL6 3LV Northallerton North Yorkshire | British | Chartered Engineer | 23695020001 | |||||
BARRATT, James Reekie | Director | 4 Skottowe Crescent Great Ayton TS9 6DS Middlesbrough Cleveland | British | Retired | 23695030001 | |||||
BATE, David John | Director | 9 The Pines TS15 9EW Yarm Cleveland | British | Retired | 20751200001 | |||||
BATTY, Frederick Allen | Director | 12 Friarswood Close Yarm TS15 9JG Stockton On Tees Cleveland | British | Retired | 23695050001 | |||||
BELL, Keith Anthony | Director | New Garth House Upper Garth Gardens TS14 6HA Guisborough | England | British | Engineer | 63935210001 | ||||
BOYD, John | Director | New Garth House Upper Garth Gardens TS14 6HA Guisborough | United Kingdom | British | Consultant | 18326360001 | ||||
BRETT, Francis Vincent | Director | 10 Burnside Grove Hartburn TS18 4ET Stockton On Tees Cleveland | British | Retired | 23695060001 | |||||
BROOKS, Douglas William | Director | 19 Glendale TS14 8JF Guisborough Cleveland | British | Retired | 6295560001 | |||||
BROWN, Merrik Boswell | Director | 23 Stokesley Road Nunthorpe TS7 0NB Middlesbrough Cleveland | British | Engineer | 23695040001 | |||||
BUCKLEY, Peter Mellor | Director | Penny Lane HG4 1HG Ripon 1 North Yorkshire England | England | British | Engineering Consultant | 34159440004 | ||||
BUTTERFIELD, Jacqueline Gail | Director | 39 Longbeck Lane New Marske TS11 8DF Redcar Cleveland | British | Senior Metallurgist | 67726290001 | |||||
CAMPBELL, Joseph Wilson | Director | 5 Broad Close Stainton TS8 9BW Middlesbrough Cleveland | United Kingdom | British | Retired | 11826300001 | ||||
CLARK, Albert Victor George | Director | 51 Wallington Road High Grange TS23 3UR Billingham Cleveland | British | Total Quality Coordinator | 37919450001 | |||||
CLIFTON, Robert | Director | 1 Shearwater Lane Norton TS20 1SH Stockton On Tees Cleveland | British | Consultant | 40629250001 | |||||
CROZIER, Colin William | Director | 78 St James Drive YO7 8YW Northallerton North Yorkshire | British | Insurance Branch Manager | 23695080001 |
¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para CLEVELAND SCIENTIFIC INSTITUTION?
Notificado el | Cesado el | Declaración |
---|---|---|
30 nov 2016 | La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa. |
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0