FLEETSBRIDGE RANDALL LIMITED

FLEETSBRIDGE RANDALL LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaFLEETSBRIDGE RANDALL LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00200575
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de FLEETSBRIDGE RANDALL LIMITED?

    • Otro alquiler y explotación de bienes inmobiliarios propios o arrendados (68209) / Actividades inmobiliarias
    • Administración de bienes inmobiliarios por cuenta ajena (68320) / Actividades inmobiliarias

    ¿Dónde se encuentra FLEETSBRIDGE RANDALL LIMITED?

    Dirección de la sede social
    58 Low Friar Street
    UNIT 71
    NE1 5UD Newcastle Upon Tyne
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de FLEETSBRIDGE RANDALL LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    PAIG INTERNATIONAL LIMITED08 oct 200708 oct 2007
    SETON HOUSE INTERNATIONAL LIMITED17 nov 200517 nov 2005
    BRITAX INTERNATIONAL LIMITED29 may 199729 may 1997
    B.S.G. INTERNATIONAL PLC23 sept 192423 sept 1924

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de FLEETSBRIDGE RANDALL LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 sept 2014

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para FLEETSBRIDGE RANDALL LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ2

    Domicilio social registrado cambiado de , 53 Welbeck Street, London, W1G 9XR a PO Box Unit 71 58 Low Friar Street Newcastle upon Tyne NE1 5UD el 30 ago 2016

    1 páginasAD01

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Cambio de datos del director Mr Douglas John Mcbean el 29 feb 2016

    2 páginasCH01

    Cese del nombramiento de Johanne Coutts como secretario el 29 feb 2016

    1 páginasTM02

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 30 sept 2014

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 18 jun 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital19 jun 2015

    Estado de capital el 19 jun 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 30 sept 2013

    4 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 18 jun 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital02 jul 2014

    Estado de capital el 02 jul 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Déclaration annuelle établie au 18 jun 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cambio de datos del secretario Johanne Coutts el 19 jun 2013

    2 páginasCH03

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 30 sept 2012

    4 páginasAA

    Domicilio social registrado cambiado de , 14 Gees Court, London, W1U 1JW el 05 feb 2013

    1 páginasAD01

    Déclaration annuelle établie au 18 jun 2012 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01

    Cambio de datos del secretario Johanne Coutts el 24 ago 2012

    1 páginasCH03

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 30 sept 2011

    5 páginasAA

    Exercice comptable précédent raccourci du 31 dic 2011 au 30 sept 2011

    2 páginasAA01

    Déclaration annuelle établie au 18 jun 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2010

    6 páginasAA

    Domicilio social registrado cambiado de , One Eleven Edmund Street, Birmingham, B3 2HJ el 28 sept 2011

    1 páginasAD01

    Nombramiento de Douglas John Mcbean como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de John Colhoun como director

    1 páginasTM01

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Interim dividend 16/12/2010
    RES13

    Nombramiento de Johanne Coutts como secretario

    3 páginasAP03

    Nombramiento de John Colhoun como director

    3 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de FLEETSBRIDGE RANDALL LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MCBEAN, Douglas John
    West Pilton Way
    EH4 4BF Edinburgh
    3/6
    Scotland
    Director
    West Pilton Way
    EH4 4BF Edinburgh
    3/6
    Scotland
    ScotlandBritishNone160663440002
    COUTTS, Johanne
    Orbital Court
    East Kilbride
    G74 5PH Glasgow
    3c
    Scotland
    Secretario
    Orbital Court
    East Kilbride
    G74 5PH Glasgow
    3c
    Scotland
    British157147220001
    MCCASLIN, Stuart David
    Victoria House 27 Victoria Road
    B50 4AS Bidford On Avon
    Warwickshire
    Secretario
    Victoria House 27 Victoria Road
    B50 4AS Bidford On Avon
    Warwickshire
    British1824650002
    THORNE, Raymond
    60 Silhill Hall Road
    B91 1JS Solihull
    West Midlands
    Secretario
    60 Silhill Hall Road
    B91 1JS Solihull
    West Midlands
    British2756010001
    PREMIUM AIRCRAFT INTERIORS GROUP LIMITED
    Watchmoor Road
    GU15 3EX Camberley
    Watchmoor Point
    Surrey
    Secretario corporativo
    Watchmoor Road
    GU15 3EX Camberley
    Watchmoor Point
    Surrey
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro3929802
    154770140001
    AMEY, Brian Leslie
    Edgemoor Howard Drive
    Hale
    WA15 0LT Altrincham
    Cheshire
    Director
    Edgemoor Howard Drive
    Hale
    WA15 0LT Altrincham
    Cheshire
    BritishDirector69888230001
    BARBER, Norman Victor
    Greylands 17 Merrow Croft
    Merrow
    GU1 2XH Guildford
    Surrey
    Director
    Greylands 17 Merrow Croft
    Merrow
    GU1 2XH Guildford
    Surrey
    EnglandBritishDirector6210060001
    BROGAN, Bernard Desmond
    Blakeley Lodge
    Egginton Road Etwall
    DE65 6NQ Derby
    Derbyshire
    Director
    Blakeley Lodge
    Egginton Road Etwall
    DE65 6NQ Derby
    Derbyshire
    EnglandBritishChartered Engineer70252730001
    BRYANT, Alan Christopher
    Old School House
    Saintbury
    WR12 7PX Broadway
    Worcestershire
    Director
    Old School House
    Saintbury
    WR12 7PX Broadway
    Worcestershire
    BritishDirector1910400001
    BRYCE, Robert Donaldson Hamish
    29 Marryat Road
    SW19 5BE London
    Director
    29 Marryat Road
    SW19 5BE London
    BritishCompany Director2661060002
    CANNON, Thomas Charles
    90 Knowle Wood Road
    Dorridge
    B93 8JP Solihull
    West Midlands
    Director
    90 Knowle Wood Road
    Dorridge
    B93 8JP Solihull
    West Midlands
    BritishChartered Secretary2756000001
    CARTER, Paul Dennis
    24 Allington Avenue
    WS13 6PF Lichfield
    Staffordshire
    Director
    24 Allington Avenue
    WS13 6PF Lichfield
    Staffordshire
    EnglandBritishCompany Director123148720001
    CASTON, Richard Charles Austin
    11 Halland Way
    HA6 2AG Northwood
    Middlesex
    Director
    11 Halland Way
    HA6 2AG Northwood
    Middlesex
    United KingdomBritishInvestment Manager62682380001
    COLHOUN, John
    Central Avenue
    G72 8AY Cambuslang
    25
    Glasgow
    United Kingdom
    Director
    Central Avenue
    G72 8AY Cambuslang
    25
    Glasgow
    United Kingdom
    UkBritishNone157176060001
    CULLINAN, Rory Malcolm
    25 Oakwood Court
    Abbotsbury Road
    W14 8JU London
    Director
    25 Oakwood Court
    Abbotsbury Road
    W14 8JU London
    EnglandBritishCompany Director149327390001
    DAWSON, Anthony David
    Flat 21 Hillbrow
    Richmond Hill
    TW10 6BH Richmond
    Surrey
    Director
    Flat 21 Hillbrow
    Richmond Hill
    TW10 6BH Richmond
    Surrey
    United KingdomBritishChartered Accountant89317200001
    DEVANNEY, William Gerard
    Edmund Street
    B3 2HJ Birmingham
    One Eleven
    Director
    Edmund Street
    B3 2HJ Birmingham
    One Eleven
    EnglandBritishFinance Director87628900001
    DILLON, John Eamon
    25 Park Avenue
    B91 3EJ Solihull
    West Midlands
    Director
    25 Park Avenue
    B91 3EJ Solihull
    West Midlands
    BritishVenture Capitalist54871970004
    DUFFIELD, Stephen Leslie
    Jacknett Barn
    1820 Warwick Road Knowle
    B93 0DX Solihull
    West Midlands
    Director
    Jacknett Barn
    1820 Warwick Road Knowle
    B93 0DX Solihull
    West Midlands
    EnglandBritishCompany Director24487000002
    ELLSMORE, Mark Anthony
    Moor Cottage
    Eversley Centre
    RG27 0NB Hook
    Director
    Moor Cottage
    Eversley Centre
    RG27 0NB Hook
    BritishFinance Director58979090001
    FINDLER, Jonathan Paul
    Westwood House
    Heathfield Avenue
    SL5 0AL Ascot
    Berkshire
    Director
    Westwood House
    Heathfield Avenue
    SL5 0AL Ascot
    Berkshire
    BritishCompany Director45532880003
    FREER, Robert Ian
    67 Fox Hollies Road
    B76 2RN Sutton Coldfield
    West Midlands
    Director
    67 Fox Hollies Road
    B76 2RN Sutton Coldfield
    West Midlands
    BritishVenture Capitalist65280490001
    GREGSON, Henry William
    47 Sutherland Place
    W2 5BY London
    Director
    47 Sutherland Place
    W2 5BY London
    United KingdomBritishFund Manager141581500001
    JONES, Alan Wingate
    The Grange
    North Cadbury
    BA22 7BY Yeovil
    Somerset
    Director
    The Grange
    North Cadbury
    BA22 7BY Yeovil
    Somerset
    BritishCompany Director4561920002
    JONES, Evan Taylor
    Ash Lea
    Barbon
    LA6 2LW Kirby Lonsdale
    Cumbria
    Director
    Ash Lea
    Barbon
    LA6 2LW Kirby Lonsdale
    Cumbria
    BritishDirector40267750001
    KAYSER, Michael Arthur
    17 Hartsbourne Avenue
    WD23 1JP Bushey Heath
    Hertfordshire
    Director
    17 Hartsbourne Avenue
    WD23 1JP Bushey Heath
    Hertfordshire
    United KingdomBritishCompany Director141893610001
    MADELEY, Sydney John, Dr
    46b Hampton Lane
    B91 2PZ Solihull
    West Midlands
    Director
    46b Hampton Lane
    B91 2PZ Solihull
    West Midlands
    UkBritishChartered Engineer51063290002
    MARTON, Richard Egerton Christopher
    Capernwray
    6 Kier Park
    SL5 7DS Ascot
    Berkshire
    Director
    Capernwray
    6 Kier Park
    SL5 7DS Ascot
    Berkshire
    BritishCompany Director34653220001
    MCCASLIN, Stuart David
    Victoria House 27 Victoria Road
    B50 4AS Bidford On Avon
    Warwickshire
    Director
    Victoria House 27 Victoria Road
    B50 4AS Bidford On Avon
    Warwickshire
    EnglandBritishChartered Secretary1824650002
    MCCOMASKY, James Anthony
    123 Old Bath Road
    GL53 7DH Cheltenham
    Gloucestershire
    Director
    123 Old Bath Road
    GL53 7DH Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritishChartered Accountant148271070001
    NEWLANDS, David Baxter
    Lane End Chucks Lane
    Walton-On-The-Hill
    KT20 7UB Tadworth
    Surrey
    Director
    Lane End Chucks Lane
    Walton-On-The-Hill
    KT20 7UB Tadworth
    Surrey
    EnglandBritishChartered Accountant14918650001
    PAGE, Gordon Francis De Courcy
    Avrillian
    Woodland Walk
    BH22 9LP Ferndown
    Dorset
    Director
    Avrillian
    Woodland Walk
    BH22 9LP Ferndown
    Dorset
    BritishCompany Director5105910002
    ROBERTSON, Douglas Grant
    Blackmore Grange
    Blackmore End
    WR8 0EE Hanley Swan
    Worcestershire
    Director
    Blackmore Grange
    Blackmore End
    WR8 0EE Hanley Swan
    Worcestershire
    EnglandBritishChartered Accountant123487130001
    RODGERS, Neil Anthony
    Latchmere Green
    Little London
    RG26 5EJ Tadley
    Abbots Dwell
    Hampshire
    Uk
    Director
    Latchmere Green
    Little London
    RG26 5EJ Tadley
    Abbots Dwell
    Hampshire
    Uk
    EnglandBritishGroup Finance Director136538310002
    SELWAY, Mark Wayne
    Flat 5-4
    5 South Frederick Street
    G1 1JG Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    Flat 5-4
    5 South Frederick Street
    G1 1JG Glasgow
    Lanarkshire
    United KingdomAustralianDirector105098120001

    ¿Tiene FLEETSBRIDGE RANDALL LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 31 oct 2008
    Entregado el 07 nov 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Burdale Financial Limited as Security Trustee for the Finance Parties
    Transacciones
    • 07 nov 2008Registro de un cargo (395)
    • 19 ene 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 22 dic 2005
    Entregado el 06 ene 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Legal mortgage all f/h and l/h property,first fixed charge all the subsidiary shares and investments,all other interests in any f/h or l/h property,the buildings and fixtures (including trade fixtures) on that property,all proceeds of sale derived therefrom. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The "Security Trustee")
    Transacciones
    • 06 ene 2006Registro de un cargo (395)
    • 28 ene 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Equitable mortgage of shares
    Creado el 28 feb 2005
    Entregado el 21 jun 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and from the borrower to any of the security beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The present security being the right, title and interest to or in the shares, the new rights and all of the future security. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lehman Commercial Paper Inc. (The Security Agent)
    Transacciones
    • 21 jun 2005Registro de un cargo (395)
    • 25 mar 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Security accession deed between the company,seton house group limited (the "parent") and lehman commercial paper inc (the "security agent") supplemental to a debenture dated 4 july 2001
    Creado el 23 ago 2001
    Entregado el 31 ago 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All money or liabilities due or to become due from any charging company (as defined) or any other obligor (as defined) to any secured party (as defined) under any finance document (as defined) on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lehman Commercial Paper Inc.
    Transacciones
    • 31 ago 2001Registro de un cargo (395)
    • 21 nov 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Notice of assignment
    Creado el 04 nov 1986
    Entregado el 24 nov 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a loan of £9,102,324.44
    Breve descripción
    Assignment to the chargee of all the chargers right title and interest in and to all sums from time to time standing to the credit of a call deposit account of the charger with the chargee.
    Personas con derecho
    • Samuel Montague & Co Limited
    Transacciones
    • 24 nov 1986Registro de una carga
    Deed of charge
    Creado el 21 dic 1984
    Entregado el 10 ene 1985
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed charge on all book and other debts now and form time to time due or owing the company.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 10 ene 1985Registro de una carga
    Legal charge
    Creado el 20 sept 1982
    Entregado el 30 sept 1982
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H 61, bay lane, atherton, greater manchester.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank LTD
    Transacciones
    • 30 sept 1982Registro de una carga
    • 03 abr 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 20 sept 1982
    Entregado el 30 sept 1982
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H land & premises at bay lane, atherton, greater manchester.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank LTD
    Transacciones
    • 30 sept 1982Registro de una carga
    • 03 abr 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0