FIRTH RIXSON AURORA LIMITED

FIRTH RIXSON AURORA LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaFIRTH RIXSON AURORA LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00201071
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de FIRTH RIXSON AURORA LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra FIRTH RIXSON AURORA LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Firth Rixson House
    26a Atlas Way
    S4 7QQ Sheffield
    South Yorkshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de FIRTH RIXSON AURORA LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    AURORA PLC29 jun 198229 jun 1982
    AURORA PLC17 oct 192417 oct 1924

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de FIRTH RIXSON AURORA LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 sept 2013

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para FIRTH RIXSON AURORA LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para FIRTH RIXSON AURORA LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    5 páginas4.71

    Nombramiento de Kay Louise Dowdall como director el 20 nov 2014

    3 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Peter Simon Bland como director el 20 nov 2014

    2 páginasTM01

    Cancelación total de la carga 5

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 4

    4 páginasMR04

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 29 ago 2014

    LRESSP

    Déclaration annuelle établie au 31 jul 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital14 ago 2014

    Estado de capital el 14 ago 2014

    • Capital: GBP 29,288,427.9
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2013

    14 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 31 jul 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital08 ago 2013

    Estado de capital el 08 ago 2013

    • Capital: GBP 29,288,427.9
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2012

    15 páginasAA

    Domicilio social registrado cambiado de * Firth House P.O. Box 644 Meadowhall Road Sheffield South Yorkshire S9 1JD* el 16 ene 2013

    1 páginasAD01

    legacy

    15 páginasMG01

    Déclaration annuelle établie au 31 jul 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cambio de datos del secretario Christopher David Seymour el 31 jul 2012

    1 páginasCH03

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2011

    15 páginasAA

    Memorándum y Estatutos

    5 páginasMEM/ARTS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución del Memorándum de Asociación

    RES01

    Déclaration annuelle établie au 31 jul 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01

    Cambio de datos del secretario Christopher David Seumour el 31 jul 2011

    1 páginasCH03

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2010

    15 páginasAA

    Cese del nombramiento de James Hart como director

    2 páginasTM01

    Nombramiento de Christopher David Seumour como secretario

    3 páginasAP03

    ¿Quiénes son los directivos de FIRTH RIXSON AURORA LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    SEYMOUR, Christopher David
    26a Atlas Way
    S4 7QQ Sheffield
    Firth Rixson House
    South Yorkshire
    England
    Secretario
    26a Atlas Way
    S4 7QQ Sheffield
    Firth Rixson House
    South Yorkshire
    England
    British158366440002
    DOWDALL, Kay Louise, Dr
    26a Atlas Way
    S4 7QQ Sheffield
    Firth Rixson House
    South Yorkshire
    Director
    26a Atlas Way
    S4 7QQ Sheffield
    Firth Rixson House
    South Yorkshire
    United KingdomBritish82722960002
    SEYMOUR, Christopher David
    26a Atlas Way
    S4 7QQ Sheffield
    Firth Rixson House
    South Yorkshire
    England
    Director
    26a Atlas Way
    S4 7QQ Sheffield
    Firth Rixson House
    South Yorkshire
    England
    EnglandBritish158310680001
    BERGIN, John Charles Michael Francis
    24 Northgate
    Tickhill
    DN11 9HY Doncaster
    South Yorkshire
    Secretario
    24 Northgate
    Tickhill
    DN11 9HY Doncaster
    South Yorkshire
    British12452990001
    COOMER, John Andrew
    12 Chorley Avenue
    S10 3RP Sheffield
    Secretario
    12 Chorley Avenue
    S10 3RP Sheffield
    British37571230001
    DUNLEVY, Terence Francis
    123 Knowle Lane
    S11 9SN Sheffield
    South Yorkshire
    Secretario
    123 Knowle Lane
    S11 9SN Sheffield
    South Yorkshire
    Australian987090002
    HART, James Thomas
    Firth House P.O. Box 644
    Meadowhall Road
    S9 1JD Sheffield
    South Yorkshire
    Secretario
    Firth House P.O. Box 644
    Meadowhall Road
    S9 1JD Sheffield
    South Yorkshire
    British115557140002
    PILGRIM, Roy Malcolm
    Marchwood Roebuck Drive
    NG18 5AW Mansfield
    Nottinghamshire
    Secretario
    Marchwood Roebuck Drive
    NG18 5AW Mansfield
    Nottinghamshire
    British1790630001
    WILSON, Peter William Frederick
    Leigh Cottage 10 Slayleigh Lane
    Fulwood
    S10 3RF Sheffield
    South Yorkshire
    Secretario
    Leigh Cottage 10 Slayleigh Lane
    Fulwood
    S10 3RF Sheffield
    South Yorkshire
    British987080001
    BERGIN, John Charles Michael Francis
    24 Northgate
    Tickhill
    DN11 9HY Doncaster
    South Yorkshire
    Director
    24 Northgate
    Tickhill
    DN11 9HY Doncaster
    South Yorkshire
    EnglandBritish12452990001
    BLAND, Peter Simon
    26a Atlas Way
    S4 7QQ Sheffield
    Firth Rixson House
    South Yorkshire
    England
    Director
    26a Atlas Way
    S4 7QQ Sheffield
    Firth Rixson House
    South Yorkshire
    England
    United KingdomBritish42351130005
    BRIGHTMORE, Eric Arthur
    6 Kilburn Road
    Dronfield Woodhouse
    S18 5QA Sheffield
    South Yorkshire
    Director
    6 Kilburn Road
    Dronfield Woodhouse
    S18 5QA Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritish1435570001
    BUNYON, Ross Murdoch
    132 Morshead Drive
    2220 Hurstville Grove
    Nsw
    Australia
    Director
    132 Morshead Drive
    2220 Hurstville Grove
    Nsw
    Australia
    Australian58154840001
    CASTAN, George
    26 Coppin Grove
    3122 Hawthorn
    Victoria
    Australia
    Director
    26 Coppin Grove
    3122 Hawthorn
    Victoria
    Australia
    Australian62993940001
    DUNLEVY, Terence Francis
    123 Knowle Lane
    S11 9SN Sheffield
    South Yorkshire
    Director
    123 Knowle Lane
    S11 9SN Sheffield
    South Yorkshire
    Australian987090002
    FITCH, Peter George Edward
    3 Ridge Lane
    New Lambton Heights
    New South Wales
    Nsw 2305
    Australia
    Director
    3 Ridge Lane
    New Lambton Heights
    New South Wales
    Nsw 2305
    Australia
    Australian34075380002
    HALL, David John
    Craglands
    Ashopton Road, Bamford
    S33 0DB Hope Valley
    Derbyshire
    Director
    Craglands
    Ashopton Road, Bamford
    S33 0DB Hope Valley
    Derbyshire
    British40070600001
    HART, James Thomas
    Firth House P.O. Box 644
    Meadowhall Road
    S9 1JD Sheffield
    South Yorkshire
    Director
    Firth House P.O. Box 644
    Meadowhall Road
    S9 1JD Sheffield
    South Yorkshire
    United KingdomBritish115557140002
    MACDONALD, Neil Andrew
    21 Clarendon Road
    S10 3TQ Sheffield
    South Yorkshire
    Director
    21 Clarendon Road
    S10 3TQ Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritish3696630003
    NEWMAN, Peter John
    1 Riverside Crescent
    DE45 1HF Bakewell
    Derbyshire
    Director
    1 Riverside Crescent
    DE45 1HF Bakewell
    Derbyshire
    British77363340001
    PILGRIM, Roy Malcolm
    Marchwood Roebuck Drive
    NG18 5AW Mansfield
    Nottinghamshire
    Director
    Marchwood Roebuck Drive
    NG18 5AW Mansfield
    Nottinghamshire
    British1790630001
    READING, Paul George
    52a Parriwi Road
    FOREIGN Mosman
    New South Wales 2088
    Australia
    Director
    52a Parriwi Road
    FOREIGN Mosman
    New South Wales 2088
    Australia
    New Zealander35821240001
    REES, Henry Evan
    14 Julian Street
    Mosman New South Wales 2088
    FOREIGN
    Australia
    Director
    14 Julian Street
    Mosman New South Wales 2088
    FOREIGN
    Australia
    Australian1853660001
    ROBINSON, Gregory Allan
    87 Hallamshire Road
    S10 4FN Sheffield
    South Yorkshire
    Director
    87 Hallamshire Road
    S10 4FN Sheffield
    South Yorkshire
    Australia55134620001
    SANDOW, Maxwell Thomas
    314 Hudson Parade
    Clareville Beach New South Wales 2107
    FOREIGN
    Australia
    Director
    314 Hudson Parade
    Clareville Beach New South Wales 2107
    FOREIGN
    Australia
    Australian20205310001
    SCOTT, Bryan
    3 Majura Close
    2075 St Ives
    Nsw
    Australia
    Director
    3 Majura Close
    2075 St Ives
    Nsw
    Australia
    Australian/British58155920001
    SHEEHAN, Alan John
    2 Dore Road
    Dore
    S17 3NB Sheffield
    Yorkshire
    Director
    2 Dore Road
    Dore
    S17 3NB Sheffield
    Yorkshire
    British75517320001
    SMORGON, Graham Joseph
    2 Linlithgow Road
    3142 Toorak
    Victoria
    Australia
    Director
    2 Linlithgow Road
    3142 Toorak
    Victoria
    Australia
    Australian62996170001
    STANCLIFFE, Peter William
    1895 Pittwater Road
    Bayview New South Wales
    FOREIGN Nsw 2104 Australia
    Director
    1895 Pittwater Road
    Bayview New South Wales
    FOREIGN Nsw 2104 Australia
    British47330950001
    WILSON, Peter William Frederick
    Leigh Cottage 10 Slayleigh Lane
    Fulwood
    S10 3RF Sheffield
    South Yorkshire
    Director
    Leigh Cottage 10 Slayleigh Lane
    Fulwood
    S10 3RF Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritish987080001

    ¿Tiene FIRTH RIXSON AURORA LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 07 dic 2012
    Entregado el 11 dic 2012
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 11 dic 2012Registro de un cargo (MG01)
    • 20 nov 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Security accession deed
    Creado el 20 dic 2007
    Entregado el 29 dic 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become from any charging company or any other obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over all property and assets present and future including bookdebts uncalled capital buildings fixtures plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lehman Brothers International (Europe) (Security Agent)
    Transacciones
    • 29 dic 2007Registro de un cargo (395)
    • 20 nov 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 07 sept 2006
    Entregado el 20 sept 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lehman Brothers International (Europe), as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties (the Security Agent)
    Transacciones
    • 20 sept 2006Registro de un cargo (395)
    • 11 feb 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Security accession deed
    Creado el 21 feb 2003
    Entregado el 27 feb 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All money or liabilities due or to become due from any charging company or any other obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed charge over all properties listed in schedule with all buildings and fixtures thereon and by way of first equitable charge over all subsidiary shares,investments and all distribution rights and all freehold/leasehold property not charged pursuant to clause 2.3(a) of the deed; all book debts,rights and claims,all monetary claims and monies standing to the credit of its accounts; the goodwill and uncalled capital; floating charge over all assets; see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland,London,as Security Trustee for Itself and Theother Secured Parties
    Transacciones
    • 27 feb 2003Registro de un cargo (395)
    • 05 oct 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Agreement
    Creado el 05 ago 1983
    Entregado el 05 ago 1983
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 05 ago 1983Registro de una carga

    ¿Tiene FIRTH RIXSON AURORA LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    29 ago 2014Inicio de la liquidación
    04 feb 2016Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Peter James Greaves
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Profesional
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Timothy Gerard Walsh
    Benson House
    33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    Profesional
    Benson House
    33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0