SITA CONTAINERS LIMITED

SITA CONTAINERS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSITA CONTAINERS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00208371
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de SITA CONTAINERS LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra SITA CONTAINERS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Sita House
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Berkshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SITA CONTAINERS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    A & J BULL CONTAINERS LIMITED02 jun 200002 jun 2000
    MARCO(CROYDON)LIMITED12 sept 192512 sept 1925

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de SITA CONTAINERS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2011

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para SITA CONTAINERS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    4 páginasDS01

    Cese del nombramiento de Mark Hedley Thompson como director el 31 oct 2013

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 12 jul 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital20 sept 2013

    Estado de capital el 20 sept 2013

    • Capital: GBP 1
    SH01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 21 dic 2012

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    legacy

    3 páginasMG04

    legacy

    3 páginasMG04

    Cambio de nombre o denominación de la clase de acciones

    2 páginasSH08

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Dividend shares 01/11/2012
    RES13
    capital

    Resolución de variación de los derechos o del nombre de las acciones

    RES12

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2011

    6 páginasAA

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Dividend approved and copy of res sent to auditors 19/07/2012
    RES13
    capital

    Resolución de variación de los derechos o del nombre de las acciones

    RES12

    Cambio de nombre o denominación de la clase de acciones

    2 páginasSH08

    Cambio de datos del director Mr Christophe Andre Bernard Chapron el 26 jun 2012

    2 páginasCH01

    Déclaration annuelle établie au 12 jul 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cambio de datos del director Mr Mark Hedley Thompson el 27 ene 2012

    2 páginasCH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2010

    7 páginasAA

    Nombramiento de Mr Mark Hedley Thompson como director el 01 sept 2010

    2 páginasAP01

    Déclaration annuelle établie au 12 jul 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Nombramiento de Mr David Courtenay Palmer-Jones como director

    2 páginasAP01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2009

    7 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 12 jul 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    ¿Quiénes son los directivos de SITA CONTAINERS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    KNIGHT, Joan
    Sita House
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Berkshire
    Secretario
    Sita House
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Berkshire
    British80543820001
    CHAPRON, Christophe Andre Bernard
    Sita House
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Berkshire
    Director
    Sita House
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Berkshire
    EnglandFrench122645500003
    PALMER-JONES, David Courtenay
    Sita House
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Berkshire
    Director
    Sita House
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Berkshire
    United KingdomBritish125070620001
    COOPER, Elizabeth Jayne Clare
    39 Church Road
    LU5 6LE Harlington
    Bedfordshire
    Secretario
    39 Church Road
    LU5 6LE Harlington
    Bedfordshire
    British3540250005
    LEWIS, Jack Malcolm
    Saddlers Croft Road
    TN6 1DS Crowborough
    East Sussex
    Secretario
    Saddlers Croft Road
    TN6 1DS Crowborough
    East Sussex
    British14038510001
    CARTWRIGHT, Keith Charles
    Redwood Cottage Church Way
    Hurst Green
    RH8 9EA Oxted
    Surrey
    Director
    Redwood Cottage Church Way
    Hurst Green
    RH8 9EA Oxted
    Surrey
    EnglandBritish14038540002
    GOODFELLOW, Ian Frederick
    Highlands Harewood Drive
    Cold Ash
    RG18 9PF Thatcham
    Berkshire
    Director
    Highlands Harewood Drive
    Cold Ash
    RG18 9PF Thatcham
    Berkshire
    EnglandBritish28725450004
    GORDON, Marek Robert
    7 Woodbank Avenue
    SL9 7PY Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Director
    7 Woodbank Avenue
    SL9 7PY Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandBritish20420300002
    MILLS, Stephen Terence
    Bonnibur Copthill Lane
    Kingswood
    KT20 6HL Tadworth
    Surrey
    Director
    Bonnibur Copthill Lane
    Kingswood
    KT20 6HL Tadworth
    Surrey
    EnglandBritish14038520001
    MILLS, Terrence George
    Headley Hill House Lorretta Lodge
    Tilley Lane, Headley
    KT18 6EP Epsom
    Surrey
    Director
    Headley Hill House Lorretta Lodge
    Tilley Lane, Headley
    KT18 6EP Epsom
    Surrey
    British71438230001
    MOXON, Terrence Frederick
    19 Pointers Hill
    RH4 3PF Westcott
    Surrey
    Director
    19 Pointers Hill
    RH4 3PF Westcott
    Surrey
    British14174250001
    SCARBOROUGH, Philip John
    Galedon House
    Hogs Back, Seale
    GU10 1JX Farnham
    Surrey
    Director
    Galedon House
    Hogs Back, Seale
    GU10 1JX Farnham
    Surrey
    EnglandBritish71437540001
    SEXTON, Ian Anthony
    31 Dedmere Road
    SL7 1PE Marlow
    Buckinghamshire
    Director
    31 Dedmere Road
    SL7 1PE Marlow
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish33971310004
    SHERWIN, David Andrew
    212 Ferrymead Avenue
    Greenford
    UB6 9TP Middlesex
    Director
    212 Ferrymead Avenue
    Greenford
    UB6 9TP Middlesex
    British10025660001
    THOMPSON, Mark Hedley
    Sita House
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Berkshire
    Director
    Sita House
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Berkshire
    EnglandBritish162837220002
    WATKINS, Steven Thomas
    42 Pauls Place
    KT21 1HN Ashtead
    Surrey
    Director
    42 Pauls Place
    KT21 1HN Ashtead
    Surrey
    EnglandBritish53589530002

    ¿Tiene SITA CONTAINERS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Mortgage
    Creado el 19 dic 1996
    Entregado el 20 dic 1996
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The f/h property k/a 63 hampton road croydon t/n SY71139 together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon fixed charge all present and future book and other debts assigns the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 20 dic 1996Registro de un cargo (395)
    • 05 dic 2012Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad gravada ha sido liberada (MG04)
    Mortgage
    Creado el 19 dic 1996
    Entregado el 20 dic 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The f/h property being 73 hampton road croydon together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon fixed charge all present and future book and other debts assigns the goodwill of the busines (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 20 dic 1996Registro de un cargo (395)
    • 04 ago 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage
    Creado el 19 dic 1996
    Entregado el 20 dic 1996
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The f/h property k/a 33 and 35 hampton road croydon t/n SY275017 together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon fixed charge all present and future book and other debts assigns the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 20 dic 1996Registro de un cargo (395)
    • 05 dic 2012Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad gravada ha sido liberada (MG04)
    Debenture
    Creado el 19 dic 1996
    Entregado el 20 dic 1996
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 20 dic 1996Registro de un cargo (395)
    Mortgage debenture
    Creado el 22 mar 1976
    Entregado el 31 mar 1976
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    33, 35, 47, 51, 63, 65, 67, 73 hampton road, croydon. Land on the south west side of hampton road, croydon 49 to 67 (add nos) hanpton road croydon fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital. (See doc 99 for full details).
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank LTD
    Transacciones
    • 31 mar 1976Registro de una carga
    • 03 jul 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0