SELECTA UK HOLDING LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | SELECTA UK HOLDING LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 00209116 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de SELECTA UK HOLDING LIMITED?
- Actividades de otras sociedades holding n.c.o.p. (64209) / Actividades financieras y de seguros
¿Dónde se encuentra SELECTA UK HOLDING LIMITED?
| Dirección de la sede social | 1 Finway Road Finway Road Hemel Hempstead Industrial Estate HP2 7PT Hemel Hempstead Hertfordshire England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SELECTA UK HOLDING LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| PELICAN ROUGE COFFEE SOLUTIONS GROUP LIMITED | 27 oct 2014 | 27 oct 2014 |
| AUTOBAR GROUP LIMITED | 31 dic 1980 | 31 dic 1980 |
| REMFIELD TRUST LIMITED | 19 oct 1925 | 19 oct 1925 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de SELECTA UK HOLDING LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para SELECTA UK HOLDING LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 08 mar 2027 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 22 mar 2027 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 08 mar 2026 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para SELECTA UK HOLDING LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Declaración de confirmación presentada el 08 mar 2026 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cessation de Kkr & Co.L.P. en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 11 jun 2025 | 1 páginas | PSC07 | ||
Notification de Seagull Bidco Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 11 jun 2025 | 2 páginas | PSC02 | ||
Nombramiento de Mr Douglas Lindsay Hogg como director el 19 feb 2026 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Paul Nathaniel Ian Hearne como director el 19 feb 2026 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Christopher William Ellis como director el 12 sept 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2024 | 29 páginas | AA | ||
Registro de la carga 002091160011, creada el 11 jun 2025 | 40 páginas | MR01 | ||
Cancelación total de la carga 002091160010 | 1 páginas | MR04 | ||
Cancelación total de la carga 002091160008 | 1 páginas | MR04 | ||
Cancelación total de la carga 002091160009 | 1 páginas | MR04 | ||
Declaración de confirmación presentada el 08 mar 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2023 | 29 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Timothy Stephen Goldsmith como director el 21 may 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr Christopher William Ellis como director el 21 may 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 08 mar 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2022 | 33 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 08 mar 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Nicole Charriere Roos como director el 22 mar 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr Timothy Stephen Goldsmith como director el 20 mar 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2021 | 35 páginas | AA | ||
Domicilio social registrado cambiado de Apollo House Odyssey Business Park West End Road Ruislip Middlesex HA4 6QD England a 1 Finway Road Finway Road Hemel Hempstead Industrial Estate Hemel Hempstead Hertfordshire HP2 7PT el 14 nov 2022 | 1 páginas | AD01 | ||
Cese del nombramiento de Philippe Gautier como director el 14 oct 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Ms Nicole Charriere Roos como director el 14 oct 2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 08 mar 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
¿Quiénes son los directivos de SELECTA UK HOLDING LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOGG, Douglas Lindsay | Director | c/o Seagull Bidco Limited Basepoint, Shearway Business Park Shearway Road CT19 4RH Folkestone Xeinadin South East Limited Unit 68 Kent England | Scotland | British | 175195450002 | |||||
| VENUS, Toby | Director | Finway Road Hemel Hempstead Industrial Estate HP2 7PT Hemel Hempstead 1 Finway Road Hertfordshire England | England | British | 275668090001 | |||||
| GREENWOOD, Michael Frank | Secretario | Gloucester Road Kew TW9 3BT Richmond 51 Surrey | British | 90910000002 | ||||||
| MCKAY, William Trevor | Secretario | 1 West Court HA0 3QQ North Wembley Middlesex | British | 588890001 | ||||||
| ABRAHAMS, Daniel Henry | Director | Odyssey Business Park West End Road HA4 6QD Ruislip Apollo House Middlesex England | England | British | 183822370001 | |||||
| ABU SUUD, Walid Khaled | Director | Flat 4 30 Cadogan Place SW1X 9RX London | Kuwaiti | 41043890001 | ||||||
| AL BADER, Ahmad Abdulla | Director | Kuwait Investment Authority Ministries Complex Block 3 PO BOX 64 Safat 13007 State Of Kuwait | Kuwaiti | 90877720001 | ||||||
| AL-AWADI, Yousef Abdullah, Dr | Director | Kuwait Investment Authority Ministries Complex, Block 3 P O Box 64 Safat 13007 State Of Kuwait | Kuwaiti | 49545810006 | ||||||
| AL-HATHAL, Nafel | Director | Flat 10 15 Ruthland Gate SW7 London | British | 34209280001 | ||||||
| AL-MUDHAF, Tareq Abdullah | Director | Flat 16 5 Park St James Prince Albert Road NW8 7LE London | Kuwaiti | 54726190001 | ||||||
| AL-SHARHAN, Anwar Abdulmuhsen | Director | 19 High Meadow Stortford Road CM6 1UG Great Dunmore | Kuwaiti | 34209090002 | ||||||
| AL-SHAYJI, Saud Abdulaziz | Director | Flat 2 15 Herbert Crescent Knightsbridge SW3 London | Kuwaiti | 25871210001 | ||||||
| ALATIQI, Imad Mohamed, Dr | Director | Kuwait University College Of Engineering & Petroleum Building 8-Kh, 5th Floor Khaldia State Of Kuwait | Kuwait | 90957730001 | ||||||
| ALDRED, Duncan | Director | Penwood Penwood End GU22 0JU Woking Surrey | England | British | 151584290001 | |||||
| ARENDS, Ricardo Jose | Director | Odyssey Business Park West End Road HA4 6QD Ruislip Apollo House Middlesex England | United Kingdom | British | 186756390001 | |||||
| ARMSTRONG, Stephen Derek | Director | Main Street Kirklington NG22 8NN Nr Newark Hall Farm Nottinghamshire Uk | England | British | 180767850001 | |||||
| ASTON, Edward | Director | Odyssey Business Park West End Road HA4 6QD Ruislip Apollo House Middlesex England | England | British | 269240860001 | |||||
| BASTAKI, Farouk Ali | Director | Ministries Complex Block 3 PO BOX 64 Kuwait Kuwait Investment Authority 13001 Kuwait | Kuwait | Kuwaiti | 136744910001 | |||||
| BETTS, David Roland | Director | 35 High Street Foxton CB2 6SP Cambridge | British | 33369690001 | ||||||
| BEYENS, Alain Henri Gaston Guy | Director | East Wing 14th Floor 389 Chiswick High Road W4 4AJ Chiswick London | United Kingdom | Belgian | 173399130001 | |||||
| BRISTOW, Andrew Wyatt | Director | Garden Road BR1 3LX Bromley 22 Kent | England | British | 8748280008 | |||||
| CHARRIERE ROOS, Nicole | Director | Finway Road Hemel Hempstead Industrial Estate HP2 7PT Hemel Hempstead 1 Finway Road Hertfordshire England | Switzerland | Swiss | 297571080001 | |||||
| DARWENT, James | Director | Jocelyn Road TW9 2TJ Richmond 29 Surrey | United Kingdom | British | 128153210003 | |||||
| DAVEY, Michael John | Director | 225 Sheen Lane East Sheen SW14 8LE London | United Kingdom | British | 976330001 | |||||
| ELLIS, Christopher William | Director | Finway Road Hemel Hempstead Industrial Estate HP2 7PT Hemel Hempstead 1 Finway Road Hertfordshire England | England | British | 323515960001 | |||||
| FIELDER, Christopher Francis | Director | 5 The Brambles SG1 4AU Stevenage Hertfordshire | British | 5837810001 | ||||||
| FLOCHEL, David Christophe Marc | Director | Hinterbergstrasse 6330 Cham 20 Switzerland | Switzerland | French | 238363320001 | |||||
| GAUTIER, Philippe | Director | Odyssey Business Park West End Road HA4 6QD Ruislip Apollo House Middlesex England | France | French | 277154610001 | |||||
| GEYSELS, Kris Paul Ludo | Director | Odyssey Business Park West End Road HA4 6QD Ruislip Apollo House Middlesex England | Belgium | Belgian | 193655140001 | |||||
| GOLDSMITH, Timothy Stephen | Director | Finway Road Hemel Hempstead Industrial Estate HP2 7PT Hemel Hempstead 1 Finway Road Hertfordshire England | England | British | 307432700001 | |||||
| GREENWOOD, Michael Frank | Director | Gloucester Road Kew TW9 3BT Richmond 51 Surrey | United Kingdom | British | 90910000002 | |||||
| HEARNE, Paul Nathaniel Ian, Mr. | Director | Finway Road Hemel Hempstead Industrial Estate HP2 7PT Hemel Hempstead 1 Finway Road Hertfordshire England | England | British | 124527170003 | |||||
| HEARNE, Paul Nathaniel Ian, Mr. | Director | Odyssey Business Park West End Road HA4 6QD Ruislip Apollo House Middlesex England | England | British | 124527170003 | |||||
| JOHNS, Ian Francis | Director | 3 Mistletoe Close Shirley Oaks CR0 8YE Croydon Surrey | United Kingdom | British | 112454960001 | |||||
| JONES, Glyn Anthony | Director | East Wing 14th Floor 389 Chiswick High Road W4 4AJ Chiswick London | United Kingdom | British | 173742060001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de SELECTA UK HOLDING LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seagull Bidco Limited | 11 jun 2025 | Shearway Road CT19 4RH Folkestone C/O Xeinadin South East Limited Unit 68, Basepoint England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Kkr & Co.L.P. | 06 abr 2016 | Suite 4200 New York 9 West 57th Street Ny 10019 United States | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0