LEGG MASON INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED

LEGG MASON INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaLEGG MASON INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00211513
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de LEGG MASON INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED?

    • Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra LEGG MASON INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    92 London Street
    RG1 4SJ Reading
    Berkshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de LEGG MASON INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    JOHNSON FRY HOLDINGS PLC13 ene 199413 ene 1994
    LIT HOLDINGS PLC08 mar 198808 mar 1988
    LONDON INVESTMENT TRUST PLC(THE)31 dic 197731 dic 1977
    CATEL TRUST LIMITED04 feb 192604 feb 1926

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de LEGG MASON INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2016

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para LEGG MASON INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    15 páginasLIQ13

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 01 mar 2018

    13 páginasLIQ03

    Domicilio social registrado cambiado de 201 Bishopsgate London England EC2M 3AB a 92 London Street Reading Berkshire RG1 4SJ el 17 mar 2017

    2 páginasAD01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 02 mar 2017

    LRESSP

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2016

    19 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 17 jun 2016 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital21 jun 2016

    Estado de capital el 21 jun 2016

    • Capital: GBP 5,073,685.6
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2015

    15 páginasAA

    Nombramiento de Director Anita Connolly como director el 01 oct 2015

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Edward Stephen Squires Venner como director el 01 oct 2015

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 17 jun 2015 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital29 jun 2015

    Estado de capital el 29 jun 2015

    • Capital: GBP 5,073,685.6
    SH01

    Déclaration annuelle établie au 17 jun 2014 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital29 ago 2014

    Estado de capital el 29 ago 2014

    • Capital: GBP 5,073,685.6
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2014

    16 páginasAA

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2013

    13 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 17 jun 2013 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital08 jul 2013

    Estado de capital el 08 jul 2013

    • Capital: GBP 5,073,685.6
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2012

    12 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 17 jun 2012 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01

    Cambio de datos del director Mr Ian Stephen Goodhew el 01 jun 2012

    2 páginasCH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2011

    14 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 17 jun 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01

    Domicilio social registrado cambiado de * 75 King William Street London EC4N 7BE* el 09 may 2011

    1 páginasAD01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2010

    14 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 17 jun 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    ¿Quiénes son los directivos de LEGG MASON INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    CONNOLLY, Anita, Director
    London Street
    RG1 4SJ Reading
    92
    Berkshire
    Director
    London Street
    RG1 4SJ Reading
    92
    Berkshire
    United KingdomIrish99214840001
    GOODHEW, Ian Stephen
    London Street
    RG1 4SJ Reading
    92
    Berkshire
    Director
    London Street
    RG1 4SJ Reading
    92
    Berkshire
    EnglandBritish36704030003
    GILDERSLEEVES, Paul Simon
    The Old Stables
    The Green
    OX12 0EU Charney Bassett
    Oxfordshire
    Secretario
    The Old Stables
    The Green
    OX12 0EU Charney Bassett
    Oxfordshire
    British11307070002
    GOODHEW, Ian Stephen
    16 College Gardens
    SE21 7BE London
    Secretario
    16 College Gardens
    SE21 7BE London
    British36704030003
    LLEWELLYN, Anthony
    10 Glenwood House
    127 Leicester Road
    EN5 5EA Barnet
    Hertfordshire
    Secretario
    10 Glenwood House
    127 Leicester Road
    EN5 5EA Barnet
    Hertfordshire
    British38515170001
    LEGG MASON INVESTMENTS SECRETARIES LIMITED
    75 King William Street
    EC4N 7BE London
    Secretario corporativo
    75 King William Street
    EC4N 7BE London
    33216460026
    ALTHAM, Alastair John Livingstone
    1 Devereux Road
    SW11 6JR London
    Director
    1 Devereux Road
    SW11 6JR London
    British53456190002
    BACKHOUSE, David Miles
    South Farm House
    Hatherop
    GL7 3PN Cirencester
    Gloucestershire
    Director
    South Farm House
    Hatherop
    GL7 3PN Cirencester
    Gloucestershire
    United KingdomBritish407140001
    BALSAMO, Stephen Dennis
    620 Gregory Avenue
    Wilmette
    Illinois 60091
    Usa
    Director
    620 Gregory Avenue
    Wilmette
    Illinois 60091
    Usa
    American32994360001
    BOTTS, John Chester
    21 Argyll Road
    W8 7DA London
    Director
    21 Argyll Road
    W8 7DA London
    United KingdomAmerican2943960001
    BOUGHTON, Paul Lindsay
    Gandish House
    Gandish Road
    CO7 6UR East Bergholt
    Suffolk
    Director
    Gandish House
    Gandish Road
    CO7 6UR East Bergholt
    Suffolk
    British141421890001
    CASTLEMAN, Christopher Norman Anthony
    182 Kensington Park Road
    W11 2ER London
    Director
    182 Kensington Park Road
    W11 2ER London
    British11677630001
    CHOWDHURY, Deepak
    214 Wendover Road
    Baltimore
    IRISH Maryland
    21218
    United States
    Director
    214 Wendover Road
    Baltimore
    IRISH Maryland
    21218
    United States
    United States84272030002
    DIMSEY, Kathryn Jane
    Summercourt Cottage
    Kemsing Road Wrotham
    TN15 7BP Sevenoaks
    Kent
    Director
    Summercourt Cottage
    Kemsing Road Wrotham
    TN15 7BP Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritish98113510002
    FIRTH MCGUCKIN, Lindsay Peta
    6 Northcote Road
    TW1 1PA Twickenham
    Middlesex
    Director
    6 Northcote Road
    TW1 1PA Twickenham
    Middlesex
    British70682640001
    FLETCHER, Michael Granville
    64 Elms Road
    SW4 9EW London
    Director
    64 Elms Road
    SW4 9EW London
    United KingdomBritish10919860001
    FRY, Charles Anthony
    48 Cadogan Place
    SW1X 9RS London
    Director designado
    48 Cadogan Place
    SW1X 9RS London
    British900005410001
    GILDERSLEEVES, Paul Simon
    The Old Stables
    The Green
    OX12 0EU Charney Bassett
    Oxfordshire
    Director
    The Old Stables
    The Green
    OX12 0EU Charney Bassett
    Oxfordshire
    British11307070002
    GREATREX, Brett
    25 Theobalds Road
    SS9 2NE Leigh On Sea
    Essex
    Director
    25 Theobalds Road
    SS9 2NE Leigh On Sea
    Essex
    British77420520001
    HIRSCHMANN, Thomas John
    3551 Old Trail Road
    Edgewater
    Maryland 21034
    U.S.A
    Director
    3551 Old Trail Road
    Edgewater
    Maryland 21034
    U.S.A
    United StatesAmerican149003850001
    INSKIP, Owen Hampden
    Park Farm
    Shipton Moyne
    GL8 8PR Tetbury
    Gloucestershire
    Director
    Park Farm
    Shipton Moyne
    GL8 8PR Tetbury
    Gloucestershire
    British7941560001
    JOHNSON, Terence Andrew
    Flat 2
    15 Redcliffe Square
    SW10 9JX London
    Director
    Flat 2
    15 Redcliffe Square
    SW10 9JX London
    American116175380001
    KEAN, Dorn Mary
    9 Nutfields
    Ightham
    TN15 9EA Sevenoaks
    Kent
    Director
    9 Nutfields
    Ightham
    TN15 9EA Sevenoaks
    Kent
    British70682750002
    LO, Robert Anthony
    113 Arthur Road
    Wimbledon
    SW19 7DR London
    Director
    113 Arthur Road
    Wimbledon
    SW19 7DR London
    EnglandBritish39029590002
    NEILL, Richard Hugh
    61 Fernlea Road
    Balham
    SW12 9RT London
    Director
    61 Fernlea Road
    Balham
    SW12 9RT London
    British59054140001
    POVALL, Christopher John
    31 Burlington Drive
    Beltinge
    CT6 6PG Herne Bay
    Kent
    Director
    31 Burlington Drive
    Beltinge
    CT6 6PG Herne Bay
    Kent
    EnglandBritish70682420005
    PURDY, Deborah Ann
    30a Sherriff Road
    NW6 2AU London
    Director
    30a Sherriff Road
    NW6 2AU London
    British68400960001
    THOMAS, Rebecca Bronwen Garvey
    Mill House
    Talbot Place
    SE3 0TZ Blackheath
    London
    Director
    Mill House
    Talbot Place
    SE3 0TZ Blackheath
    London
    British59219930008
    TOMAN, Catherine
    24 Winchfield Court
    Winchfield
    RG27 8SP Hook
    Hampshire
    Director
    24 Winchfield Court
    Winchfield
    RG27 8SP Hook
    Hampshire
    British51328180002
    VENNER, Edward Stephen Squires
    Bishopsgate
    EC2M 3AB London
    201
    England
    England
    Director
    Bishopsgate
    EC2M 3AB London
    201
    England
    England
    United KingdomBritish115580140001
    VOGEL, David Joseph
    223 Douglas Road
    Far Hills
    FOREIGN New Jersey 07931
    Usa
    Director
    223 Douglas Road
    Far Hills
    FOREIGN New Jersey 07931
    Usa
    American28970050001
    WHALLEY, Andrew Nicholas
    6 Lynne Walk
    KT10 9DZ Esher
    Surrey
    Director
    6 Lynne Walk
    KT10 9DZ Esher
    Surrey
    British43664020005
    WHITTINGTON, Christopher Mark John
    Southwood Lodge Kingsley Place
    Highgate
    N6 5EA London
    Director
    Southwood Lodge Kingsley Place
    Highgate
    N6 5EA London
    United KingdomBritish1140780001

    ¿Tiene LEGG MASON INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Charge
    Creado el 06 nov 1990
    Entregado el 26 nov 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or dysart developments (tyne & wear) limited pursuant to clouse 8 of a construction agreement dated 22/11/89 to the chargee.
    Breve descripción
    The monies from time to time held in theaccount numbered 12067400 opened by the depositor (defined earlier) with the royal bank of scotland PLC. See doc m 131 for further details.
    Personas con derecho
    • London & Edinburgh Trust PLC
    Transacciones
    • 26 nov 1990Registro de una carga
    • 08 feb 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture deed
    Creado el 10 sept 1990
    Entregado el 17 sept 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from thecompany to the lloyds bank PLC in the capacity as agent and the several banks (as therein defined) (including lloyds bank PLC for its an account and as the agent.) chargee on any account whatsoever.
    Breve descripción
    By way of first fixed charge on all bookdebts both present and future due or owing to the company. By way of a floating charge the undertaking and all property and assets of the company both present and future. (See form 395 for full details.).
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 17 sept 1990Registro de una carga
    • 06 ene 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Security deed
    Creado el 15 ene 1990
    Entregado el 18 ene 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee for itself and as agent for the secured creditors (as defined))
    Breve descripción
    All dividends, rights in respect of the shares, 100 ordinary shares of $1 each in the capital of brent properties limited 2,700,000 ordinary shares of 25 pence each in the capital of international city holdings PLC (see form 395 for full details).
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 18 ene 1990Registro de una carga
    • 06 ene 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene LEGG MASON INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    02 mar 2017Inicio de la liquidación
    23 oct 2018Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    David William Tann
    Wilkins Kennedy Llp
    92 London Street
    RG1 4SJ Reading
    Berkshire
    Profesional
    Wilkins Kennedy Llp
    92 London Street
    RG1 4SJ Reading
    Berkshire
    Matthew John Waghorn
    92 London Street
    RG1 4SJ Reading
    Berkshire
    Profesional
    92 London Street
    RG1 4SJ Reading
    Berkshire

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0