SPIRIT GROUP RETAIL HOTELS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | SPIRIT GROUP RETAIL HOTELS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 00215000 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de SPIRIT GROUP RETAIL HOTELS LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra SPIRIT GROUP RETAIL HOTELS LIMITED?
| Dirección de la sede social | Resolve Partners Limited 22 York Buildings John Adam Street WC2N 6JU London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SPIRIT GROUP RETAIL HOTELS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| SCOTTISH & NEWCASTLE HOTELS LIMITED | 19 ago 1994 | 19 ago 1994 |
| TAMPLIN'S LICENSED PROPERTIES LIMITED | 12 jul 1926 | 12 jul 1926 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de SPIRIT GROUP RETAIL HOTELS LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 22 ago 2015 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para SPIRIT GROUP RETAIL HOTELS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 9 páginas | LIQ13 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 11 ene 2018 | 9 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Resolve Partners Limited 48 Warwick Street London W1B 5NL a Resolve Partners Limited 22 York Buildings John Adam Street London WC2N 6JU el 13 sept 2017 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 02 mar 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Westgate Brewery Bury St Edmunds Suffolk IP33 1QT United Kingdom a Resolve Partners Limited 48 Warwick Street London W1B 5NL el 08 feb 2017 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de solvencia | 3 páginas | 4.70 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 1 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nombramiento de Lindsay Anne Keswick como secretario el 25 abr 2016 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Claire Susan Stewart como secretario el 25 abr 2016 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Sunrise House Ninth Avenue Burton upon Trent Staffordshire DE14 3JZ a Westgate Brewery Bury St Edmunds Suffolk IP33 1QT el 07 mar 2016 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 02 mar 2016 avec liste complète des actionnaires | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 22 ago 2015 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Jonathan Robert Langford como director el 26 ene 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Daryl Antony Kelly como director el 26 ene 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Lucy Jane Bell como director el 26 ene 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Kirk Dyson Davis como director el 21 dic 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Henry Jones como secretario el 04 dic 2015 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Exercice comptable en cours raccourci du 24 ago 2016 au 30 abr 2016 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Patrick James Gallagher como director el 23 jun 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 02 mar 2015 avec liste complète des actionnaires | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 23 ago 2014 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 02 mar 2014 avec liste complète des actionnaires | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 17 ago 2013 | 4 páginas | AA | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de SPIRIT GROUP RETAIL HOTELS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KESWICK, Lindsay Anne | Secretario | 22 York Buildings John Adam Street WC2N 6JU London Resolve Partners Limited | 207523600001 | |||||||
| DAVIS, Kirk Dyson | Director | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 158484730001 | |||||
| ADAMS, Susanne Margaret | Secretario | Azalea 167 High Street Northchurch HP4 3QT Berkhamsted Hertfordshire | British | 28738400002 | ||||||
| CUTHBERTSON, Colin | Secretario | 5 Hill Gardens LE16 9EB Market Harborough Leicestershire | British | 26369940001 | ||||||
| HOMER, Neville Rex | Secretario | Caberfeidh 12 Forth Street EH39 4HY North Berwick East Lothian | British | 895960001 | ||||||
| HOMER, Neville Rex | Secretario | Caberfeidh 12 Forth Street EH39 4HY North Berwick East Lothian | British | 895960001 | ||||||
| JONES, Henry | Secretario | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | 180592260001 | |||||||
| KENDALL, Timothy James | Secretario | 31 Canterbury Close Erdington B23 7QL Birmingham West Midlands | British | 117397470002 | ||||||
| RUDD, Susan Clare | Secretario | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | 172445620001 | |||||||
| RUDD, Susan Clare | Secretario | 17 Thacker Drive WS13 6NS Lichfield Staffordshire | British | 81789210004 | ||||||
| STEVENS, Mark | Secretario | 5 Lyon Drive Murieston EH54 9HF Livingston West Lothian | British | 80951870001 | ||||||
| STEWART, Claire Susan | Secretario | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | 181021780001 | |||||||
| STEWART, Claire Susan | Secretario | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | Other | 130369890001 | ||||||
| WALMSLEY, Derek Kerr | Secretario | High Street Pavenham MK43 7NJ Bedford Walnut Barn Bedfordshire | British | 135181230001 | ||||||
| BASHFORTH, Edward Michael | Director | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 131551840002 | |||||
| BELL, Lucy Jane | Director | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 164754670001 | |||||
| BUBB, Stewart Edmund Conyers | Director | Clare Cottage 42 Lammas Lane KT10 8PD Esher Surrey | British | 36779040001 | ||||||
| CUMMING, Johanna Louise | Director | 18 Prospect Quay 98 Point Pleasant SW18 1PR London | United Kingdom | British | 111108910001 | |||||
| DANDO, Stephen Peter | Director | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 152083750001 | |||||
| DUTTON, Philip | Director | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 141395280001 | |||||
| GALLAGHER, Patrick James | Director | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | England | British | 205366190001 | |||||
| GODWIN-BRATT, Robert James | Director | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 170184800001 | |||||
| HOMER, Neville Rex | Director | Caberfeidh 12 Forth Street EH39 4HY North Berwick East Lothian | British | 895960001 | ||||||
| HOMER, Neville Rex | Director | Caberfeidh 12 Forth Street EH39 4HY North Berwick East Lothian | British | 895960001 | ||||||
| JONES, Karen Elisabeth Dind | Director | Paddock House 9 Spencer Park Wandsworth SW18 2SX London | United Kingdom | British | 47793260007 | |||||
| KELLY, Daryl Antony | Director | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 86246470001 | |||||
| KNIGHT, Andrew Ronald | Director | 89 Main Street DE13 7ED Alrewas Staffordshire | British | 81555100002 | ||||||
| LANGFORD, Jonathan Robert | Director | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 135408140001 | |||||
| MARGERRISON, Russell John | Director | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | England | British | 170590800001 | |||||
| MCDONALD, Robert James | Director | 46 Wentworth Drive WS14 9HN Lichfield Staffordshire | British | 42019620001 | ||||||
| MILLER, Louise | Director | 13 Traquair Park West EH12 7AN Edinburgh Midlothian | British | 63895470001 | ||||||
| MYDDELTON, Roger Hugh | Director | 21 Lawford Road NW5 2LH London | British | 399500001 | ||||||
| PEAREY, Michael John | Director | The Lodge EH32 0RE Aberlady East Lothian | British | 46305030001 | ||||||
| PEAREY, Michael John | Director | The Lodge EH32 0RE Aberlady East Lothian | British | 46305030001 | ||||||
| PRESTON, Neil David | Director | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 63043630002 |
¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para SPIRIT GROUP RETAIL HOTELS LIMITED?
| Notificado el | Cesado el | Declaración |
|---|---|---|
| 02 mar 2017 | La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa. |
¿Tiene SPIRIT GROUP RETAIL HOTELS LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Security agreement | Creado el 15 dic 2003 Entregado el 31 dic 2003 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Floating charge | Creado el 05 ene 1989 Entregado el 12 ene 1989 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Twelfth supplemental trust deed | Creado el 30 sept 1985 Entregado el 07 oct 1985 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada Sterling pounds 1,288,988 debenture stock of watney mann & truman holdings PLC comprising of sterling pounds 349,595 5% redeemable debenture stock 2000, sterling pounds 243,200 6 1/2% redeemable debenture stock 1988/93 & sterling pounds 696,193 7 3/4% redeemable debenture stock 1988/93 & all moneys intended to be secured by a trust deed dated 7/2/62 & deeds supplemental thereto. | |
Breve descripción First floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Trust deed | Creado el 24 may 1983 Entregado el 25 may 1983 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada For securing sterling pounds 50,000,000 12 1/8% redeemable debenture stock 2008 of watney mann & truman holdings PLC & for further securing all monies due or to become due from watney mann & truman holdings PLC to the chargee under the terms of the trust deed dated 7/2/62 and supplemental thereto | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Trust deed | Creado el 28 jul 1970 Entregado el 12 ago 1970 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada Securing debenture stock of watney mann LTD amounting to sterling pounds 53,127,463 inclusive of sterling pounds 45,627,463 secured by a trust deed dated 7.2.62 & deeds supplemental | |
Breve descripción First floating charge on. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Trust deed | Creado el 31 jul 1967 Entregado el 31 jul 1967 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada Securing debenture stock of watney mann LTD amounting to sterling pounds 45,627,463 inclusive of sterling pounds 35,627,463 secured by trust deed dated 7/2/62 and deeds suppl. Thereto | |
Breve descripción First floating charge on. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Equitable charge without instrument | Creado el 08 may 1967 Entregado el 26 may 1967 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada For securing debenture stock of watney mann LTD amounting to sterling pounds 10,000,000 | |
Breve descripción First floating charge on. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Trust deed | Creado el 26 jul 1965 Entregado el 28 jul 1965 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada For securing debenture stock of watney mann LTD. Amounting to sterling pounds 7,500,000 | |
Breve descripción Floating charge on the (see doc. 82). undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Trust deed | Creado el 26 mar 1965 Entregado el 06 abr 1965 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada 1,347,268 debenture stock of watney mann LTD. | |
Breve descripción Floating charge:. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Trust deed | Creado el 22 ene 1964 Entregado el 23 jun 1964 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada For securing debenture stock of watney mann LTD. Amounting to sterling pounds 8,000,000 | |
Breve descripción Undertaking and all assets present and future including uncalled capital. (See doc 77). | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Trust deed | Creado el 08 feb 1962 Entregado el 08 feb 1962 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada For further securing sterling pounds 5,000,000 debenture stock of watney mann limited, (see doc 73 for further details) | |
Breve descripción Undertaking and all assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Trust deed. | Creado el 07 feb 1962 Entregado el 07 feb 1962 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada For further securing sterling pounds 13,780,195 debenture stock of watney mann LTD. (For further details see doc 72) | |
Breve descripción Undertaking and all assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene SPIRIT GROUP RETAIL HOTELS LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0