JOURDAN PLC

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaJOURDAN PLC
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad anónima cotizada
    Número de empresa 00215690
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de JOURDAN PLC?

    • Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra JOURDAN PLC?

    Dirección de la sede social
    C/O Cfs Restructuring Llp
    22 Regent Street
    NG1 5BQ Nottingham
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de JOURDAN PLC?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    THOMAS JOURDAN PUBLIC LIMITED COMPANY16 ago 192616 ago 1926

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de JOURDAN PLC?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2019

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para JOURDAN PLC?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    11 páginasLIQ13

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 29 dic 2021

    15 páginasLIQ03

    Declaración de solvencia

    5 páginasLIQ01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    3 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 30 dic 2020

    LRESSP

    Domicilio social registrado cambiado de Elm House Elmer Street North Grantham Lincolnshire NG31 6RE a C/O Cfs Restructuring Llp 22 Regent Street Nottingham NG1 5BQ el 21 dic 2020

    1 páginasAD01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2019

    26 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 20 mar 2020 con actualizaciones

    13 páginasCS01

    Exercice comptable en cours prolongé du 30 jun 2019 au 31 dic 2019

    1 páginasAA01

    Declaración de confirmación presentada el 20 mar 2019 con actualizaciones

    13 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2018

    27 páginasAA

    Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada Neville House Steelpark Road Halesowen B62 8HD

    1 páginasAD03

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado de Elm House Elmer Street North Grantham NG31 6RE England a Neville House Steelpark Road Halesowen B62 8HD

    1 páginasAD02

    Cancelación total de la carga 11

    1 páginasMR04

    Declaración de confirmación presentada el 20 mar 2018 con actualizaciones

    16 páginasCS01

    Los registros se han trasladado a la dirección del domicilio social registrado Elm House Elmer Street North Grantham Lincolnshire NG31 6RE

    1 páginasAD04

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2017

    27 páginasAA

    Cancelación total de la carga 18

    1 páginasMR04

    Renuncia del auditor

    1 páginasAUD

    Declaración de confirmación presentada el 20 mar 2017 con actualizaciones

    26 páginasCS01

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado de Thames House Portsmouth Road Esher Surrey KT10 9AD United Kingdom a Elm House Elmer Street North Grantham NG31 6RE

    1 páginasAD02

    Cuentas consolidadas preparadas hasta el 30 jun 2016

    47 páginasAA

    Parte del bien o empresa ya no forma parte de la carga 11

    5 páginasMR05

    Déclaration annuelle établie au 20 mar 2016 avec liste complète des actionnaires

    28 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital06 abr 2016

    Estado de capital el 06 abr 2016

    • Capital: GBP 2,963,000
    SH01

    ¿Quiénes son los directivos de JOURDAN PLC?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BRUCE, Martha Blanche Waymark
    Clifton Terrace
    Cliftonville
    RH4 2JG Dorking
    7
    Surrey
    United Kingdom
    Secretario
    Clifton Terrace
    Cliftonville
    RH4 2JG Dorking
    7
    Surrey
    United Kingdom
    186015670001
    ABELL, John David
    Elm House
    Elmer Street North
    NG31 6RE Grantham
    Jourdan Plc
    Lincolnshire
    United Kingdom
    Director
    Elm House
    Elmer Street North
    NG31 6RE Grantham
    Jourdan Plc
    Lincolnshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish71975220001
    MORRIS, Robert Ridley
    22 Regent Street
    NG1 5BQ Nottingham
    C/O Cfs Restructuring Llp
    United Kingdom
    Director
    22 Regent Street
    NG1 5BQ Nottingham
    C/O Cfs Restructuring Llp
    United Kingdom
    United KingdomBritish1585190002
    PITHER, Jon Peter
    5a Selwyn Gardens
    CB3 9AX Cambridge
    Cambs
    Director
    5a Selwyn Gardens
    CB3 9AX Cambridge
    Cambs
    United KingdomBritish96134950002
    BALICAO, Marla
    Portsmouth Road
    KT10 9AD Esher
    Thames House
    Surrey
    United Kingdom
    Secretario
    Portsmouth Road
    KT10 9AD Esher
    Thames House
    Surrey
    United Kingdom
    170315500001
    BRUCE, Martha Blanche Waymark
    Portsmouth Road
    KT10 9AD Esher
    Thames House
    Surrey
    United Kingdom
    Secretario
    Portsmouth Road
    KT10 9AD Esher
    Thames House
    Surrey
    United Kingdom
    British71698110001
    COLLINS, Peter William
    The Oaks
    23 Croft Road
    RG40 3HX Wokingham
    Berkshire
    Secretario
    The Oaks
    23 Croft Road
    RG40 3HX Wokingham
    Berkshire
    British26086560001
    HIGH, Keith
    37 Old Garden Close
    Locks Heath
    SO31 6RN Southampton
    Hampshire
    Secretario
    37 Old Garden Close
    Locks Heath
    SO31 6RN Southampton
    Hampshire
    British14381990001
    STUART, Alexander Alfred
    Holley House
    Manor Lane
    SL9 7NJ Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Secretario
    Holley House
    Manor Lane
    SL9 7NJ Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British12486040001
    ARNOLD, Michael John
    Brockhill
    Naunton
    GL54 3AF Cheltenham
    Gloucestershire
    Director
    Brockhill
    Naunton
    GL54 3AF Cheltenham
    Gloucestershire
    British48184650002
    COLLINS, Peter William
    The Oaks
    23 Croft Road
    RG40 3HX Wokingham
    Berkshire
    Director
    The Oaks
    23 Croft Road
    RG40 3HX Wokingham
    Berkshire
    United KingdomBritish26086560001
    ELLIOTT, Paul Stuart
    3 Mowbray Drive
    Hurworth
    DL2 2EZ Darlington
    County Durham
    Director
    3 Mowbray Drive
    Hurworth
    DL2 2EZ Darlington
    County Durham
    British43049640001
    HARTLEY, Paul
    8 Claremont Gardens
    Hallatrow
    BS39 6EY Bristol
    Director
    8 Claremont Gardens
    Hallatrow
    BS39 6EY Bristol
    United KingdomUnited Kingdom34924580003
    LAMB, Adrian Frank
    Lynbury House Burtons Way
    HP8 4BP Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Director
    Lynbury House Burtons Way
    HP8 4BP Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    British42084600001
    LINDQVIST, Karl Anders
    6 Pegasus Mews
    SG18 8QA Biggleswade
    Director
    6 Pegasus Mews
    SG18 8QA Biggleswade
    Finnish86518600002
    MACPHERSON, Michael Alastair Fox
    58 Luttrell Avenue
    Putney
    SW15 6PE London
    Director
    58 Luttrell Avenue
    Putney
    SW15 6PE London
    British11697290001
    PARKS, Brian Richard
    31 Earlswood Road
    Dorridge
    B93 8RD Solihull
    West Midlands
    Director
    31 Earlswood Road
    Dorridge
    B93 8RD Solihull
    West Midlands
    British1576160001
    STUART, Alexander Alfred
    Holley House
    Manor Lane
    SL9 7NJ Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Director
    Holley House
    Manor Lane
    SL9 7NJ Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British12486040001
    VINTON, Anna Marie
    37 Thurloe Square
    SW7 2SR London
    Director
    37 Thurloe Square
    SW7 2SR London
    British7782310004
    WHITTEN, Keith
    80 Gloucester Terrace
    Bayswater
    W2 3HH London
    Director
    80 Gloucester Terrace
    Bayswater
    W2 3HH London
    SwitzerlandBritish,Irish9760530001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de JOURDAN PLC?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Mr John David Abell
    Elmer Street North
    NG31 6RE Grantham
    Elm House
    Lincolnshire
    United Kingdom
    06 abr 2016
    Elmer Street North
    NG31 6RE Grantham
    Elm House
    Lincolnshire
    United Kingdom
    No
    Nacionalidad: British
    País de residencia: United Kingdom
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 50% pero no más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 50% pero no más del 75% de los derechos de voto en la empresa.

    ¿Tiene JOURDAN PLC alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 9 june 1998 and
    Creado el 08 sept 2006
    Entregado el 14 sept 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sums or sums standing to the credit if any one or more of any present of future accounts of the company with the bank.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 14 sept 2006Registro de un cargo (395)
    • 19 oct 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    Mortgage deed
    Creado el 30 sept 2003
    Entregado el 20 oct 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The freehold property being units 23 and 25 second avenue westfield industrial estate midsomer norton bath t/n AVL62352. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 20 oct 2003Registro de un cargo (395)
    • 11 sept 2015Todo el bien o empresa ha sido liberado de la carga (MR05)
    • 03 dic 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Mortgage of stocks and shares
    Creado el 24 may 2000
    Entregado el 06 jun 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All the rights and interests in such securities and all allotments, offers, dividends, and other distributions, interests, rights, benenfits, and advantages arising at any time in relation to any such securities. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 06 jun 2000Registro de un cargo (395)
    • 16 dic 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Mortgage deed
    Creado el 25 may 1999
    Entregado el 01 jun 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/Hold property known as plot 17,walworth industrial estate,andover; HP553495. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 01 jun 1999Registro de un cargo (395)
    • 05 ago 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Mortgage deed
    Creado el 25 may 1999
    Entregado el 01 jun 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/Hold property - unit 2,92 lots rd,chelsea; NGL556885. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 01 jun 1999Registro de un cargo (395)
    • 01 feb 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage deed
    Creado el 25 may 1999
    Entregado el 01 jun 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/Hold property being 1,2 and 3 hunter rd,south west industrial estate,peterlee; DU143617. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 01 jun 1999Registro de un cargo (395)
    • 03 dic 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Mortgage deed
    Creado el 25 may 1999
    Entregado el 01 jun 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/Hold property - land/blds on south east side of mount rd,kidsgrove; SF1453. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 01 jun 1999Registro de un cargo (395)
    • 05 ago 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 09 jun 1998
    Entregado el 11 jun 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 11 jun 1998Registro de un cargo (395)
    • 05 sept 2002Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 09 abr 2016Parte del bien o empresa ya no forma parte de la carga (MR05)
    • 04 sept 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    Letter of offset
    Creado el 20 mar 1992
    Entregado el 31 mar 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee.
    Breve descripción
    The balances at credit of any accounts held by the governor and company of the bank of scotland in the name of thomas jourdan public limited company.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 31 mar 1992Registro de un cargo (395)
    • 01 oct 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 11 jul 1986
    Entregado el 14 jul 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    F/H property being land and buildings on the south east side of mount road, kidsgrove, staffordshire. T.N. sf 1453.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland.
    Transacciones
    • 14 jul 1986Registro de una carga
    • 21 ene 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 08 ene 1986
    Entregado el 08 ene 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    F/H land and buildings on the south side of blackhorse yard, park street, windsor T.N. bk 133456.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland.
    Transacciones
    • 08 ene 1986Registro de una carga
    • 21 ene 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 24 feb 1984
    Entregado el 09 mar 1984
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    3,5 and 7 ives street and land to the rear of 2 to 5 donne place. Chelsea. T.nos-64996 ln 97822.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland.
    Transacciones
    • 09 mar 1984Registro de una carga
    • 21 ene 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 24 feb 1984
    Entregado el 09 mar 1984
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H- land at debdale lane, mansfield woodhouse, nottinghamshire.
    Personas con derecho
    • Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 09 mar 1984Registro de una carga
    • 21 ene 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 24 feb 1984
    Entregado el 09 mar 1984
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Legal mortgage - 30/32 frances road, windsor, and showroom and office premises at 3 ives street, london, and land at the rear of 2-5 donne place, london SW3 including buildings, fixtures, plant etc. fixed & floating charge - undertaking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebts. Uncalled capital.
    Personas con derecho
    • Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 09 mar 1984Registro de una carga
    • 21 ene 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 24 feb 1984
    Entregado el 09 mar 1984
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H-railway view, malpas road, northallerton, yorks,.
    Personas con derecho
    • The Governor & Company of Bank of Scotland.
    Transacciones
    • 09 mar 1984Registro de una carga
    • 21 ene 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 24 feb 1984
    Entregado el 09 mar 1984
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H-26,28,30 & 32 frances road, windsor berks, T.n-BK27390.
    Personas con derecho
    • The Governor & Company of the Bank of Scotland.
    Transacciones
    • 09 mar 1984Registro de una carga
    • 21 ene 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 04 oct 1982
    Entregado el 15 oct 1982
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H wombourne trading estate, land near main road from bridgnorth to himley, wombourne, staffs.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 15 oct 1982Registro de una carga
    Legal charge
    Creado el 15 sept 1980
    Entregado el 16 sept 1980
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H land near main road, bridgnorth to himley, wombourn staffordshire.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 16 sept 1980Registro de una carga

    ¿Tiene JOURDAN PLC algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    01 may 2023Fecha prevista de disolución
    30 dic 2020Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Andrew J Cordon
    Church House, 22 Regent Street
    NG1 5BQ Nottingham
    Nottinghamshire
    Profesional
    Church House, 22 Regent Street
    NG1 5BQ Nottingham
    Nottinghamshire
    James Oliver Everist
    Church House, 22 Regent Street
    NG1 5BQ Nottingham
    Profesional
    Church House, 22 Regent Street
    NG1 5BQ Nottingham

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0