LAVA CAPITAL UK LIMITED

LAVA CAPITAL UK LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaLAVA CAPITAL UK LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00224601
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de LAVA CAPITAL UK LIMITED?

    • Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción

    ¿Dónde se encuentra LAVA CAPITAL UK LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Chancery House
    30 St Johns Road
    GU21 7SA Woking
    Surrey
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de LAVA CAPITAL UK LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    SHELLEY OAK LIMITED15 dic 200815 dic 2008
    SHELLEY OAK PLC20 mar 200620 mar 2006
    QUINCUNX PLC11 ene 199511 ene 1995
    SR RESTAURANT PLC10 ago 199410 ago 1994
    SCOTT'S RESTAURANT, PUBLIC LIMITED COMPANY22 sept 192722 sept 1927

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de LAVA CAPITAL UK LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 jun 2020

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para LAVA CAPITAL UK LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    2 páginasDS01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 jun 2020

    14 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 30 jun 2020 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 jun 2019

    14 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 30 jun 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 jun 2018

    14 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 30 jun 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 jun 2017

    15 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 30 jun 2017 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 jun 2016

    14 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 30 jun 2016 con actualizaciones

    6 páginasCS01

    Cancelación total de la carga 10

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 13

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 12

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 11

    4 páginasMR04

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 jun 2015

    14 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 30 jun 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital12 ago 2015

    Estado de capital el 12 ago 2015

    • Capital: GBP 300,000
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2014

    19 páginasAA

    Cese del nombramiento de Philip James Curwen como secretario el 29 jun 2013

    1 páginasTM02

    Déclaration annuelle établie au 30 jun 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital09 oct 2014

    Estado de capital el 09 oct 2014

    • Capital: GBP 300,000
    SH01

    Exercice comptable précédent prolongé du 31 dic 2013 au 30 jun 2014

    1 páginasAA01

    Cese del nombramiento de Snaebjorn Sigurdsson como director el 26 jun 2014

    1 páginasTM01

    Nombramiento de So Director Limited como director el 26 jun 2014

    2 páginasAP02

    ¿Quiénes son los directivos de LAVA CAPITAL UK LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    PERRY, Alan
    30 St Johns Road
    GU21 7SA Woking
    Chancery House
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    30 St Johns Road
    GU21 7SA Woking
    Chancery House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritish125162690001
    SO DIRECTOR LIMITED
    30 St Johns Road
    GU21 7SA Woking
    Chancery House
    Surrey
    United Kingdom
    Director corporativo
    30 St Johns Road
    GU21 7SA Woking
    Chancery House
    Surrey
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registro06045490
    190248950001
    BLAND, Geoffrey Charles
    1 Hollowmead
    Claverham
    BS49 4LF Bristol
    Secretario
    1 Hollowmead
    Claverham
    BS49 4LF Bristol
    British1763600001
    CURWEN, Philip James
    High Street
    Knaphill
    GU21 2PG Woking
    1
    Surrey
    United Kingdom
    Secretario
    High Street
    Knaphill
    GU21 2PG Woking
    1
    Surrey
    United Kingdom
    155749400001
    CURWEN, Philip James
    High Street
    Knaphill
    GU21 2PG Woking
    1
    Surrey
    United Kingdom
    Secretario
    High Street
    Knaphill
    GU21 2PG Woking
    1
    Surrey
    United Kingdom
    British161979510001
    FOKES, Brian Ronald
    34 Rowan Way
    Rottingdean
    BN2 7FP Brighton
    East Sussex
    Secretario
    34 Rowan Way
    Rottingdean
    BN2 7FP Brighton
    East Sussex
    British14013980001
    PRICHARD-JONES, Kenneth Victor
    1 Field Place
    Broadbridge Heath
    RH12 3PB Horsham
    West Sussex
    Secretario
    1 Field Place
    Broadbridge Heath
    RH12 3PB Horsham
    West Sussex
    British37769570002
    NETWORK SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Field Place
    Broadbridge Heath
    RH12 3PB Horsham
    West Sussex
    Secretario corporativo
    Field Place
    Broadbridge Heath
    RH12 3PB Horsham
    West Sussex
    50353670001
    BENNISON, Peter James
    5 Ashley Close
    NW4 1PH London
    Director
    5 Ashley Close
    NW4 1PH London
    EnglandBritish88640070003
    BLAND, Geoffrey Charles
    1 Hollowmead
    Claverham
    BS49 4LF Bristol
    Director
    1 Hollowmead
    Claverham
    BS49 4LF Bristol
    EnglandBritish1763600001
    HELGASON, Arni
    19
    Reykjavik
    Kambasel
    109
    Iceland
    Director
    19
    Reykjavik
    Kambasel
    109
    Iceland
    IcelandIcelander137732190002
    KERMAN, Anthony David
    5 Saint Jamess Square
    SW1Y 4JU London
    Director
    5 Saint Jamess Square
    SW1Y 4JU London
    United KingdomBritish72531870002
    KERMAN, Isidore
    11 Mansfield Street
    W1M 0AH London
    Director
    11 Mansfield Street
    W1M 0AH London
    British35542530001
    KERMAN, Nicholas
    25 Eaton Mews South
    SW1W 9HR London
    Director
    25 Eaton Mews South
    SW1W 9HR London
    EnglandBritish55578530001
    LORENZ, Robert Jacques
    97 St Johns Wood Terrace
    NW8 6PP London
    Director
    97 St Johns Wood Terrace
    NW8 6PP London
    British3397220001
    OSBORNE, Clarke Anthony
    1 Malthouse Barn
    Barn Lane Chelwood
    BS18 4NN Bristol
    Director
    1 Malthouse Barn
    Barn Lane Chelwood
    BS18 4NN Bristol
    British48713080003
    PRICHARD JONES, Kenneth Victor
    Field Place
    Broadbridge Heath
    RH12 3PB Horsham
    West Sussex
    Director
    Field Place
    Broadbridge Heath
    RH12 3PB Horsham
    West Sussex
    United KingdomBritish118944980001
    PRICHARD JONES, Sebastian James
    Flat 4
    26/27 Great Tower Street
    EC3R 5AQ London
    Director
    Flat 4
    26/27 Great Tower Street
    EC3R 5AQ London
    EnglandBritish69343350002
    PRICHARD-JONES, Dagmar Eve
    Field Place
    Broadbridge Heath
    RH12 3PB Horsham
    West Sussex
    Director
    Field Place
    Broadbridge Heath
    RH12 3PB Horsham
    West Sussex
    British6556330001
    PRICHARD-JONES, Kenneth Victor
    1 Field Place
    Broadbridge Heath
    RH12 3PB Horsham
    West Sussex
    Director
    1 Field Place
    Broadbridge Heath
    RH12 3PB Horsham
    West Sussex
    British37769570002
    SCHINDLER, Darren
    86 Stag Leys
    KT21 2TL Ashtead
    Surrey
    Director
    86 Stag Leys
    KT21 2TL Ashtead
    Surrey
    British118944850001
    SIGURDSSON, Snaebjorn
    Kirkjusandi 2
    155 Reyjavik
    Islandsbanki Hf
    Iceland
    Director
    Kirkjusandi 2
    155 Reyjavik
    Islandsbanki Hf
    Iceland
    IcelandIcelandic168776090001
    COLERIDGE PARTNERS LLP
    Field Place
    Broadbridge Heath
    RH12 3PB Horsham
    West Sussex
    Director corporativo
    Field Place
    Broadbridge Heath
    RH12 3PB Horsham
    West Sussex
    120033030001
    CONSOLIDATED HOLDINGS PLC
    PO BOX 134 4th North Suite
    Town Mills Trinity Square
    GY1 3HN St Peter Port Guernsey
    Channel Islands
    Director corporativo
    PO BOX 134 4th North Suite
    Town Mills Trinity Square
    GY1 3HN St Peter Port Guernsey
    Channel Islands
    109847110001
    DRAGON DIRECTORS LIMITED
    Field Place
    Broadbridge Heath
    RH12 3PB Horsham
    West Sussex
    Director corporativo
    Field Place
    Broadbridge Heath
    RH12 3PB Horsham
    West Sussex
    85218910001
    ENTERPRISE CORPORATION
    P O Box 556 Charlestown
    Nevis
    West Indies
    Director corporativo
    P O Box 556 Charlestown
    Nevis
    West Indies
    52245280001
    MANAGEMENT CORPORATION
    P O Box 556
    Charlestown
    Nevis
    West Indies
    Director corporativo
    P O Box 556
    Charlestown
    Nevis
    West Indies
    51797180001
    STJORNARMENN ENF
    Skofarhlid 12
    FOREIGN Reykjavik
    105
    Iceland
    Director corporativo
    Skofarhlid 12
    FOREIGN Reykjavik
    105
    Iceland
    126702600001
    STJORNARZ EHF
    Borgartun 18,
    FOREIGN Reykjavik
    105
    Iceland
    Director corporativo
    Borgartun 18,
    FOREIGN Reykjavik
    105
    Iceland
    120033190001
    STJORNARZ EHF
    Borgartun 18,
    Reykjavik
    105
    Iceland
    Director corporativo
    Borgartun 18,
    Reykjavik
    105
    Iceland
    120033190001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de LAVA CAPITAL UK LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Mr Jason Scott Haigh
    CM23 4FS Bishops Stortford
    19 Ploughmans Close
    Hertfordshire
    England
    06 abr 2016
    CM23 4FS Bishops Stortford
    19 Ploughmans Close
    Hertfordshire
    England
    No
    Nacionalidad: British
    País de residencia: England
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de los derechos de voto en la empresa.
    Mr Christopher James Duncan Mcdougall
    30 St Johns Road
    GU21 7SA Woking
    Chancery House
    Surrey
    United Kingdom
    06 abr 2016
    30 St Johns Road
    GU21 7SA Woking
    Chancery House
    Surrey
    United Kingdom
    No
    Nacionalidad: Australian
    País de residencia: Australia
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de los derechos de voto en la empresa.

    ¿Tiene LAVA CAPITAL UK LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Deed of priorities containing a charging clause
    Creado el 03 jul 2009
    Entregado el 21 jul 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the borrowers to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Any money or assets which the company receives in contravention of the deed which has not been agreed by the senior creditor see image for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 21 jul 2009Registro de un cargo (395)
    • 13 may 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Deed of priorities
    Creado el 31 mar 2008
    Entregado el 09 abr 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from consero homes dartnell ave limited to the chargee and the senior creditor not exceeding £4,205,000 under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Any money or assets which the company receives in contravention of the deed, which has not been agreed by the senior creditor see image for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 09 abr 2008Registro de un cargo (395)
    • 13 may 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Deed of priorities
    Creado el 24 oct 2007
    Entregado el 01 nov 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from consero more lane limited (the borrower) to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Any money or assets which the company receives. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 01 nov 2007Registro de un cargo (395)
    • 13 may 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture and charge
    Creado el 12 mar 2007
    Entregado el 29 mar 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All assets and undertaking of the company including uncalled capital and including all monies due under and all security for loans made by the company from time to time.
    Personas con derecho
    • Sparisjodur Velstjora
    Transacciones
    • 29 mar 2007Registro de un cargo (395)
    • 13 may 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal charge
    Creado el 18 ago 1992
    Entregado el 21 ago 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    By way of legal mortgage bristol lawn tennis & squash centre, redland green, redland, bristol by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights affecting or concerning the property the plant machinery and fixtures and fittings, furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business of a licenced publican etc the benefit of all licences (see form 395 for full details).
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 21 ago 1992Registro de un cargo (395)
    • 06 sept 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 31 mar 1992
    Entregado el 04 abr 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 04 abr 1992Registro de un cargo (395)
    • 28 jun 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge of licensed premises
    Creado el 31 mar 1992
    Entregado el 04 abr 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H land and buildings k/a 1 pont street l/b of kensington and chelsea, greater london title no. 334759 fixed charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment the goodwill of the business the benefit of all justices, excise or other licences (see form 395 for full details).
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 04 abr 1992Registro de un cargo (395)
    • 06 sept 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 18 oct 1991
    Entregado el 07 nov 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H land and buildings k/a 4-7 (inclusive) victoria buildings, terminus place, l/b of city of westminster, greater london, title no. 353505 fixed charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture andequipment.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 07 nov 1991Registro de un cargo (395)
    • 06 sept 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 02 mar 1987
    Entregado el 12 mar 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Mirabelle restaurant 56 curzon street westminster fixed charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 12 mar 1987Registro de una carga
    • 25 ene 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 02 mar 1987
    Entregado el 12 mar 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Flat 9, 56 curzon street westminster fixed charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipement.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 12 mar 1987Registro de una carga
    • 25 may 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 27 feb 1987
    Entregado el 02 mar 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £1,200,000 and all other moneys due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    F/H premises at pickering place vaults (title no 106860) l/h premises at 5 st.jame's street (title no ln U04252) l/h premises at 4/7 victoria buildings (title no ln 65915). (see form 395 for full details).
    Personas con derecho
    • Mr L Muller
    Transacciones
    • 02 mar 1987Registro de una carga
    • 28 nov 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 26 ene 1984
    Entregado el 27 ene 1984
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H 81 & 83 buckingham alace road and 164 victoria street, london SW1 title no. 249201.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 27 ene 1984Registro de una carga
    • 05 dic 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage
    Creado el 10 ene 1966
    Entregado el 12 ene 1966
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £150,000
    Breve descripción
    1 & 2 great windmill street 18, 19, 20 coventry street W1.
    Personas con derecho
    • Legal & General Assurance Society LTD
    Transacciones
    • 12 ene 1966Registro de una carga
    • 25 may 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0