SELECTED LAND AND PROPERTY COMPANY,
Visión general
Nombre de la empresa | SELECTED LAND AND PROPERTY COMPANY, |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad privada sin límite de capital |
Número de empresa | 00228839 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de SELECTED LAND AND PROPERTY COMPANY,?
- Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción
¿Dónde se encuentra SELECTED LAND AND PROPERTY COMPANY,?
Dirección de la sede social | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SELECTED LAND AND PROPERTY COMPANY,?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
SELECTED LAND AND PROPERTY COMPANY,LIMITED | 15 mar 1928 | 15 mar 1928 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de SELECTED LAND AND PROPERTY COMPANY,?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2018 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para SELECTED LAND AND PROPERTY COMPANY,?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||
Cese del nombramiento de David Clifford Wheeler como director el 14 jun 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||
Nombramiento de Mr Bruce Richardson como director el 14 jun 2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 4 páginas | DS01 | ||||||
legacy | 5 páginas | RP04CS01 | ||||||
Cancelación total de la carga 1 | 4 páginas | MR04 | ||||||
Cancelación total de la carga 3 | 4 páginas | MR04 | ||||||
Cancelación total de la carga 7 | 4 páginas | MR04 | ||||||
Cancelación total de la carga 2 | 4 páginas | MR04 | ||||||
Cancelación total de la carga 9 | 4 páginas | MR04 | ||||||
Cancelación total de la carga 4 | 4 páginas | MR04 | ||||||
Cancelación total de la carga 6 | 4 páginas | MR04 | ||||||
Cancelación total de la carga 8 | 4 páginas | MR04 | ||||||
Cancelación total de la carga 5 | 4 páginas | MR04 | ||||||
Cancelación total de la carga 12 | 4 páginas | MR04 | ||||||
Cancelación total de la carga 10 | 4 páginas | MR04 | ||||||
Cancelación total de la carga 11 | 4 páginas | MR04 | ||||||
Cancelación total de la carga 13 | 4 páginas | MR04 | ||||||
Cancelación total de la carga 14 | 4 páginas | MR04 | ||||||
Cancelación total de la carga 15 | 4 páginas | MR04 | ||||||
Cese del nombramiento de Sarah Nelson como director el 14 ene 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||
Nombramiento de Mr David Clifford Wheeler como director el 14 ene 2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||
legacy | 5 páginas | CS01 | ||||||
| ||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2018 | 3 páginas | AA | ||||||
¿Quiénes son los directivos de SELECTED LAND AND PROPERTY COMPANY,?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED | Secretario corporativo | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom |
| 187856670001 | ||||||||||
BURKE, Martyn Stephen | Director | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 152531940004 | ||||||||
CLEGG, Dean | Director | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | England | British | Company Director | 189632520001 | ||||||||
COWEN, Geraint Jamie | Director | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | England | British | Company Director | 141040000003 | ||||||||
HONEYMAN, James Andrew | Director | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | Chartered Surveyor | 201179510001 | ||||||||
PINKSTONE, James Michael | Director | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | England | British | Corporate Finance Executive | 241498640001 | ||||||||
RICHARDSON, Bruce | Director | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | England | British,South African | Group Financial Controller | 260008150001 | ||||||||
SHAH, Hursh | Director | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | Company Director | 162123940002 | ||||||||
WATSON, James | Director | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | United Kingdom | British | Investment Surveyor | 248560570001 | ||||||||
CLARKE, Peter Courtenay | Secretario | Langkawi 2 Ashlea Road SL9 8NY Chalfont St Peter Buckinghamshire | British | 78691990001 | ||||||||||
EKPO, Ndiana | Secretario | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | Other | 138446320001 | ||||||||||
SCUDAMORE, Rebecca Jane | Secretario | 40 Canbury Avenue KT2 6JP Kingston Upon Thames Surrey | Other | 72249480003 | ||||||||||
ATKINSON, William Stephen | Director | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | Investment Surveyor | 174566650001 | ||||||||
BAGULEY, Peter Jeffrey | Director | Westridge Farm Daggerridge Plain Cadeleigh EX16 8HU Tiverton Devon | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 175617500001 | ||||||||
BARZYCKI, Sarah Morrell | Director | Sandown Road KT10 9TT Esher 27 Surrey | United Kingdom | British | Head Of Finance | 58016770004 | ||||||||
BELL, Lucinda Margaret | Director | 6 Priory Gardens Chiswick W4 1TT London | England | British | Chartered Accountant | 32809050004 | ||||||||
BELL-BROWN, Philip | Director | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | England | British | Company Director | 119073370001 | ||||||||
BERRY, David Charles | Director | Portland Dene Valley Way SL9 7PN Gerrards Cross Buckinghamshire | British | Chartered Accountant | 166550001 | |||||||||
BIRCH, John Matthew | Director | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 191027500001 | ||||||||
BOWDEN, Robert Edward | Director | The Chase Ongar Road CM15 0DG Kelvedon Hatch Essex | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 152497530001 | ||||||||
BRAINE, Anthony | Director | 21 Woodville Road Ealing W5 2SE London | United Kingdom | British | Chartered Secretary | 32809000002 | ||||||||
CARTER, Simon Geoffrey | Director | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | Treasury Executive | 170891060001 | ||||||||
CLARKE, Peter Courtenay | Director | Oakmeade Park Road SL2 4PG Stoke Poges Berkshire | United Kingdom | British | Chartered Secretary | 78691990003 | ||||||||
COHEN, Carolina Alfred | Director | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | United Kingdom | British | Investment Executive | 248093020001 | ||||||||
FLEMING, Richard Alexander | Director | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 125990210002 | ||||||||
FORSHAW, Christopher Michael John | Director | 44 Kerris Way Lower Earley RG6 5UW Reading Berkshire | England | British | Company Director | 1898090001 | ||||||||
FRANCIS, Luke Thomas | Director | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | Accountant | 223122340001 | ||||||||
GROSE, Benjamin Toby | Director | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 146546000001 | ||||||||
GUNSTON, Michael Ian | Director | Larchmont Hambledon Road, Denmead PO7 6HB Waterlooville Hampshire | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 3079890002 | ||||||||
HESTER, Stephen Alan Michael | Director | 3 Ilchester Place W14 8AA London | British | Chief Executive | 51688320001 | |||||||||
HOORN, Antony John Van Der | Director | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | United Kingdom | British | Finance Director | 170891040001 | ||||||||
JONES, Andrew Marc | Director | Hazlewell Road Putney SW15 6LH London 2 | England | British | Company Director | 82020730004 | ||||||||
JONES, Andrew Marc | Director | Hazlewell Road Putney SW15 6LH London 2 | England | British | Company Director | 82020730004 | ||||||||
KALMAN, Stephen Lionel | Director | 81 Eastbury Road HA6 3AP Northwood Middlesex | England | British | Chartered Surveyor | 1188110001 | ||||||||
LEARMONT, Richard John | Director | Holborn EC1N 2HT London 33 United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 116126860008 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de SELECTED LAND AND PROPERTY COMPANY,?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pencilscreen Limited | 31 dic 2016 | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene SELECTED LAND AND PROPERTY COMPANY, alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Supplemental legal charge | Creado el 08 jul 1987 Entregado el 16 jul 1987 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada For further securing all monies due or to become due from city will properties limited to the chargee supplemental to the dated 18-4-63 | |
Breve descripción Land & buildings at arundel street buckingham street & clarendon place portsmouth title no hp 28647 tog with all usual landlords fixtures & fittings. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Deed of charge | Creado el 04 jul 1978 Entregado el 17 jul 1978 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada Sterling pounds 1033455 and all other monies due or to become due from the british land company limited to the chargee supplemental to a deed of variation and covenant dated 8TH june 73 | |
Breve descripción L/H land knwon as 211/213 regent street london. Title no ngl 10465. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Further charge | Creado el 04 jul 1978 Entregado el 17 jul 1978 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada Sterling pounds 1000000 and all other monies due or to become due from the british land company limited to the chargee under the terms of this charge supplemented to a charge dated 4TH july 1978 | |
Breve descripción L/H land known as 211/213 regent street london title no. Ngl 10465. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Agreement | Creado el 02 sept 1975 Entregado el 05 sept 1975 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada For securing all monies due or to become due from the british land company limited to the chargee under the terms of an agreement contained in a letter dated 30/3/73 and a further agreement dated 13/11/73 | |
Breve descripción 211/213, regent street london W1. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal charge | Creado el 02 sept 1975 Entregado el 05 sept 1975 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada For securing all monies due or to become due from the british land company limited to the chargee under the terms of an agreement contained in a letter dated 30/08/73 and a further agreement dated 13/11/73. | |
Breve descripción 211/213, regent street london W1. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal charge | Creado el 23 jun 1975 Entregado el 25 jun 1975 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada For securing all monies due or to become due from the british land company limited to the chargee under or guarantee dated 23/6/75. | |
Breve descripción 211/213, regent street london W1. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Further charge | Creado el 28 sept 1973 Entregado el 09 oct 1973 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada For securing sterling pounds 990788 due from the company and all or any of the six. Other companies named therein | |
Breve descripción Granville arcade london borough of lambeth being the property comprised in a charge dates 6/4/73. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal charge | Creado el 17 abr 1973 Entregado el 19 abr 1973 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada For securing sterling pounds 1400000 duefrom the company and/or all or any of the six other companies named therein | |
Breve descripción Granville arcade, lambeth, london. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Deed | Creado el 06 abr 1973 Entregado el 19 abr 1973 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada Deed effecting substitution of security for securing sterling pounds 2609212 outstanding under and secured by a charge dated U5-7-54 and deeds supplemental thereto. | |
Breve descripción Granville arcade, lambeth, london. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Deed of covenant and further charges | Creado el 31 mar 1966 Entregado el 06 abr 1966 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada Securing 235,000 inclusive of £129,432 outstanding and secured by three charges all dated 4/5/56 | |
Breve descripción All the land and premises charges by the b mortgage off 4-5(56. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Further charge | Creado el 12 feb 1965 Entregado el 16 feb 1965 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada Sterling pounds 11198 | |
Breve descripción 9, montpelier ave, ealing, middx. 3, crane way, 13,17,24 and 48, hall farm drive, and 73, warren rd, whitton, middx. Office, factory & premises off faggs rd, feltenham, middx. 330332, 332A and 334/344(even) kingston rd, merton, wimbledon, surrey. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal charge | Creado el 20 dic 1963 Adquirido el 22 mar 1968 Entregado el 10 abr 1968 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada Sterling pounds 10059 | |
Breve descripción 68/72 (even) college street, kempston beds. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Mortgage | Creado el 04 may 1956 Adquirido el 14 oct 1959 Entregado el 02 nov 1959 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada Sterling pounds 32000 owing | |
Breve descripción Part of granville arcade, brixton, london title no. Ln 38033. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Mortgage | Creado el 04 may 1956 Adquirido el 14 oct 1959 Entregado el 02 nov 1959 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada Sterling pounds 47432 owing | |
Breve descripción 7 station approach, hinchley wood, surrey title no. Sy 51471 port of granville arcade, coldharbour lane, brixton london,title no. Ln 38034. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Mortgage | Creado el 04 may 1956 Entregado el 08 may 1956 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada Sterling pounds 50000 | |
Breve descripción Property known as granville arcade, britain, london, railway arch 615 known as 37, atlantic rd, and land adjoining arches 20-25 (inc) near brixton stan. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Mortgage | Creado el 29 ene 1954 Entregado el 02 feb 1954 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada Sterling pounds 38712 | |
Breve descripción Various properties at:- ealing twickenham, and feltham, middlesex and at merton, and richmond surrey. (For details see doc 119). | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0