SELECTED LAND AND PROPERTY COMPANY,

SELECTED LAND AND PROPERTY COMPANY,

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSELECTED LAND AND PROPERTY COMPANY,
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad privada sin límite de capital
    Número de empresa 00228839
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de SELECTED LAND AND PROPERTY COMPANY,?

    • Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción

    ¿Dónde se encuentra SELECTED LAND AND PROPERTY COMPANY,?

    Dirección de la sede social
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SELECTED LAND AND PROPERTY COMPANY,?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    SELECTED LAND AND PROPERTY COMPANY,LIMITED15 mar 192815 mar 1928

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de SELECTED LAND AND PROPERTY COMPANY,?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2018

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para SELECTED LAND AND PROPERTY COMPANY,?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Cese del nombramiento de David Clifford Wheeler como director el 14 jun 2019

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Bruce Richardson como director el 14 jun 2019

    2 páginasAP01

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    4 páginasDS01

    legacy

    5 páginasRP04CS01

    Cancelación total de la carga 1

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 3

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 7

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 2

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 9

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 4

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 6

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 8

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 5

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 12

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 10

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 11

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 13

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 14

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 15

    4 páginasMR04

    Cese del nombramiento de Sarah Nelson como director el 14 ene 2019

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr David Clifford Wheeler como director el 14 ene 2019

    2 páginasAP01

    legacy

    5 páginasCS01
    Anotaciones
    FechaAnotación
    02 may 2019Clarification A second filed CS01 (Statement of capital change) was registered on 02/05/2019.

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2018

    3 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de SELECTED LAND AND PROPERTY COMPANY,?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro8992198
    187856670001
    BURKE, Martyn Stephen
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    Director
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director152531940004
    CLEGG, Dean
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    Director
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director189632520001
    COWEN, Geraint Jamie
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    Director
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director141040000003
    HONEYMAN, James Andrew
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Surveyor201179510001
    PINKSTONE, James Michael
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Director
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    EnglandBritishCorporate Finance Executive241498640001
    RICHARDSON, Bruce
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Director
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    EnglandBritish,South AfricanGroup Financial Controller260008150001
    SHAH, Hursh
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director162123940002
    WATSON, James
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Director
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    United KingdomBritishInvestment Surveyor248560570001
    CLARKE, Peter Courtenay
    Langkawi
    2 Ashlea Road
    SL9 8NY Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    Secretario
    Langkawi
    2 Ashlea Road
    SL9 8NY Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    British78691990001
    EKPO, Ndiana
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Secretario
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Other138446320001
    SCUDAMORE, Rebecca Jane
    40 Canbury Avenue
    KT2 6JP Kingston Upon Thames
    Surrey
    Secretario
    40 Canbury Avenue
    KT2 6JP Kingston Upon Thames
    Surrey
    Other72249480003
    ATKINSON, William Stephen
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishInvestment Surveyor174566650001
    BAGULEY, Peter Jeffrey
    Westridge Farm
    Daggerridge Plain Cadeleigh
    EX16 8HU Tiverton
    Devon
    Director
    Westridge Farm
    Daggerridge Plain Cadeleigh
    EX16 8HU Tiverton
    Devon
    United KingdomBritishChartered Surveyor175617500001
    BARZYCKI, Sarah Morrell
    Sandown Road
    KT10 9TT Esher
    27
    Surrey
    Director
    Sandown Road
    KT10 9TT Esher
    27
    Surrey
    United KingdomBritishHead Of Finance58016770004
    BELL, Lucinda Margaret
    6 Priory Gardens
    Chiswick
    W4 1TT London
    Director
    6 Priory Gardens
    Chiswick
    W4 1TT London
    EnglandBritishChartered Accountant32809050004
    BELL-BROWN, Philip
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    Director
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director119073370001
    BERRY, David Charles
    Portland Dene
    Valley Way
    SL9 7PN Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Director
    Portland Dene
    Valley Way
    SL9 7PN Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    BritishChartered Accountant166550001
    BIRCH, John Matthew
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    Director
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director191027500001
    BOWDEN, Robert Edward
    The Chase
    Ongar Road
    CM15 0DG Kelvedon Hatch
    Essex
    Director
    The Chase
    Ongar Road
    CM15 0DG Kelvedon Hatch
    Essex
    United KingdomBritishChartered Surveyor152497530001
    BRAINE, Anthony
    21 Woodville Road
    Ealing
    W5 2SE London
    Director
    21 Woodville Road
    Ealing
    W5 2SE London
    United KingdomBritishChartered Secretary32809000002
    CARTER, Simon Geoffrey
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishTreasury Executive170891060001
    CLARKE, Peter Courtenay
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    Director
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    United KingdomBritishChartered Secretary78691990003
    COHEN, Carolina Alfred
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Director
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    United KingdomBritishInvestment Executive248093020001
    FLEMING, Richard Alexander
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    Director
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant125990210002
    FORSHAW, Christopher Michael John
    44 Kerris Way
    Lower Earley
    RG6 5UW Reading
    Berkshire
    Director
    44 Kerris Way
    Lower Earley
    RG6 5UW Reading
    Berkshire
    EnglandBritishCompany Director1898090001
    FRANCIS, Luke Thomas
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritishAccountant223122340001
    GROSE, Benjamin Toby
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Surveyor146546000001
    GUNSTON, Michael Ian
    Larchmont
    Hambledon Road, Denmead
    PO7 6HB Waterlooville
    Hampshire
    Director
    Larchmont
    Hambledon Road, Denmead
    PO7 6HB Waterlooville
    Hampshire
    United KingdomBritishChartered Surveyor3079890002
    HESTER, Stephen Alan Michael
    3 Ilchester Place
    W14 8AA London
    Director
    3 Ilchester Place
    W14 8AA London
    BritishChief Executive51688320001
    HOORN, Antony John Van Der
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    Director
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinance Director170891040001
    JONES, Andrew Marc
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    Director
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    EnglandBritishCompany Director82020730004
    JONES, Andrew Marc
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    Director
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    EnglandBritishCompany Director82020730004
    KALMAN, Stephen Lionel
    81 Eastbury Road
    HA6 3AP Northwood
    Middlesex
    Director
    81 Eastbury Road
    HA6 3AP Northwood
    Middlesex
    EnglandBritishChartered Surveyor1188110001
    LEARMONT, Richard John
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    Director
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director116126860008

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de SELECTED LAND AND PROPERTY COMPANY,?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Pencilscreen Limited
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    31 dic 2016
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroEngland And Wales
    Número de registro06532033
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene SELECTED LAND AND PROPERTY COMPANY, alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Supplemental legal charge
    Creado el 08 jul 1987
    Entregado el 16 jul 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    For further securing all monies due or to become due from city will properties limited to the chargee supplemental to the dated 18-4-63
    Breve descripción
    Land & buildings at arundel street buckingham street & clarendon place portsmouth title no hp 28647 tog with all usual landlords fixtures & fittings.
    Personas con derecho
    • Scottish Widows Fund and Life Assurance Society
    Transacciones
    • 16 jul 1987Registro de una carga
    • 29 nov 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of charge
    Creado el 04 jul 1978
    Entregado el 17 jul 1978
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    Sterling pounds 1033455 and all other monies due or to become due from the british land company limited to the chargee supplemental to a deed of variation and covenant dated 8TH june 73
    Breve descripción
    L/H land knwon as 211/213 regent street london. Title no ngl 10465.
    Personas con derecho
    • Legal & General Assurance Society Limited
    Transacciones
    • 17 jul 1978Registro de una carga
    • 12 feb 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    Further charge
    Creado el 04 jul 1978
    Entregado el 17 jul 1978
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    Sterling pounds 1000000 and all other monies due or to become due from the british land company limited to the chargee under the terms of this charge supplemented to a charge dated 4TH july 1978
    Breve descripción
    L/H land known as 211/213 regent street london title no. Ngl 10465.
    Personas con derecho
    • Legal & General Assurance Society Limited
    Transacciones
    • 17 jul 1978Registro de una carga
    • 12 feb 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    Agreement
    Creado el 02 sept 1975
    Entregado el 05 sept 1975
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    For securing all monies due or to become due from the british land company limited to the chargee under the terms of an agreement contained in a letter dated 30/3/73 and a further agreement dated 13/11/73
    Breve descripción
    211/213, regent street london W1.
    Personas con derecho
    • First National City Bank
    Transacciones
    • 05 sept 1975Registro de una carga
    • 12 feb 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal charge
    Creado el 02 sept 1975
    Entregado el 05 sept 1975
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    For securing all monies due or to become due from the british land company limited to the chargee under the terms of an agreement contained in a letter dated 30/08/73 and a further agreement dated 13/11/73.
    Breve descripción
    211/213, regent street london W1.
    Personas con derecho
    • First Nationa City Bank
    Transacciones
    • 05 sept 1975Registro de una carga
    • 12 feb 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal charge
    Creado el 23 jun 1975
    Entregado el 25 jun 1975
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    For securing all monies due or to become due from the british land company limited to the chargee under or guarantee dated 23/6/75.
    Breve descripción
    211/213, regent street london W1.
    Personas con derecho
    • First National City Bank
    Transacciones
    • 25 jun 1975Registro de una carga
    • 12 feb 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    Further charge
    Creado el 28 sept 1973
    Entregado el 09 oct 1973
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    For securing sterling pounds 990788 due from the company and all or any of the six. Other companies named therein
    Breve descripción
    Granville arcade london borough of lambeth being the property comprised in a charge dates 6/4/73.
    Personas con derecho
    • Royal Liver Trustees LTD.
    Transacciones
    • 09 oct 1973Registro de una carga
    • 12 feb 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal charge
    Creado el 17 abr 1973
    Entregado el 19 abr 1973
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    For securing sterling pounds 1400000 duefrom the company and/or all or any of the six other companies named therein
    Breve descripción
    Granville arcade, lambeth, london.
    Personas con derecho
    • Royal Liver Trustees LTD.
    Transacciones
    • 19 abr 1973Registro de una carga
    • 12 feb 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    Deed
    Creado el 06 abr 1973
    Entregado el 19 abr 1973
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    Deed effecting substitution of security for securing sterling pounds 2609212 outstanding under and secured by a charge dated U5-7-54 and deeds supplemental thereto.
    Breve descripción
    Granville arcade, lambeth, london.
    Personas con derecho
    • Royal Liver Trusteed LTD
    Transacciones
    • 19 abr 1973Registro de una carga
    • 12 feb 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    Deed of covenant and further charges
    Creado el 31 mar 1966
    Entregado el 06 abr 1966
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    Securing 235,000 inclusive of £129,432 outstanding and secured by three charges all dated 4/5/56
    Breve descripción
    All the land and premises charges by the b mortgage off 4-5(56.
    Personas con derecho
    • W. M. Newton
    • J.F. Mcevoy
    • F. Halesti
    Transacciones
    • 06 abr 1966Registro de una carga
    • 12 feb 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    Further charge
    Creado el 12 feb 1965
    Entregado el 16 feb 1965
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    Sterling pounds 11198
    Breve descripción
    9, montpelier ave, ealing, middx. 3, crane way, 13,17,24 and 48, hall farm drive, and 73, warren rd, whitton, middx. Office, factory & premises off faggs rd, feltenham, middx. 330332, 332A and 334/344(even) kingston rd, merton, wimbledon, surrey.
    Personas con derecho
    • Trustees of the Royal Liver Friendly Society
    Transacciones
    • 16 feb 1965Registro de una carga
    • 12 feb 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal charge
    Creado el 20 dic 1963
    Adquirido el 22 mar 1968
    Entregado el 10 abr 1968
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    Sterling pounds 10059
    Breve descripción
    68/72 (even) college street, kempston beds.
    Personas con derecho
    • Bedford Permanent Building Society
    Transacciones
    • 10 abr 1968Registro de una carga
    • 12 feb 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    Mortgage
    Creado el 04 may 1956
    Adquirido el 14 oct 1959
    Entregado el 02 nov 1959
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    Sterling pounds 32000 owing
    Breve descripción
    Part of granville arcade, brixton, london title no. Ln 38033.
    Personas con derecho
    • Trustees of the Royal Liver Friendly Society
    Transacciones
    • 02 nov 1959Registro de una carga
    • 12 feb 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    Mortgage
    Creado el 04 may 1956
    Adquirido el 14 oct 1959
    Entregado el 02 nov 1959
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    Sterling pounds 47432 owing
    Breve descripción
    7 station approach, hinchley wood, surrey title no. Sy 51471 port of granville arcade, coldharbour lane, brixton london,title no. Ln 38034.
    Personas con derecho
    • Trustees of the Royal Liver Friendly Society
    Transacciones
    • 02 nov 1959Registro de una carga
    • 12 feb 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    Mortgage
    Creado el 04 may 1956
    Entregado el 08 may 1956
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    Sterling pounds 50000
    Breve descripción
    Property known as granville arcade, britain, london, railway arch 615 known as 37, atlantic rd, and land adjoining arches 20-25 (inc) near brixton stan.
    Personas con derecho
    • Trustees of the Royal Liver Friendly Society
    Transacciones
    • 08 may 1956Registro de una carga
    • 12 feb 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    Mortgage
    Creado el 29 ene 1954
    Entregado el 02 feb 1954
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    Sterling pounds 38712
    Breve descripción
    Various properties at:- ealing twickenham, and feltham, middlesex and at merton, and richmond surrey. (For details see doc 119).
    Personas con derecho
    • Trustees of the Royal Liver Friendly Society
    Transacciones
    • 02 feb 1954Registro de una carga
    • 12 feb 2019Satisfacción de una carga (MR04)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0