WASELEY TEN LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaWASELEY TEN LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00234336
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de WASELEY TEN LIMITED?

    • (7499) /

    ¿Dónde se encuentra WASELEY TEN LIMITED?

    Dirección de la sede social
    100 Barbirolli Square
    Manchester
    M2 3AB
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de WASELEY TEN LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    COMPASS CATERING SERVICES LIMITED07 may 200207 may 2002
    FORTE CATERING LIMITED03 jun 199103 jun 1991
    TRUSTHOUSE FORTE CATERING LIMITED31 dic 197931 dic 1979
    TRUST HOUSES FORTE CATERING LIMITED25 oct 192825 oct 1928

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de WASELEY TEN LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2008

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para WASELEY TEN LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Déclaration annuelle établie au 24 ago 2010 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital02 sept 2010

    Estado de capital el 02 sept 2010

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 22 abr 2010

    • Capital: GBP 51
    4 páginasSH01

    Resoluciones

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de asignación de valores

    RES10

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Estado de capital el 12 may 2010

    • Capital: GBP 0.25
    4 páginasSH19

    Resoluciones

    Resolutions
    17 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de modificación del Memorándum y/o Artículos de Asociación

    RES01
    capital

    Resoluciones

    Re sect 175 12/03/2010
    RES13

    Cambio de datos del director Guy Paul Cuthbert Parsons el 03 feb 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Paul Victor Harvey el 03 feb 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Grant David Hearn el 03 feb 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Jon William Mortimore el 03 feb 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Jon William Mortimore el 03 feb 2010

    1 páginasCH03

    Déclaration annuelle établie au 05 nov 2009 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2008

    3 páginasAA

    legacy

    7 páginas363a

    legacy

    4 páginas363a

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2007

    3 páginasAA

    legacy

    3 páginas363a

    legacy

    1 páginas288c

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2006

    3 páginasAA

    legacy

    1 páginas288c

    ¿Quiénes son los directivos de WASELEY TEN LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MORTIMORE, Jon William
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    Secretario
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    BritishCompany Director93906210001
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Secretario corporativo
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    HARVEY, Paul Victor
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    Director
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant116809270002
    HEARN, Grant David
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    Director
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director88628480002
    MORTIMORE, Jon William
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    Director
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director93906210001
    PARSONS, Guy Paul Cuthbert
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    Director
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director102187770002
    HICKS, Christopher Michael
    Valpy Cottage 3 St Andrews Road
    RG4 7PH Reading
    Berkshire
    Secretario
    Valpy Cottage 3 St Andrews Road
    RG4 7PH Reading
    Berkshire
    BritishAccountant53932930001
    JACKSON, Kevin David
    Field House
    147 Main Street Sutton Bonington
    LE12 5PE Loughborough
    Secretario
    Field House
    147 Main Street Sutton Bonington
    LE12 5PE Loughborough
    British141586330001
    MASON, Timothy Charles
    231 Station Road
    Knowle
    B93 0PU Solihull
    West Midlands
    Secretario
    231 Station Road
    Knowle
    B93 0PU Solihull
    West Midlands
    British12314170002
    MATHEWS, Benedict John Spurway
    39 Lower Teddington Road
    KT1 4HQ Hampton Wick
    Flat 3
    Surrey
    Secretario
    39 Lower Teddington Road
    KT1 4HQ Hampton Wick
    Flat 3
    Surrey
    British42217530001
    MILLS, John Michael
    33 Peplins Way
    AL9 7UR Brookmans Park
    Hertfordshire
    Secretario
    33 Peplins Way
    AL9 7UR Brookmans Park
    Hertfordshire
    BritishCompany Secretary42268710001
    MITCHLEY, Simon Colin
    8 Priory Road
    IG10 1AF Loughton
    Essex
    Secretario
    8 Priory Road
    IG10 1AF Loughton
    Essex
    British36355940001
    TAUTZ, Helen Jane
    30 South Crescent
    Prittlewell
    SS2 6TA Southend On Sea
    Essex
    Secretario
    30 South Crescent
    Prittlewell
    SS2 6TA Southend On Sea
    Essex
    BritishCompany Secretary37564540001
    WILSON, Paul James
    47 Wordsworth Drive
    SM3 8HE Cheam
    Surrey
    Secretario
    47 Wordsworth Drive
    SM3 8HE Cheam
    Surrey
    British767650001
    FORTE NOMINEES LIMITED
    166 High Holborn
    WC1V 6TT London
    Secretario corporativo
    166 High Holborn
    WC1V 6TT London
    42198970001
    BURNESS, Robert Alexander
    4 Clarendon Close
    W2 2NS London
    Director
    4 Clarendon Close
    W2 2NS London
    BritishOperations Director19166320001
    CHIANDETTI, Gian Battista
    Daneswood
    Monks Walk
    SL5 9AZ South Ascot
    Berkshire
    Director
    Daneswood
    Monks Walk
    SL5 9AZ South Ascot
    Berkshire
    ItalianCatering Services Director35071680001
    CLACK, Peter Melvyn
    37 Keswick Road
    Great Bookham
    KT23 4BQ Leatherhead
    Surrey
    Director
    37 Keswick Road
    Great Bookham
    KT23 4BQ Leatherhead
    Surrey
    BritishFinance Director7668050002
    EDIS-BATES, Jonathan Geoffrey
    The Croft
    Chalfont Lane Chorleywood
    WD3 5PP Rickmansworth
    Hertfordshire
    Director
    The Croft
    Chalfont Lane Chorleywood
    WD3 5PP Rickmansworth
    Hertfordshire
    EnglandBritishSolicitor Company Secretary49678170001
    ENGEL, Anthony Ernest
    Woodside House 8 Butler Road
    GU19 5QF Bagshot
    Surrey
    Director
    Woodside House 8 Butler Road
    GU19 5QF Bagshot
    Surrey
    BritishManaging Director7687180001
    FORTE, Alfonso John
    83 Denham Green Lane
    Denham
    UB9 5LG Uxbridge
    Middlesex
    Director
    83 Denham Green Lane
    Denham
    UB9 5LG Uxbridge
    Middlesex
    United KingdomBritishCaterer54396670002
    FORTE, Rocco Giovanni, The Hon Sir
    21 Cheyne Gardens
    SW3 5QT London
    Director
    21 Cheyne Gardens
    SW3 5QT London
    EnglandBritishChairman Of Forte Plc2725010001
    HICKS, Christopher Michael
    Valpy Cottage 3 St Andrews Road
    RG4 7PH Reading
    Berkshire
    Director
    Valpy Cottage 3 St Andrews Road
    RG4 7PH Reading
    Berkshire
    BritishAccountant53932930001
    JACKSON, Kevin David
    Field House
    147 Main Street Sutton Bonington
    LE12 5PE Loughborough
    Director
    Field House
    147 Main Street Sutton Bonington
    LE12 5PE Loughborough
    EnglandBritishProperty Director141586330001
    KNIGHT, Jeremy Charles
    Seagry 29 Bosley Way
    BH23 2HF Christchurch
    Dorset
    Director
    Seagry 29 Bosley Way
    BH23 2HF Christchurch
    Dorset
    BritishPersonnel Director19166300001
    MILLS, John Michael
    33 Peplins Way
    AL9 7UR Brookmans Park
    Hertfordshire
    Director
    33 Peplins Way
    AL9 7UR Brookmans Park
    Hertfordshire
    BritishChartered Secretary42268710001
    MONNICKENDAM, Anthony Louis
    Auburn House
    39 High Street
    MK46 4EB Olney
    Buckinghamshire
    Director
    Auburn House
    39 High Street
    MK46 4EB Olney
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishManaging Director1013880003
    SMALL, Jeremy Peter
    Cherry Trees
    West Heath
    GU24 0JQ Pirbright
    Surrey
    Director
    Cherry Trees
    West Heath
    GU24 0JQ Pirbright
    Surrey
    EnglandBritishCompany Secretary67168210001
    STEVENS, David John
    42 Burghley Road
    Wimbledon
    SW19 5HN London
    Director
    42 Burghley Road
    Wimbledon
    SW19 5HN London
    BritishGroup Legal Dir56704240001
    TAUTZ, Helen Jane
    30 South Crescent
    Prittlewell
    SS2 6TA Southend On Sea
    Essex
    Director
    30 South Crescent
    Prittlewell
    SS2 6TA Southend On Sea
    Essex
    United KingdomBritishCs37564540001
    TURL, Simon Charles
    Arden House
    Eastwell Road
    LE14 4SS Scalford
    Leicestershire
    Director
    Arden House
    Eastwell Road
    LE14 4SS Scalford
    Leicestershire
    BritishDirector80261230001
    TURNER, Harry
    Shepherds Cottage The Vale Golf &
    Country Club Bishampton Fields
    WR10 2LZ Bishampton Near Pershore
    Worcestershire
    Director
    Shepherds Cottage The Vale Golf &
    Country Club Bishampton Fields
    WR10 2LZ Bishampton Near Pershore
    Worcestershire
    EnglandBritishChief Operating Officer166789700001
    FORTE (UK) LIMITED
    166 High Holborn
    WC1V 6TT London
    Director corporativo
    166 High Holborn
    WC1V 6TT London
    42204690001
    TRAVELREST SERVICES LIMITED
    Parklands Court 24 Parklands
    Birmingham Great Park Rubery
    B45 9PZ Birmingham
    West Midlands
    Director corporativo
    Parklands Court 24 Parklands
    Birmingham Great Park Rubery
    B45 9PZ Birmingham
    West Midlands
    42204690005

    ¿Tiene WASELEY TEN LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Security accession deed
    Creado el 04 feb 2003
    Entregado el 12 feb 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due by any chargor or any other obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All that property situated at kendrick street, warrington. All that property situated at 1 midpoint, dick lane, pudsey, bradford. All that property situated at riverside, nottingham. For further details of all property charged please refer to form 395.. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties("Security Agent")
    Transacciones
    • 12 feb 2003Registro de un cargo (395)
    • 27 sept 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of substitution
    Creado el 10 ago 1955
    Entregado el 16 ago 1955
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    See col 3
    Breve descripción
    Land with buildings thereon situation in pepys street, st olave flart street, london including all fesced plant, macinery and fixtures including biads fixtures (for further eletails see doc no 58 and schedule).
    Personas con derecho
    • The Prudential Assurance Co LTD
    Transacciones
    • 16 ago 1955Registro de una carga

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0