CHAS.ROSE & CO.LIMITED

CHAS.ROSE & CO.LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCHAS.ROSE & CO.LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00235418
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CHAS.ROSE & CO.LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra CHAS.ROSE & CO.LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Elsley Court
    20-22 Great Titchfield Street
    W1W 8BE London
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CHAS.ROSE & CO.LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2018

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CHAS.ROSE & CO.LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Cese del nombramiento de David Forde como director el 31 jul 2020

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 11 jul 2020 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 17 ene 2020

    • Capital: GBP 1.00
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Se ha descontinuado la acción de cancelación obligatoria

    1 páginasDISS40

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    legacy

    3 páginasGUARANTEE1

    legacy

    2 páginasAGREEMENT1

    legacy

    79 páginasPARENT_ACC

    Declaración de confirmación presentada el 11 jul 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Sean Michael Paterson como director el 24 abr 2019

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de David James Tannahill como director el 24 abr 2019

    1 páginasTM01

    Exercice comptable en cours prolongé du 24 ago 2018 au 31 dic 2018

    1 páginasAA01

    Declaración de confirmación presentada el 12 jul 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cancelación total de la carga 9

    2 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 002354180010

    1 páginasMR04

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 19 ago 2017

    3 páginasAA

    Domicilio social registrado cambiado de Jubilee House Second Avenue Burton upon Trent Staffordshire DE14 2WF a Elsley Court 20-22 Great Titchfield Street London W1W 8BE el 08 sept 2017

    1 páginasAD01

    Modification des détails de Punch Taverns (Rh) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 04 sept 2017

    2 páginasPSC05

    Cese del nombramiento de Francesca Appleby como secretario el 29 ago 2017

    1 páginasTM02

    ¿Quiénes son los directivos de CHAS.ROSE & CO.LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MOORE, Christopher John
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    Director
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    United KingdomBritish136853310001
    MOUNTSTEVENS, Lawson John Wembridge
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    Director
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    United KingdomBritish112375050001
    PATERSON, Sean Michael
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4 Broadway Park
    Scotland
    Director
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4 Broadway Park
    Scotland
    ScotlandBritish257892140001
    APPLEBY, Francesca
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secretario
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    191627400001
    BELL, Richard Edgar, Llb Solicitor
    13 Harbury Street
    DE13 0RX Burton On Trent
    Staffordshire
    Secretario
    13 Harbury Street
    DE13 0RX Burton On Trent
    Staffordshire
    British637110001
    HARRIS, Claire Louise
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secretario
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    175487970001
    RUDD, Susan Clare
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    Secretario
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    British81789210004
    STEWART, Claire Susan
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secretario
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    British117216940001
    TYRRELL, Helen
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secretario
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    161623700001
    BASHFORTH, Edward Michael
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Director
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish131551840002
    BELL, Richard Edgar, Llb Solicitor
    13 Harbury Street
    DE13 0RX Burton On Trent
    Staffordshire
    Director
    13 Harbury Street
    DE13 0RX Burton On Trent
    Staffordshire
    British637110001
    CONSTANTINE, Peter Anthony
    83 South Rise
    CF14 0RG Cardiff
    South Glamorgan
    Director
    83 South Rise
    CF14 0RG Cardiff
    South Glamorgan
    WalesBritish114160540001
    DANDO, Stephen Peter
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Director
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish152083750001
    DUTTON, Philip
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Director
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish141395280001
    FORDE, David
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    Director
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    United KingdomIrish180590780001
    JONES, Bruce Abbott
    1 Hall Drive
    DE13 8TF Hanbury
    Staffordshire
    Director
    1 Hall Drive
    DE13 8TF Hanbury
    Staffordshire
    British29595900002
    KEMP, Deborah Jane
    6 Station Road
    Hampton In Arden
    B92 0BJ Solihull
    Director
    6 Station Road
    Hampton In Arden
    B92 0BJ Solihull
    United KingdomBritish79388130005
    MCDONALD, Robert James
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    Director
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    British42019620001
    PRESTON, Neil David
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Director
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish63043630002
    TANNAHILL, David James
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    Director
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    ScotlandBritish237381690001
    WHITEHEAD, Gordon William George
    Rosedale
    24 Jacks Lane
    ST14 8LW Marchington
    Staffordshire
    Director
    Rosedale
    24 Jacks Lane
    ST14 8LW Marchington
    Staffordshire
    British13507460001
    WILFORD, Nicholas James
    The Virgate Church Street
    Swepstone Coalville
    LE6 7SA Leicester
    Leicestershire
    Director
    The Virgate Church Street
    Swepstone Coalville
    LE6 7SA Leicester
    Leicestershire
    British33328990001
    WILKINSON, Anthony Eric
    Bupton Grange
    Longford Lane Longford
    DE6 3DT Ashbourne
    Derbyshire
    Director
    Bupton Grange
    Longford Lane Longford
    DE6 3DT Ashbourne
    Derbyshire
    British4656080002

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de CHAS.ROSE & CO.LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    Scotland
    29 ago 2017
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    Scotland
    No
    Forma jurídicaCorporate
    País de registroScotland
    Autoridad legalUnited Kingdom (Scotland)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registroSc065527
    Naturaleza del control
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre la empresa.
    Punch Taverns (Rh) Limited
    20-22 Great Titchfield Street
    W1W 8BE London
    Elsley Court
    United Kingdom
    06 abr 2016
    20-22 Great Titchfield Street
    W1W 8BE London
    Elsley Court
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene CHAS.ROSE & CO.LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 08 oct 2014
    Entregado el 15 oct 2014
    Satisfecho en su totalidad
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Deutsche Trustee Company Limited as Security Trustee for the Punch Taverns Secured Parties
    Transacciones
    • 15 oct 2014Registro de una carga (MR01)
    • 18 abr 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    Third supplemental deed of charge
    Creado el 03 nov 2003
    Entregado el 20 nov 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other punch taverns secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of first legal mortgage all right, title, interest and benefit, present and future (if any), in, to and under: the f/h or l/h property comprising the further punch taverns mortgaged properties; and all estates or interests in such property and all buildings, trade and other fixtures. By way of fixed security the whole right, title, interest and benefit in and to the whole of the scottish trust property.. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Deutsche Trustee Company Limited (Or Such Other Person Acting as Security Trustee Under Thepunch Taverns First Priority Deed of Charge) (the "Security Trustee")
    Transacciones
    • 20 nov 2003Registro de un cargo (395)
    • 18 abr 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    Deed of charge
    Creado el 22 abr 2002
    Entregado el 08 may 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other spirit secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All right title and interest in to and under the f/h or l/h property comprising in the spirit mortgaged properties owned by it and described in part 1 of schedule 2 to the charge; and all estates or interests in such property and allbuildings, trade and other fixtures, fixed plant and machinery from time to time on such f/h or l/h property. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Deutsche Trustee Company Limited as Trustee for the Spirit Secured Parties
    Transacciones
    • 08 may 2002Registro de un cargo (395)
    • 14 ene 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of charge
    Creado el 22 abr 2002
    Entregado el 08 may 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the security trustee or any of the other pr secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of assignment all of the company's right, title, interest and benefit, present and future in, to and under the master amendment deed.
    Personas con derecho
    • Deutsche Trustee Company Limited
    Transacciones
    • 08 may 2002Registro de un cargo (395)
    • 14 ene 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of charge
    Creado el 28 jun 2000
    Entregado el 15 jul 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys due or to become due from the company, or any other charging company and/or guarantor to the chargee whether for its own account or as trustee for the pr secured parties or any of the other pr secured parties under or in respect of the issuer/borrower facility agreement, the charge and/or any other transaction documents to which it is a party (all as defined therein)
    Breve descripción
    All right title and interest and benefit, in, to and under the f/h and l/h properties owned by it and described in part 1 of schedule 2 to the charge, and all estates or interests in such property and all buildings, trade and other fixtures, fiall right title interest and benefit, in, to and under the f/h xed plant and machinery a floating charge over the undertaking of all property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Bankers Trustee Company Limited "the Security Trustee" (As Defined Therein)
    Transacciones
    • 15 jul 2000Registro de un cargo (395)
    • 24 ene 2003Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 24 ene 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    • 14 ene 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Security agreement
    Creado el 05 oct 1999
    Entregado el 21 oct 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of the obligors (as defined) to any transaction party under each transaction document (as defined) except for any obligation which, if it were so included, would result in the security agreement contravening section 151 of the companies act 1985
    Breve descripción
    By way of first legal mortgage the property defined as abbots way south drive sothway plymouth devon, alsager arms 4 sandbach rd south alsager stoke-on-trent staffs, anchor high st little paxton st neots huntingdon cambs (for full list of all property charged see schedule to form 395) together with fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital building fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Morgan Stanley & Co International Limited as Agent and Trustee for the Transaction Parties (The"Security Trustee")
    Transacciones
    • 21 oct 1999Registro de un cargo (395)
    • 30 may 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 01 may 1942
    Entregado el 13 may 1942
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £3000
    Breve descripción
    Central hotel castle road scarborough.
    Personas con derecho
    • R N Wilkins
    • R W Lund
    • R D Lund
    Transacciones
    • 13 may 1942Registro de una carga
    • 15 sept 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge (supplemental to legal charge dated 7TH jany 1929 for securing all moneys due etc to barclays bank LTD)
    Creado el 26 mar 1941
    Entregado el 06 abr 1941
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Land and the tennyson arms dean road scarborough yorks.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 06 abr 1941Registro de una carga
    • 15 sept 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage
    Creado el 07 ene 1929
    Entregado el 12 ene 1929
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys etc.
    Breve descripción
    Brewery and premises in castlegate malton york the nags head inn and no 28 oxford st scarborough the borough arms and 11 union st and 23 and 24 bedford st scarborough the black swan inn no 25 queen st scarborough.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 12 ene 1929Registro de una carga
    • 26 ago 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage
    Creado el 24 dic 1928
    Entregado el 04 ene 1929
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £2100
    Breve descripción
    Inn hotel & premises in wheelgate malton york golden lion inn premises 3 cottages lana in great borugh york.
    Personas con derecho
    • J. F. Clarkson
    • J. L. Clarkson
    Transacciones
    • 04 ene 1929Registro de una carga
    • 15 sept 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0