ERON INVESTMENTS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | ERON INVESTMENTS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 00237658 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de ERON INVESTMENTS LIMITED?
- Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción
¿Dónde se encuentra ERON INVESTMENTS LIMITED?
| Dirección de la sede social | 100 Victoria Street SW1E 5JL London United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de ERON INVESTMENTS LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2017 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para ERON INVESTMENTS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Louise Miller como director el 01 ene 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mrs Elizabeth Miles como director el 01 ene 2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2017 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Cancelación total de la carga 2 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 5 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 4 | 2 páginas | MR04 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 12 may 2017 con actualizaciones | 6 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Michael Arnaouti como director el 31 mar 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Louise Miller como director el 01 mar 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Michael Arnaouti el 16 ene 2017 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Ls Company Secretaries Limited el 10 ene 2017 | 1 páginas | CH04 | ||||||||||
Cambio de datos del director Ls Director Limited el 10 ene 2017 | 1 páginas | CH02 | ||||||||||
Cambio de datos del director Land Securities Management Services Limited el 10 ene 2017 | 1 páginas | CH02 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 5 Strand London WC2N 5AF a 100 Victoria Street London SW1E 5JL el 10 ene 2017 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2016 | 13 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 21 jun 2016 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2015 | 12 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 29 jun 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nombramiento de Mr Michael Arnaouti como director el 01 abr 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Adrian Michael De Souza como director el 31 mar 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2014 | 9 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 29 jun 2014 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de ERON INVESTMENTS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS COMPANY SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | Victoria Street SW1E 5JL London 100 United Kingdom |
| 159674790001 | ||||||||||
| MILES, Elizabeth | Director | Victoria Street SW1E 5JL London 100 United Kingdom | United Kingdom | British | 235498150001 | |||||||||
| LAND SECURITIES MANAGEMENT SERVICES LIMITED | Director corporativo | Victoria Street SW1E 5JL London 100 United Kingdom | 74974580001 | |||||||||||
| LS DIRECTOR LIMITED | Director corporativo | Victoria Street SW1E 5JL London 100 United Kingdom |
| 133814600001 | ||||||||||
| DUDGEON, Peter Maxwell | Secretario | 41 Links Road KT17 3PP Epsom Surrey | British | 14674480002 | ||||||||||
| JONES, Laurance Aubrey | Secretario | 242 Cromwell Tower Barbican EC2Y 8DD London | British | 13653250002 | ||||||||||
| ARNAOUTI, Michael | Director | Victoria Street SW1E 5JL London 100 United Kingdom | England | British | 539040004 | |||||||||
| DE BARR, Robert Henry | Director | Watermark Thames Lawn St Peter Street SL7 1QA Marlow Buckinghamshire | England | British | 14885390006 | |||||||||
| DE SOUZA, Adrian Michael | Director | Strand WC2N 5AF London 5 United Kingdom | United Kingdom | British | 158381390001 | |||||||||
| DUDGEON, Peter Maxwell | Director | 41 Links Road KT17 3PP Epsom Surrey | United Kingdom | British | 14674480002 | |||||||||
| GRIFFITHS, Michael Robert | Director | Maidirin Rua Camden Road DA5 3NP Bexley Kent | England | British | 13422390003 | |||||||||
| HENDERSON, Ian James | Director | Crouch House TN8 5LQ Edenbridge Kent | England | United Kingdom | 14674060001 | |||||||||
| HUNT, Peter John, Sir | Director | 37 Devonshire Mews West W1N 1FQ London | British | 13653440001 | ||||||||||
| MATHIESON, William | Director | 14 Quickswood Primrose Hill NW3 3SE London | British | 37425010001 | ||||||||||
| MILLER, Louise | Director | Victoria Street SW1E 5JL London 100 United Kingdom | United Kingdom | British | 199935770001 | |||||||||
| MURRAY, James Ian Keith | Director | 8 Pines Road BR1 2AA Bickley Kent | British | 13422400003 | ||||||||||
| REDSHAW, Keith | Director | 2 Pound Farm Close KT10 8EX Esher Surrey | England | British | 85333010001 | |||||||||
| SALWAY, Francis William | Director | Nash House 25 Mount Sion TN1 1TZ Tunbridge Wells Kent | United Kingdom | British | 72491970003 | |||||||||
| STRANGE, Alfred Richard Frank | Director | 25 Hollingbourne Gardens Ealing W13 8EN London | British | 13422420001 | ||||||||||
| LAND SECURITIES PORTFOLIO MANAGEMENT LIMITED | Director corporativo | 5 Strand WC2N 5AF London | 100069790001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de ERON INVESTMENTS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land Securities Portfolio Management Limited | 06 abr 2016 | Victoria Street SW1E 5JL London 100 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene ERON INVESTMENTS LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Obligor floating charge agreement | Creado el 03 nov 2004 Entregado el 16 nov 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from finco and the company and each obligor to the chargee and all monies due or to become due from the obligors to the note trustee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción First floating charge all present and future assets and undertaking of the company. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Security trust and intercreditor deed | Creado el 03 nov 2004 Entregado el 16 nov 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from each obligor to any obligor secured creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción All rights title and interests in 1) the original mortgaged properties 2) any real property 3) all plant machinery and other chattels 4) the obligor accounts 5) all shares and all dividends 6) all rights under any agreement 7) all intellectual property rights 8) all interest in any eligible investments 9) all goodwill 10) all uncalled share capital 11) all monetary claims and related rights. By way of assignment all rental income, all proceeds receivable and all obligor transaction documents. By way of floating charge all assets and undertakings. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Deed of release and substitution | Creado el 28 oct 1999 Entregado el 29 oct 1999 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the trust deeds dated 29TH july 1955 and 28TH july 1955 | |
Breve descripción The f/h property k/a 7/9 pilgrim street and 10/13 ludgate broadway london EC4. T/no. Ln 221398. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Trust deed | Creado el 01 oct 1991 Entregado el 04 oct 1991 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada The principal of and interest on the £200,000,000, 10 per cent. First mortgage debenture stock 2027 (the "stock") of land securities PLC and all other moneys intended to be secured by the trust deed | |
Breve descripción Freehold land known as ling house, 10-13 dominion street in the london borough of islington title no ln 170275 (see for full details doc M68). | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Deed of assurance | Creado el 31 mar 1989 Entregado el 04 abr 1989 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £400,000 10% first mortgage debenture stock 2025 of land securities PLC and all other moneys due or to become due under the terms of the terms of the trust deed dated 8/11/85 and supplemental deeds thereto | |
Breve descripción All that f/h land & premises k/a 10 to 13 ludgate broadway and 7 & 9 pilgrim street in the city of london title no ln 221398. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0