THE HEART OF ENGLAND BAPTIST ASSOCIATION
Visión general
Nombre de la empresa | THE HEART OF ENGLAND BAPTIST ASSOCIATION |
---|---|
Estado de la empresa | Activa |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social |
Número de empresa | 00238738 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de THE HEART OF ENGLAND BAPTIST ASSOCIATION?
- Actividades de organizaciones religiosas (94910) / Otras actividades de servicios
¿Dónde se encuentra THE HEART OF ENGLAND BAPTIST ASSOCIATION?
Dirección de la sede social | 480 Chester Road B73 5BP Sutton Coldfield England |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de THE HEART OF ENGLAND BAPTIST ASSOCIATION?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
WEST MIDLAND BAPTIST(TRUST)ASSOCIATION(INCORPORATED)(THE) | 15 abr 1929 | 15 abr 1929 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de THE HEART OF ENGLAND BAPTIST ASSOCIATION?
Vencido | No |
---|---|
Próximas cuentas | |
Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2024 |
Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2025 |
Últimas cuentas | |
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2023 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para THE HEART OF ENGLAND BAPTIST ASSOCIATION?
Última declaración de confirmación cerrada hasta | 21 may 2025 |
---|---|
Próxima declaración de confirmación vence | 04 jun 2025 |
Última declaración de confirmación | |
Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 21 may 2024 |
Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para THE HEART OF ENGLAND BAPTIST ASSOCIATION?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombramiento de Reverend Denise Ann Dobie como director el 26 nov 2024 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Christopher Austin Knight como director el 06 dic 2024 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Reverend John Alexander Bernard como director el 30 sept 2024 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Edward Morton Pillar como director el 26 sept 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2023 | 51 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Mercy Adhiambo Otieno Mbajah como director el 31 may 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 21 may 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Duncan Charles Maclean como director el 12 mar 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Glenford Alexander Gordon como director el 13 ene 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 7 | 2 páginas | MR04 | ||||||||||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2022 | 52 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 21 may 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Rev Dr Antony Bryan Maude el 27 feb 2023 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Nombramiento de Mrs Mercy Adhiambo Otieno Mbajah como director el 20 ene 2023 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Notification d'une déclaration relative à une personne disposant d'un contrôle significatif | 2 páginas | PSC08 | ||||||||||
Nombramiento de Rev Terry Ian Lockyer como director el 17 oct 2022 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cessation de Edward John Rye en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 27 oct 2022 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Edward John Rye como director el 01 sept 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2021 | 53 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Ms Karen Averil Martindale el 22 jul 2022 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Doreen Jean Walker como director el 06 jun 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 21 may 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Memorándum y Estatutos | 18 páginas | MA | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cambio de datos del director Rev Dr Anthony Bryan Maude el 08 feb 2022 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de THE HEART OF ENGLAND BAPTIST ASSOCIATION?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTINDALE, Karen Averil | Secretario | Chester Road B73 5BP Sutton Coldfield 480 England | British | Administrator | 81259730001 | |||||
ARGILE, Adrian Stuart, Rev | Director | Chester Road B73 5BP Sutton Coldfield 480 England | United Kingdom | British | Minister Of Religion | 62876130002 | ||||
BERNARD, John Alexander, Revd | Director | Chester Road B73 5BP Sutton Coldfield 480 England | England | British | Baptist Minister | 327985680001 | ||||
DOBIE, Denise Ann, Reverend | Director | Chester Road B73 5BP Sutton Coldfield 480 England | England | British | Minister Of Religion | 155604930001 | ||||
GREEN, Joanne | Director | Chester Road B73 5BP Sutton Coldfield 480 England | England | British | Education Advisor | 158142820001 | ||||
KNIGHT, Christopher Austin | Director | Chester Road B73 5BP Sutton Coldfield 480 England | United Kingdom | British | Finance Director (Retired) | 300512180001 | ||||
LOCKYER, Terry Ian, Rev | Director | Chester Road B73 5BP Sutton Coldfield 480 England | England | British | Ceo Of A Charity | 301608460001 | ||||
MAUDE, Antony Bryan, Rev Dr | Director | Chester Road B73 5BP Sutton Coldfield 480 England | United Kingdom | British | Baptist Minister | 292167530003 | ||||
MILLER, Judith | Director | Chester Road B73 5BP Sutton Coldfield 480 England | England | British | Self-Employed | 91979110001 | ||||
WEARING, Amy Louise, Revd | Director | Chester Road B73 5BP Sutton Coldfield 480 England | England | British | Baptist Minister | 276130540001 | ||||
EGGINTON, Peter, Rev | Secretario | Little St Edwards 175 West Malvern Road WR14 4AY Malvern Worcestershire | British | 48717780001 | ||||||
SMITH, Barrie, Reverend | Secretario | 57 Doveridge Road B28 0LT Birmingham | British | Minister Of Religion | 27193790002 | |||||
SMITH, Barrie, Reverend | Secretario | 57 Doveridge Road B28 0LT Birmingham | British | Minister Of Religion | 27193790002 | |||||
BEESLEY, Paul Richard | Director | 11 Hollyfield Crescent B75 7SW Sutton Coldfield West Midlands | British | Teacher | 91458090001 | |||||
BENNETT, Neil Stuart, Rev | Director | 24 Weoley Park Road Selly Oak B29 6QX Birmingham Bms International Mission Centre West Midlands | United Kingdom | British | Baptist Minister | 204130770001 | ||||
BETTERIDGE, Alan, Reverend | Director | 33 Cannon Hill Road CV4 7DE Coventry West Midlands | British | Baptist Minister Retired | 76720950001 | |||||
BIGGIN, Geoffrey Ernest | Director | 24 Weoley Park Road Selly Oak B29 6QX Birmingham Bms International Mission Centre West Midlands | England | British | Retired Civil Servant | 204116970001 | ||||
BLUNN, John Stanley | Director | 54 Bilston Road WV13 2JL Willenhall West Midlands | British | College Co Ordinator | 34702740001 | |||||
BROOKES, Dorien | Director | 24 Weoley Park Road Selly Oak B29 6QX Birmingham Bms International Mission Centre West Midlands | United Kingdom | British | Senior Site Technician | 179994690001 | ||||
BROWN, Raymond John | Director | 16 Goodwyn Avenue Oldbury B68 0ES Warley West Midlands | British | Surveyor | 13463830001 | |||||
CARTER, Timothy Leonard | Director | Cranmere Lillington Avenue CV32 5UE Leamington Spa Warwickshire | British | Baptist Minister | 39788940001 | |||||
CHALLINOR, Clifford Henry | Director | Kingsley Minsterley Road Pontesbury SY5 0QH Shrewsbury Salop | British | Secretary | 13463840001 | |||||
COCKBILL, Elaine Susan Lee, Reverend | Director | 268 Sandon Road ST16 3HL Stafford Staffordshire | British | Minister Of Religion | 83075680001 | |||||
COLLIS, Michael John, Reverend | Director | 41 Montville Drive ST17 9XJ Stafford Staffordshire | British | Baptist Minister | 48751290001 | |||||
COOKE, Philip John | Director | Hollyoak 1 White House Drive Barnt Green B45 8HF Birmingham | England | British | Chartered Accountant | 51352620001 | ||||
COPSON, Stephen Leonard, Reverend | Director | 9 Silver Birch Road Erdington B24 0AR Birmingham West Midlands | British | Minister Of Religion | 63712670001 | |||||
COUCHMAN, Patricia | Director | 24 Weoley Park Road Selly Oak B29 6QX Birmingham Bms International Mission Centre West Midlands | England | British | Retired | 186040160001 | ||||
CREBBIN, Linda Elsie, Reverend | Director | 24 Weoley Park Road Selly Oak B29 6QX Birmingham Bms International Mission Centre West Midlands | England | British | Minister Of Religion | 114716140001 | ||||
DWYER, Peter, The Revd | Director | 88 Franche Road DY11 5BJ Kidderminster Worcestershire | British | Minister Of Religion | 56001660001 | |||||
EAVES, Charles Dennis | Director | 24 Weoley Park Road Selly Oak B29 6QX Birmingham Bms International Mission Centre West Midlands | England | British | Retired Electrical Engineer | 133652790002 | ||||
EGGINTON, Peter, Reverend | Director | 33 Hunnington Crescent B63 3DJ Halesowen West Midlands | British | Retired | 48717780002 | |||||
EGGINTON, Peter, Rev | Director | Little St Edwards 175 West Malvern Road WR14 4AY Malvern Worcestershire | British | General Secretary Of West Midland Baptist Associat | 48717780001 | |||||
FERGUSSON, Timothy Robert, Rev | Director | 24 Weoley Park Road Selly Oak B29 6QX Birmingham Bms International Mission Centre West Midlands | United Kingdom | British | Minister Of Religion | 179776620001 | ||||
FIRMIN, Audrey Carol | Director | 9 Fairwater Crescent B49 6QX Alcester Warwickshire | British | Housewife | 91586090001 | |||||
FOREMAN, Harold, Reverend Doctor | Director | Lawrence House 33 Main Road Ketley Bank TF2 0DH Telford Salop | British | Minister Of Religion | 13463860001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de THE HEART OF ENGLAND BAPTIST ASSOCIATION?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado |
---|---|---|---|
Mr Edward John Rye | 13 oct 2016 | Chester Road B73 5BP Sutton Coldfield 480 England | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||
Naturaleza del control
|
¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para THE HEART OF ENGLAND BAPTIST ASSOCIATION?
Notificado el | Cesado el | Declaración |
---|---|---|
17 nov 2022 | La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa. |
¿Tiene THE HEART OF ENGLAND BAPTIST ASSOCIATION alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Legal charge | Creado el 01 may 2009 Entregado el 19 may 2009 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the trustees of perry beeches baptist church (the borrower) to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción F/H property k/a perry beeches baptist church, beeches road, birmingham t/no WM920696 which includes all buildings, roads, ways, sewers, see image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal charge | Creado el 19 jun 2007 Entregado el 26 jun 2007 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción F/H 183 west heath road west heath t/n WM81849. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal charge | Creado el 17 nov 2006 Entregado el 23 nov 2006 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company for the trustees of the church of the redeemer to the chargee | |
Breve descripción 12 anchor road edgbaston birmingham. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal charge | Creado el 06 mar 2006 Entregado el 17 mar 2006 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Cannon street memorial baptist church 300 soho road handsworth birmingham t/no WM864158. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Further charge | Creado el 04 nov 2005 Entregado el 10 nov 2005 | Pendiente | Cantidad garantizada £17,100.00 due or to become due from the company to | |
Breve descripción Christ church mission hall victoria road handsworth birmingham. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal charge | Creado el 08 ene 2004 Entregado el 23 ene 2004 | Pendiente | Cantidad garantizada £171,770.00 due or to become due from the company to the chargee | |
Breve descripción Christ church mission hall victoria road handsworth birmingham. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal charge | Creado el 17 sept 2002 Entregado el 21 sept 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción The f/h property k/a 7 pinewoods, bartley green, birmingham t/no. WM529177. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Mortgage | Creado el 20 oct 2000 Entregado el 24 oct 2000 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £97,145 due or to become due from the company to the chargee | |
Breve descripción 4 hewell road barnt green bromsgrove. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0