CMPI HOLDINGS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | CMPI HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 00239142 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de CMPI HOLDINGS LIMITED?
- Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo
¿Dónde se encuentra CMPI HOLDINGS LIMITED?
| Dirección de la sede social | 5 Howick Place SW1P 1WG London United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CMPI HOLDINGS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| UTRAVEL.CO.UK LIMITED | 12 jul 2000 | 12 jul 2000 |
| UNITED BUSINESS MEDIA LIMITED | 28 jun 2000 | 28 jun 2000 |
| MILLER FREEMAN UK LIMITED | 08 abr 1998 | 08 abr 1998 |
| MILLER FREEMAN PLC | 01 jun 1995 | 01 jun 1995 |
| MORGAN - GRAMPIAN P L C | 30 abr 1929 | 30 abr 1929 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de CMPI HOLDINGS LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2018 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para CMPI HOLDINGS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 2 páginas | DS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2018 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 31 dic 2018 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Carl Sheldon Adrian el 07 dic 2018 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Crosswall Nominees Limited el 04 dic 2018 | 1 páginas | CH02 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 240 Blackfriars Road London SE1 8BF a 5 Howick Place London SW1P 1WG el 06 dic 2018 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Crosswall Nominees Limited el 04 dic 2018 | 1 páginas | CH04 | ||||||||||
Cambio de datos del director Unm Investments Limited el 04 dic 2018 | 1 páginas | CH02 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2017 | 18 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 31 dic 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016 | 18 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 31 dic 2016 con actualizaciones | 6 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015 | 18 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 31 dic 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2014 | 14 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 10 abr 2015 avec liste complète des actionnaires | 15 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Se ha descontinuado la acción de cancelación obligatoria | 1 páginas | DISS40 | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ1 | ||||||||||
Cambio de datos del director Crosswall Nominees Limited el 16 feb 2015 | 1 páginas | CH02 | ||||||||||
Cambio de datos del director Carl Adrian el 16 feb 2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Unm Investments Limited el 16 feb 2015 | 1 páginas | CH02 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Crosswall Nominees Limited el 16 feb 2015 | 1 páginas | CH04 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Ludgate House 245 Blackfriars Road London SE1 9UY a 240 Blackfriars Road London England SE1 8BF el 17 abr 2015 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de CMPI HOLDINGS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROSSWALL NOMINEES LIMITED | Secretario corporativo | Howick Place SW1P 1WG London 5 United Kingdom |
| 992770004 | ||||||||||
| ADRIAN, Carl Sheldon | Director | Howick Place SW1P 1WG London 5 United Kingdom | United Kingdom | British | 134006860001 | |||||||||
| CROSSWALL NOMINEES LIMITED | Director corporativo | Howick Place SW1P 1WG London 5 United Kingdom |
| 992770004 | ||||||||||
| UNM INVESTMENTS LIMITED | Director corporativo | Howick Place SW1P 1WG London 5 United Kingdom |
| 48157320003 | ||||||||||
| PURSER, Jean Dorothy Anne | Secretario | The Dumbles 7 Ashdown View TN22 3HX Nutley East Sussex | British | 94669070001 | ||||||||||
| SECKER, James | Secretario | Berwyn 1 Links Close TN6 1QW Crowborough East Sussex | British | 1219420001 | ||||||||||
| SIMPSON, Mark Andrew Goodman | Secretario | Crockford House Snow Hill Crawley Down RH10 3EE Crawley West Sussex | British | 56280120001 | ||||||||||
| CROSSWALL NOMINEES LIMITED | Secretario corporativo | 245 Blackfriars Road SE1 9UY London Ludgate House | 992770004 | |||||||||||
| ARNOLD, Anthony Burton | Director | Oldbury Farm Southend Road Great Wakering SS3 0PJ Southend On Sea Essex | United Kingdom | British | 8572820001 | |||||||||
| ARNOLD, Stanley Richard | Director | Great Bubhurst Farm Bubhurst Lane Frittenden TN17 2BD Cranbrook Kent | British | 34857830001 | ||||||||||
| BAKER, David Arthur | Director | Oakwood Shoreham Road Otford TN14 5RN Sevenoaks Kent | British | 6265440001 | ||||||||||
| BRAZIER, John Ansell | Director | Little Croft 22 Norbury Way KT23 4RY Great Bookham Surrey | England | British | 53359450001 | |||||||||
| CAMPBELL, James Milne | Director | 22 Lower Hill Road KT19 8LT Epsom Surrey | British | 49487790001 | ||||||||||
| CONLON, Denis | Director | Woodstock Westmore Road Tatsfield TN16 2BJ Westerham Kent | British | 8471710001 | ||||||||||
| CUNNINGHAM, Paul | Director | 110 Chestnut Grove SW12 8JJ London | British | 17122880004 | ||||||||||
| DE CARLE, John Brian | Director | Folly Hill Cottage Friezley Lane TN17 2LL Cranbrook Kent | British | 8317060001 | ||||||||||
| DOWNING, Brian George Kirby | Director | 35 Badingham Drive Fetcham KT22 9EU Leatherhead Surrey | British | 8426380001 | ||||||||||
| ELLINGS, Clive Bryan | Director | Priors Lea The Drive SL8 5RE Bourne End Buckinghamshire | United Kingdom | British | 66808150001 | |||||||||
| ELTON, Graham Clive | Director | Palmers Farm Hawkenbury Road TN3 9AD Tunbridge Wells Kent | England | British | 40436370002 | |||||||||
| ELTON, Graham Clive | Director | Palmers Farm Hawkenbury Road TN3 9AD Tunbridge Wells Kent | England | British | 40436370002 | |||||||||
| FERGUSON, Ailsa Murray | Director | 18 Hosack Road SW17 7QP London | British | 69565050001 | ||||||||||
| FOSTER, Maurice Curtis | Director | White House Farm Ivy Hatch TN15 0NN Sevenoaks Kent | British | 8173280001 | ||||||||||
| FREEMAN, Marshall William | Director | PO BOX 645 94528 Diablo California Usa | American | 11882820001 | ||||||||||
| GRAY, Bernard Peter | Director | Apartment 35 Blk B 3rd Floor 10 Wild Street WC2B 4RL London | British | 108397670001 | ||||||||||
| JAKES, Clifford Duncan | Director | Littlehay Burley BH24 4AG Ringwood Hampshire | British | 8426370001 | ||||||||||
| KING, Harold Leslie | Director | 17 Wildcroft Manor Wildcroft Road SW15 3TS London | British | 14996700001 | ||||||||||
| LEVY, Rupert James | Director | 25 Muswell Avenue N10 2EB London | British | 57681630002 | ||||||||||
| LLOYD, Julian Stuart | Director | 6 Queens Gate Villas Victoria Park Road E9 7BU London | British | 59624160002 | ||||||||||
| LOMAX, Diana | Director | 17 Parsons Green Lane SW6 4HL London | British | 49719540003 | ||||||||||
| MCALEENAN, Patrick David | Director | Hazlewell Road Putney SW15 6UR London 78 | England | British | 14226510001 | |||||||||
| MELVILLE, Iain Boyd | Director | 34 Waterlow Road RH2 7EX Reigate Surrey | British | 34669410002 | ||||||||||
| MICHAEL, Roger Lucas | Director | 22 Greenways WD5 0EU Abbots Langley Hertfordshire | United Kingdom | British | 99335210001 | |||||||||
| NAUGHTON, Shane Paul | Director | 41 Neville House 19 Page Street, Westminster SW1P 4JX London | Irish | 124972750001 | ||||||||||
| NUGEE, Andrew | Director | 47 Breer Street SW6 3HE London | British | 78161450001 | ||||||||||
| NUGEE, Andrew | Director | 47 Breer Street SW6 3HE London | British | 78161450001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de CMPI HOLDINGS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubmg Holdings | 30 jun 2016 | Blackfriars Road SE1 8BF London 240 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene CMPI HOLDINGS LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Mortgage | Creado el 06 feb 1984 Entregado el 16 feb 1984 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this charge & a charge dated 31-10-1983. | |
Breve descripción All monies standing to the credit of the amount & all interest of the company therein both present & future at lloyds bank PLC designated "morgan-grampian PLC" re-"the far pavilions" and numbered 0933717. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Charge | Creado el 31 oct 1983 Entregado el 30 nov 1983 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter dated 26-10-83 or under the terms of the charge | |
Breve descripción Agreement, rights, and the benefit of the guarantee see doc for details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Facility letter | Creado el 26 oct 1983 Entregado el 03 nov 1983 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the chargee dated 31-10/83 | |
Breve descripción Fixed charge over all monies then or thereafter standing to the credit of account designated "morgan-grampian PLC" re "the far pavilions" (see doc M209). | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Omnibus letter of set-off | Creado el 30 jun 1982 Entregado el 08 jul 1982 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever. | |
Breve descripción All sums standing to the credit of any account of the company with the bank. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Omnibus letter of set-off | Creado el 26 feb 1982 Entregado el 05 mar 1982 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee | |
Breve descripción All sums standing to the credit of the company with the bank. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Charge | Creado el 10 ago 1978 Entregado el 10 ago 1982 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee s under the terms of a guarantee dated 10TH august 1982 | |
Breve descripción All book debts and other debts present and future. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal mortgage | Creado el 02 ago 1971 Entregado el 03 ago 1971 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción 28/31, essex st. City of westminster and vaults beneath essex st.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 27 jun 1969 Entregado el 07 jul 1969 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción 36, 37, 39 essex st & 2, 3, devereux court - 248596 together with machinery & fixtures, & floating charge on implements (see doc 106 for further details). | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0