CMPI HOLDINGS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCMPI HOLDINGS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00239142
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CMPI HOLDINGS LIMITED?

    • Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo

    ¿Dónde se encuentra CMPI HOLDINGS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    5 Howick Place
    SW1P 1WG London
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CMPI HOLDINGS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    UTRAVEL.CO.UK LIMITED12 jul 200012 jul 2000
    UNITED BUSINESS MEDIA LIMITED28 jun 200028 jun 2000
    MILLER FREEMAN UK LIMITED08 abr 199808 abr 1998
    MILLER FREEMAN PLC01 jun 199501 jun 1995
    MORGAN - GRAMPIAN P L C30 abr 192930 abr 1929

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CMPI HOLDINGS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2018

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CMPI HOLDINGS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    2 páginasDS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2018

    6 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 31 dic 2018 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cambio de datos del director Carl Sheldon Adrian el 07 dic 2018

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Crosswall Nominees Limited el 04 dic 2018

    1 páginasCH02

    Domicilio social registrado cambiado de 240 Blackfriars Road London SE1 8BF a 5 Howick Place London SW1P 1WG el 06 dic 2018

    1 páginasAD01

    Cambio de datos del secretario Crosswall Nominees Limited el 04 dic 2018

    1 páginasCH04

    Cambio de datos del director Unm Investments Limited el 04 dic 2018

    1 páginasCH02

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2017

    18 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 31 dic 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016

    18 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 31 dic 2016 con actualizaciones

    6 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015

    18 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 31 dic 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital08 ene 2016

    Estado de capital el 08 ene 2016

    • Capital: GBP .995
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2014

    14 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 10 abr 2015 avec liste complète des actionnaires

    15 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital18 ago 2015

    Estado de capital el 18 ago 2015

    • Capital: GBP .995459
    SH01

    Se ha descontinuado la acción de cancelación obligatoria

    1 páginasDISS40

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Cambio de datos del director Crosswall Nominees Limited el 16 feb 2015

    1 páginasCH02

    Cambio de datos del director Carl Adrian el 16 feb 2015

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Unm Investments Limited el 16 feb 2015

    1 páginasCH02

    Cambio de datos del secretario Crosswall Nominees Limited el 16 feb 2015

    1 páginasCH04

    Domicilio social registrado cambiado de Ludgate House 245 Blackfriars Road London SE1 9UY a 240 Blackfriars Road London England SE1 8BF el 17 abr 2015

    1 páginasAD01

    ¿Quiénes son los directivos de CMPI HOLDINGS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    CROSSWALL NOMINEES LIMITED
    Howick Place
    SW1P 1WG London
    5
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    Howick Place
    SW1P 1WG London
    5
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro950209
    992770004
    ADRIAN, Carl Sheldon
    Howick Place
    SW1P 1WG London
    5
    United Kingdom
    Director
    Howick Place
    SW1P 1WG London
    5
    United Kingdom
    United KingdomBritish134006860001
    CROSSWALL NOMINEES LIMITED
    Howick Place
    SW1P 1WG London
    5
    United Kingdom
    Director corporativo
    Howick Place
    SW1P 1WG London
    5
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro950209
    992770004
    UNM INVESTMENTS LIMITED
    Howick Place
    SW1P 1WG London
    5
    United Kingdom
    Director corporativo
    Howick Place
    SW1P 1WG London
    5
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro1219152
    48157320003
    PURSER, Jean Dorothy Anne
    The Dumbles
    7 Ashdown View
    TN22 3HX Nutley
    East Sussex
    Secretario
    The Dumbles
    7 Ashdown View
    TN22 3HX Nutley
    East Sussex
    British94669070001
    SECKER, James
    Berwyn 1 Links Close
    TN6 1QW Crowborough
    East Sussex
    Secretario
    Berwyn 1 Links Close
    TN6 1QW Crowborough
    East Sussex
    British1219420001
    SIMPSON, Mark Andrew Goodman
    Crockford House Snow Hill
    Crawley Down
    RH10 3EE Crawley
    West Sussex
    Secretario
    Crockford House Snow Hill
    Crawley Down
    RH10 3EE Crawley
    West Sussex
    British56280120001
    CROSSWALL NOMINEES LIMITED
    245 Blackfriars Road
    SE1 9UY London
    Ludgate House
    Secretario corporativo
    245 Blackfriars Road
    SE1 9UY London
    Ludgate House
    992770004
    ARNOLD, Anthony Burton
    Oldbury Farm Southend Road
    Great Wakering
    SS3 0PJ Southend On Sea
    Essex
    Director
    Oldbury Farm Southend Road
    Great Wakering
    SS3 0PJ Southend On Sea
    Essex
    United KingdomBritish8572820001
    ARNOLD, Stanley Richard
    Great Bubhurst Farm
    Bubhurst Lane Frittenden
    TN17 2BD Cranbrook
    Kent
    Director
    Great Bubhurst Farm
    Bubhurst Lane Frittenden
    TN17 2BD Cranbrook
    Kent
    British34857830001
    BAKER, David Arthur
    Oakwood Shoreham Road
    Otford
    TN14 5RN Sevenoaks
    Kent
    Director
    Oakwood Shoreham Road
    Otford
    TN14 5RN Sevenoaks
    Kent
    British6265440001
    BRAZIER, John Ansell
    Little Croft 22 Norbury Way
    KT23 4RY Great Bookham
    Surrey
    Director
    Little Croft 22 Norbury Way
    KT23 4RY Great Bookham
    Surrey
    EnglandBritish53359450001
    CAMPBELL, James Milne
    22 Lower Hill Road
    KT19 8LT Epsom
    Surrey
    Director
    22 Lower Hill Road
    KT19 8LT Epsom
    Surrey
    British49487790001
    CONLON, Denis
    Woodstock Westmore Road
    Tatsfield
    TN16 2BJ Westerham
    Kent
    Director
    Woodstock Westmore Road
    Tatsfield
    TN16 2BJ Westerham
    Kent
    British8471710001
    CUNNINGHAM, Paul
    110 Chestnut Grove
    SW12 8JJ London
    Director
    110 Chestnut Grove
    SW12 8JJ London
    British17122880004
    DE CARLE, John Brian
    Folly Hill Cottage
    Friezley Lane
    TN17 2LL Cranbrook
    Kent
    Director
    Folly Hill Cottage
    Friezley Lane
    TN17 2LL Cranbrook
    Kent
    British8317060001
    DOWNING, Brian George Kirby
    35 Badingham Drive
    Fetcham
    KT22 9EU Leatherhead
    Surrey
    Director
    35 Badingham Drive
    Fetcham
    KT22 9EU Leatherhead
    Surrey
    British8426380001
    ELLINGS, Clive Bryan
    Priors Lea
    The Drive
    SL8 5RE Bourne End
    Buckinghamshire
    Director
    Priors Lea
    The Drive
    SL8 5RE Bourne End
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish66808150001
    ELTON, Graham Clive
    Palmers Farm
    Hawkenbury Road
    TN3 9AD Tunbridge Wells
    Kent
    Director
    Palmers Farm
    Hawkenbury Road
    TN3 9AD Tunbridge Wells
    Kent
    EnglandBritish40436370002
    ELTON, Graham Clive
    Palmers Farm
    Hawkenbury Road
    TN3 9AD Tunbridge Wells
    Kent
    Director
    Palmers Farm
    Hawkenbury Road
    TN3 9AD Tunbridge Wells
    Kent
    EnglandBritish40436370002
    FERGUSON, Ailsa Murray
    18 Hosack Road
    SW17 7QP London
    Director
    18 Hosack Road
    SW17 7QP London
    British69565050001
    FOSTER, Maurice Curtis
    White House Farm
    Ivy Hatch
    TN15 0NN Sevenoaks
    Kent
    Director
    White House Farm
    Ivy Hatch
    TN15 0NN Sevenoaks
    Kent
    British8173280001
    FREEMAN, Marshall William
    PO BOX 645
    94528 Diablo
    California
    Usa
    Director
    PO BOX 645
    94528 Diablo
    California
    Usa
    American11882820001
    GRAY, Bernard Peter
    Apartment 35 Blk B
    3rd Floor 10 Wild Street
    WC2B 4RL London
    Director
    Apartment 35 Blk B
    3rd Floor 10 Wild Street
    WC2B 4RL London
    British108397670001
    JAKES, Clifford Duncan
    Littlehay
    Burley
    BH24 4AG Ringwood
    Hampshire
    Director
    Littlehay
    Burley
    BH24 4AG Ringwood
    Hampshire
    British8426370001
    KING, Harold Leslie
    17 Wildcroft Manor
    Wildcroft Road
    SW15 3TS London
    Director
    17 Wildcroft Manor
    Wildcroft Road
    SW15 3TS London
    British14996700001
    LEVY, Rupert James
    25 Muswell Avenue
    N10 2EB London
    Director
    25 Muswell Avenue
    N10 2EB London
    British57681630002
    LLOYD, Julian Stuart
    6 Queens Gate Villas
    Victoria Park Road
    E9 7BU London
    Director
    6 Queens Gate Villas
    Victoria Park Road
    E9 7BU London
    British59624160002
    LOMAX, Diana
    17 Parsons Green Lane
    SW6 4HL London
    Director
    17 Parsons Green Lane
    SW6 4HL London
    British49719540003
    MCALEENAN, Patrick David
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6UR London
    78
    Director
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6UR London
    78
    EnglandBritish14226510001
    MELVILLE, Iain Boyd
    34 Waterlow Road
    RH2 7EX Reigate
    Surrey
    Director
    34 Waterlow Road
    RH2 7EX Reigate
    Surrey
    British34669410002
    MICHAEL, Roger Lucas
    22 Greenways
    WD5 0EU Abbots Langley
    Hertfordshire
    Director
    22 Greenways
    WD5 0EU Abbots Langley
    Hertfordshire
    United KingdomBritish99335210001
    NAUGHTON, Shane Paul
    41 Neville House
    19 Page Street, Westminster
    SW1P 4JX London
    Director
    41 Neville House
    19 Page Street, Westminster
    SW1P 4JX London
    Irish124972750001
    NUGEE, Andrew
    47 Breer Street
    SW6 3HE London
    Director
    47 Breer Street
    SW6 3HE London
    British78161450001
    NUGEE, Andrew
    47 Breer Street
    SW6 3HE London
    Director
    47 Breer Street
    SW6 3HE London
    British78161450001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de CMPI HOLDINGS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Blackfriars Road
    SE1 8BF London
    240
    England
    30 jun 2016
    Blackfriars Road
    SE1 8BF London
    240
    England
    No
    Forma jurídicaUnlimited Company
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro152298
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene CMPI HOLDINGS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Mortgage
    Creado el 06 feb 1984
    Entregado el 16 feb 1984
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this charge & a charge dated 31-10-1983.
    Breve descripción
    All monies standing to the credit of the amount & all interest of the company therein both present & future at lloyds bank PLC designated "morgan-grampian PLC" re-"the far pavilions" and numbered 0933717.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 16 feb 1984Registro de una carga
    Charge
    Creado el 31 oct 1983
    Entregado el 30 nov 1983
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter dated 26-10-83 or under the terms of the charge
    Breve descripción
    Agreement, rights, and the benefit of the guarantee see doc for details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 30 nov 1983Registro de una carga
    Facility letter
    Creado el 26 oct 1983
    Entregado el 03 nov 1983
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the chargee dated 31-10/83
    Breve descripción
    Fixed charge over all monies then or thereafter standing to the credit of account designated "morgan-grampian PLC" re "the far pavilions" (see doc M209).
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 03 nov 1983Registro de una carga
    Omnibus letter of set-off
    Creado el 30 jun 1982
    Entregado el 08 jul 1982
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Breve descripción
    All sums standing to the credit of any account of the company with the bank.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 08 jul 1982Registro de una carga
    Omnibus letter of set-off
    Creado el 26 feb 1982
    Entregado el 05 mar 1982
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee
    Breve descripción
    All sums standing to the credit of the company with the bank.
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC
    Transacciones
    • 05 mar 1982Registro de una carga
    Charge
    Creado el 10 ago 1978
    Entregado el 10 ago 1982
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee s under the terms of a guarantee dated 10TH august 1982
    Breve descripción
    All book debts and other debts present and future.
    Personas con derecho
    • European American Banking Corporation
    Transacciones
    • 10 ago 1982Registro de una carga
    Legal mortgage
    Creado el 02 ago 1971
    Entregado el 03 ago 1971
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    28/31, essex st. City of westminster and vaults beneath essex st.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personas con derecho
    • Coutts & Co.
    Transacciones
    • 03 ago 1971Registro de una carga
    • 27 ago 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 27 jun 1969
    Entregado el 07 jul 1969
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    36, 37, 39 essex st & 2, 3, devereux court - 248596 together with machinery & fixtures, & floating charge on implements (see doc 106 for further details).
    Personas con derecho
    • Coutts & Co.
    Transacciones
    • 07 jul 1969Registro de una carga
    • 27 ago 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0