VICTOR PRODUCTS HOLDINGS LTD

VICTOR PRODUCTS HOLDINGS LTD

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Declaraciones de personas con control significativo
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaVICTOR PRODUCTS HOLDINGS LTD
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00241316
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenesNo
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de VICTOR PRODUCTS HOLDINGS LTD?

    • Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra VICTOR PRODUCTS HOLDINGS LTD?

    Dirección de la sede social
    Unit 3a C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side
    Port Of Tyne
    NE33 5SQ South Shields
    Tyne And Wear
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de VICTOR PRODUCTS HOLDINGS LTD?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    VICTOR PRODUCTS LTD04 nov 198204 nov 1982
    VICTOR PRODUCTS (WALLSEND) P.L.C26 jul 192926 jul 1929

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de VICTOR PRODUCTS HOLDINGS LTD?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 dic 2025
    Próximas cuentas vencen el30 sept 2026
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2024

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para VICTOR PRODUCTS HOLDINGS LTD?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta11 sept 2026
    Próxima declaración de confirmación vence25 sept 2026
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta11 sept 2025
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para VICTOR PRODUCTS HOLDINGS LTD?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2024

    23 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 11 sept 2025 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Declaración de confirmación presentada el 16 mar 2025 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2023

    22 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 16 mar 2024 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2022

    20 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 16 mar 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Jose Maria Paso Luna como director el 03 nov 2022

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2021

    23 páginasAA

    Cese del nombramiento de Ian Hudson como director el 15 jul 2022

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Jose Maria Paso Luna como director el 20 may 2022

    2 páginasAP01

    Cambio de datos del director Ms Diane I B el 20 may 2022

    2 páginasCH01

    Cese del nombramiento de Daniel Anthony Dupre como director el 20 may 2022

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Ms Diane I B como director el 20 may 2022

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 16 mar 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2020

    21 páginasAA

    Cese del nombramiento de Svetlana Vinokur como director el 12 may 2021

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 16 mar 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2019

    20 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 16 mar 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2018

    18 páginasAA

    Retrait d'une déclaration relative à une personne disposant d'un contrôle significatif le 22 ago 2019

    2 páginasPSC09

    Declaración de confirmación presentada el 16 mar 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2017

    21 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 16 mar 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    ¿Quiénes son los directivos de VICTOR PRODUCTS HOLDINGS LTD?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BONINA, Diane I
    C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side
    Port Of Tyne
    NE33 5SQ South Shields
    Unit 3a
    Tyne And Wear
    England
    Director
    C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side
    Port Of Tyne
    NE33 5SQ South Shields
    Unit 3a
    Tyne And Wear
    England
    United StatesAmerican296142390002
    SHERMAN, Jennifer Lynn
    C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side
    Port Of Tyne
    NE33 5SQ South Shields
    Unit 3a
    Tyne And Wear
    England
    Director
    C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side
    Port Of Tyne
    NE33 5SQ South Shields
    Unit 3a
    Tyne And Wear
    England
    United StatesAmerican123997580001
    CLAY, David Nicholas
    37 Larkhill Lane
    Formby
    L37 1LT Liverpool
    Merseyside
    Secretario
    37 Larkhill Lane
    Formby
    L37 1LT Liverpool
    Merseyside
    British45215990001
    DIXON, John
    6 Shawbrow Close
    Dalesford Green
    NE7 7GW Newcastle Upon Tyne
    Secretario
    6 Shawbrow Close
    Dalesford Green
    NE7 7GW Newcastle Upon Tyne
    British64250670002
    GRAY, Basil Leslie
    12 Cliffe Lane
    Hathersage
    S30 1DE Sheffield
    South Yorkshire
    Secretario
    12 Cliffe Lane
    Hathersage
    S30 1DE Sheffield
    South Yorkshire
    British7952490001
    JORDAN, Margaret Elizabeth
    63 Harington Green
    L37 1PN Formby
    Merseyside
    Secretario
    63 Harington Green
    L37 1PN Formby
    Merseyside
    British47125150001
    MARSH, Anthony Richard
    197 Melton Road
    NG12 4BU Nottingham
    Nottinghamshire
    Secretario
    197 Melton Road
    NG12 4BU Nottingham
    Nottinghamshire
    Irish34189400002
    MARSH, Anthony Richard
    25 King Edward Road
    NE6 5RE Newcastle Upon Tyne
    Secretario
    25 King Edward Road
    NE6 5RE Newcastle Upon Tyne
    Irish34189400001
    NICHOLSON, Clive
    Dene Holme
    Lucy Street
    NE21 5PU Blaydon
    Tyne & Wear
    Secretario
    Dene Holme
    Lucy Street
    NE21 5PU Blaydon
    Tyne & Wear
    British38845730003
    TURNER, Stephen Paul
    C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side
    Port Of Tyne
    NE33 5SQ South Shields
    Unit 3a
    Tyne And Wear
    England
    Secretario
    C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side
    Port Of Tyne
    NE33 5SQ South Shields
    Unit 3a
    Tyne And Wear
    England
    British109249450003
    WARREN, John Emmerson
    1 Gellesfield Chare
    Whickham
    NE16 5TQ Newcastle Upon Tyne
    Secretario
    1 Gellesfield Chare
    Whickham
    NE16 5TQ Newcastle Upon Tyne
    British796200001
    ALLAN, Gerard
    2 Glastonbury Close
    Priors Green
    DL16 6XP Spennymoor
    Durham
    Director
    2 Glastonbury Close
    Priors Green
    DL16 6XP Spennymoor
    Durham
    British44566730001
    BAKER, John Roger
    162 Runnymede Road
    Ponteland
    NE20 9HR Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Director
    162 Runnymede Road
    Ponteland
    NE20 9HR Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    EnglandBritish3728650001
    BOETTGER, Bryan Louis
    New York Way
    New York Industrial Park
    NE27 0QF Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Director
    New York Way
    New York Industrial Park
    NE27 0QF Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    UsaAmerican180458050001
    COCKSEDGE, Brian
    3 Northumberland Terrace
    NE30 4BA Tynemouth
    Tyne And Wear
    Director
    3 Northumberland Terrace
    NE30 4BA Tynemouth
    Tyne And Wear
    EnglandBritish93483600001
    CONE, Harry Douglas
    5 The Orchard
    Hepscott
    NE61 6HT Morpeth
    Northumberland
    Director
    5 The Orchard
    Hepscott
    NE61 6HT Morpeth
    Northumberland
    British796210001
    COOPER, Brian Scott
    C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side
    Port Of Tyne
    NE33 5SQ South Shields
    Unit 3a
    Tyne And Wear
    England
    Director
    C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side
    Port Of Tyne
    NE33 5SQ South Shields
    Unit 3a
    Tyne And Wear
    England
    UsaAmerican180458130001
    DELEONARDIS, John Anthony
    New York Way
    New York Industrial Park
    NE27 0QF Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Director
    New York Way
    New York Industrial Park
    NE27 0QF Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    UsaAmerican178526230001
    DIXON, John
    6 Shawbrow Close
    Dalesford Green
    NE7 7GW Newcastle Upon Tyne
    Director
    6 Shawbrow Close
    Dalesford Green
    NE7 7GW Newcastle Upon Tyne
    British64250670002
    DOLAN, Sean
    New York Way
    New York Industrial Park
    NE27 0QF Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Director
    New York Way
    New York Industrial Park
    NE27 0QF Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    UsaAmerican179483520001
    DOLATOWSKI, Ronald Edward
    New York Way
    New York Industrial Park
    NE27 0QF Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Director
    New York Way
    New York Industrial Park
    NE27 0QF Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    UsaAmerican180458180001
    DUPRE, Daniel Anthony
    C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side
    Port Of Tyne
    NE33 5SQ South Shields
    Unit 3a
    Tyne And Wear
    England
    Director
    C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side
    Port Of Tyne
    NE33 5SQ South Shields
    Unit 3a
    Tyne And Wear
    England
    United StatesAmerican186758990001
    GUILE, Peter Richard
    516 Durham Drive
    Frankfort
    Il 60423
    Usa
    Director
    516 Durham Drive
    Frankfort
    Il 60423
    Usa
    British56096610002
    HANKINS, Michael Freeman
    Flat 2 Guisnes Court
    Chapel Road Tolleshunt Darcy
    CM9 8TL Maldon
    Essex
    Director
    Flat 2 Guisnes Court
    Chapel Road Tolleshunt Darcy
    CM9 8TL Maldon
    Essex
    British12578790001
    HEARNE, John Thomas
    16947 Pineview Drive
    Lockport
    Illinois 60441
    Usa
    Director
    16947 Pineview Drive
    Lockport
    Illinois 60441
    Usa
    Usa Citizen70629260001
    HETHERINGTON, Guy
    New York Way
    New York Industrial Park
    NE27 0QF Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Director
    New York Way
    New York Industrial Park
    NE27 0QF Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish109820740003
    HUDSON, Ian
    C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side
    Port Of Tyne
    NE33 5SQ South Shields
    Unit 3a
    Tyne And Wear
    England
    Director
    C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side
    Port Of Tyne
    NE33 5SQ South Shields
    Unit 3a
    Tyne And Wear
    England
    United StatesBritish236029260001
    JACKSON, Hugh Graham
    41 Eastern Way
    Ponteland
    NE20 9RD Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Director
    41 Eastern Way
    Ponteland
    NE20 9RD Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British8699390001
    JORDAN, Keith Stuart
    63 Harington Green
    Formby
    L37 1PN Liverpool
    Silverdale
    Director
    63 Harington Green
    Formby
    L37 1PN Liverpool
    Silverdale
    EnglandBritish139201050001
    LESTER, Alan Mark Denis
    94 Western Way
    NE20 9LY Ponteland
    Tyne & Wear
    Director
    94 Western Way
    NE20 9LY Ponteland
    Tyne & Wear
    British109249350001
    MARSH, Anthony Richard
    25 King Edward Road
    NE6 5RE Newcastle Upon Tyne
    Director
    25 King Edward Road
    NE6 5RE Newcastle Upon Tyne
    Irish34189400001
    MARSH, Anthony Richard
    197 Melton Road
    NG12 4BU Nottingham
    Nottinghamshire
    Director
    197 Melton Road
    NG12 4BU Nottingham
    Nottinghamshire
    Irish34189400002
    NICHOLSON, Clive
    Dene Holme
    Lucy Street
    NE21 5PU Blaydon
    Tyne & Wear
    Director
    Dene Holme
    Lucy Street
    NE21 5PU Blaydon
    Tyne & Wear
    British38845730003
    PASO LUNA, Jose Maria
    C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side
    Port Of Tyne
    NE33 5SQ South Shields
    Unit 3a
    Tyne And Wear
    England
    Director
    C/O Victor Products Ltd, Tyne Dock East Side
    Port Of Tyne
    NE33 5SQ South Shields
    Unit 3a
    Tyne And Wear
    England
    SpainSpanish296143250001
    PICKERING, James Gordon
    Silverhill House
    270a Ecclesall Road South
    S11 9PS Sheffield
    South Yorkshire
    Director
    Silverhill House
    270a Ecclesall Road South
    S11 9PS Sheffield
    South Yorkshire
    British37974600001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de VICTOR PRODUCTS HOLDINGS LTD?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Federal Signal Uk Holdings Limited
    Tyne Dock East Side
    Port Of Tyne
    NE33 5SQ South Shields
    Unit 3a
    Tyne And Wear
    England
    06 abr 2016
    Tyne Dock East Side
    Port Of Tyne
    NE33 5SQ South Shields
    Unit 3a
    Tyne And Wear
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House, Cardiff
    Número de registro02855390
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para VICTOR PRODUCTS HOLDINGS LTD?

    Declaraciones de personas con control significativo
    Notificado elCesado elDeclaración
    16 mar 201722 ago 2019La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que existe una persona registrable en relación con la empresa, pero no la ha identificado.

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0