FULLER SMITH & TURNER PLC

FULLER SMITH & TURNER PLC

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Declaraciones de personas con control significativo
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaFULLER SMITH & TURNER PLC
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad anónima cotizada
    Número de empresa 00241882
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenesNo
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de FULLER SMITH & TURNER PLC?

    • Hoteles y alojamientos similares (55100) / Actividades de alojamiento y de servicios de comida
    • Pubs y bares (56302) / Actividades de alojamiento y de servicios de comida

    ¿Dónde se encuentra FULLER SMITH & TURNER PLC?

    Dirección de la sede social
    Pier House 86-93 Strand On The Green
    W4 3NN London
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de FULLER SMITH & TURNER PLC?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 mar 2026
    Próximas cuentas vencen el30 sept 2026
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta29 mar 2025

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para FULLER SMITH & TURNER PLC?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta05 sept 2026
    Próxima declaración de confirmación vence19 sept 2026
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta05 sept 2025
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para FULLER SMITH & TURNER PLC?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Compra de acciones propias. Acciones compradas para tesorería:

    • Capital: GBP 1,899,357.76
    4 páginasSH03
    Anotaciones
    FechaAnotación
    27 abr 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate Stamp Duty has been paid for this transaction.

    Compra de acciones propias. Acciones compradas para tesorería:

    • Capital: GBP 1,913,633.36
    4 páginasSH03
    Anotaciones
    FechaAnotación
    27 abr 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate Stamp Duty has been paid for this transaction.

    Compra de acciones propias. Acciones compradas para tesorería:

    • Capital: GBP 1,942,524.56
    4 páginasSH03
    Anotaciones
    FechaAnotación
    27 abr 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate Stamp Duty has been paid for this transaction.

    Compra de acciones propias. Acciones compradas para tesorería:

    • Capital: GBP 1,875,357.76
    4 páginasSH03
    Anotaciones
    FechaAnotación
    15 abr 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase

    Compra de acciones propias. Acciones compradas para tesorería:

    • Capital: GBP 1,849,480.16
    4 páginasSH03
    Anotaciones
    FechaAnotación
    10 abr 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this transaction.

    Compra de acciones propias. Acciones compradas para tesorería:

    • Capital: GBP 1,785,206.96
    4 páginasSH03
    Anotaciones
    FechaAnotación
    17 mar 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase

    Compra de acciones propias. Acciones compradas para tesorería:

    • Capital: GBP 1,800,906.96
    4 páginasSH03
    Anotaciones
    FechaAnotación
    17 mar 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase

    Compra de acciones propias. Acciones compradas para tesorería:

    • Capital: GBP 1,819,480.16
    4 páginasSH03
    Anotaciones
    FechaAnotación
    17 mar 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase

    Compra de acciones propias. Acciones compradas para tesorería:

    • Capital: GBP 1,782,345.36
    4 páginasSH03
    Anotaciones
    FechaAnotación
    28 feb 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase.

    Compra de acciones propias. Acciones compradas para tesorería:

    • Capital: GBP 1,796,319.76
    4 páginasSH03
    Anotaciones
    FechaAnotación
    28 feb 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase.

    Venta o transferencia de acciones de tesorería. Capital de tesorería:

    • Capital: GBP 1,778,353.36
    2 páginasSH04

    Compra de acciones propias. Acciones compradas para tesorería:

    • Capital: GBP 1,764,553.76
    4 páginasSH03

    Compra de acciones propias. Acciones compradas para tesorería:

    • Capital: GBP 1,753,324.56
    4 páginasSH03
    Anotaciones
    FechaAnotación
    10 feb 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this transaction.

    Compra de acciones propias. Acciones compradas para tesorería:

    • Capital: GBP 1,742,984.96
    4 páginasSH03

    Compra de acciones propias. Acciones compradas para tesorería:

    • Capital: GBP 1,723,065.36
    4 páginasSH03
    Anotaciones
    FechaAnotación
    03 feb 2026Clarification HMRC CONFIRMATION RECEIVED THAT APPRORIATE DUTY THAT HAS BEEN PAID ON THIS TRANSACTION

    Compra de acciones propias. Acciones compradas para tesorería:

    • Capital: GBP 1,738,171.76
    4 páginasSH03
    Anotaciones
    FechaAnotación
    03 feb 2026Clarification HMRC CONFIRMATION RECEIVED THAT APPRORIATE DUTY THAT HAS BEEN PAID ON THIS TRANSACTION

    Compra de acciones propias. Acciones compradas para tesorería:

    • Capital: GBP 1,715,386.96
    4 páginasSH03
    Anotaciones
    FechaAnotación
    20 ene 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase.

    Compra de acciones propias. Acciones compradas para tesorería:

    • Capital: GBP 1,690,707.36
    4 páginasSH03
    Anotaciones
    FechaAnotación
    16 ene 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase

    Compra de acciones propias. Acciones compradas para tesorería:

    • Capital: GBP 1,659,537.76
    4 páginasSH03
    Anotaciones
    FechaAnotación
    06 ene 2026Clarification HMRC confirmation received that appropriate Stamp Duty has been paid on this transaction.

    Compra de acciones propias. Acciones compradas para tesorería:

    • Capital: GBP 1,638,475.36
    4 páginasSH03
    Anotaciones
    FechaAnotación
    05 ene 2026Clarification HMRC - CONFIRMATION RECEIVED THAT APPROPRIATE DUTY THAT HAS BEEN PAID ON THIS TRANSACTION.

    Compra de acciones propias. Acciones compradas para tesorería:

    • Capital: GBP 1,623,644.16
    4 páginasSH03
    Anotaciones
    FechaAnotación
    19 dic 2025Clarification HMRC - CONFIRMATION RECEIVED THAT APPRORIATE DUTY THAT HAS BEEN PAID ON THIS TRANSACTION

    Compra de acciones propias. Acciones compradas para tesorería:

    • Capital: GBP 1,611,588.96
    4 páginasSH03
    Anotaciones
    FechaAnotación
    15 dic 2025Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase.

    legacy

    páginasANNOTATION

    legacy

    páginasANNOTATION

    Compra de acciones propias. Acciones compradas para tesorería:

    • Capital: GBP 1,571,978.56
    4 páginasSH03

    ¿Quiénes son los directivos de FULLER SMITH & TURNER PLC?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    SPENCER, Rachel Louise
    Strand On The Green
    W4 3NN London
    Pier House 86-93
    England
    Secretario
    Strand On The Green
    W4 3NN London
    Pier House 86-93
    England
    278119370001
    BEDNALL, Jane
    Strand On The Green
    W4 3NN London
    Pier House 86-93
    England
    Director
    Strand On The Green
    W4 3NN London
    Pier House 86-93
    England
    EnglandBritish208043180001
    BROWNE, Dawn
    Strand On The Green
    W4 3NN London
    Pier House 86-93
    England
    Director
    Strand On The Green
    W4 3NN London
    Pier House 86-93
    England
    EnglandBritish160796420002
    EMENY, Simon
    Strand On The Green
    W4 3NN London
    Pier House 86-93
    England
    Director
    Strand On The Green
    W4 3NN London
    Pier House 86-93
    England
    EnglandBritish58723360004
    FULLER, James Henry Fleetwood, Sir
    Strand On The Green
    W4 3NN London
    Pier House 86-93
    England
    Director
    Strand On The Green
    W4 3NN London
    Pier House 86-93
    England
    EnglandBritish100627670001
    FULLER, Richard Hamilton Fleetwood
    Strand On The Green
    W4 3NN London
    Pier House 86-93
    England
    Director
    Strand On The Green
    W4 3NN London
    Pier House 86-93
    England
    EnglandBritish86770710001
    ROWLAND, Robin James Leslie
    Strand On The Green
    W4 3NN London
    Pier House 86-93
    England
    Director
    Strand On The Green
    W4 3NN London
    Pier House 86-93
    England
    EnglandBritish268456450001
    SMITH, Neil Reynolds
    Strand On The Green
    W4 3NN London
    Pier House 86-93
    England
    Director
    Strand On The Green
    W4 3NN London
    Pier House 86-93
    England
    EnglandBritish269740830001
    STACEY, Juliette Natasha
    Strand On The Green
    W4 3NN London
    Pier House 86-93
    England
    Director
    Strand On The Green
    W4 3NN London
    Pier House 86-93
    England
    EnglandBritish61362920003
    TURNER, Frederick James Mortimer
    Strand On The Green
    W4 3NN London
    Pier House 86-93
    England
    Director
    Strand On The Green
    W4 3NN London
    Pier House 86-93
    England
    EnglandBritish260110390001
    BEQUIN, Severine Pascale
    Griffin Brewery
    Chiswick Lane South
    W4 2QB Chiswick
    London
    Secretario
    Griffin Brewery
    Chiswick Lane South
    W4 2QB Chiswick
    London
    189815440002
    CLARKE, Paul Anthony
    Little Warren
    Seven Hills Road
    KT11 1ER Cobham
    Surrey
    Secretario
    Little Warren
    Seven Hills Road
    KT11 1ER Cobham
    Surrey
    British2032670002
    CLARKE, Paul Anthony
    Little Warren
    Seven Hills Road
    KT11 1ER Cobham
    Surrey
    Secretario
    Little Warren
    Seven Hills Road
    KT11 1ER Cobham
    Surrey
    British2032670002
    CLARKE, Paul Anthony
    Little Warren
    Seven Hills Road
    KT11 1ER Cobham
    Surrey
    Secretario
    Little Warren
    Seven Hills Road
    KT11 1ER Cobham
    Surrey
    British2032670002
    FRANCIS, Philip George
    1 Montolieu Gardens
    Putney
    SW15 6PB London
    Secretario
    1 Montolieu Gardens
    Putney
    SW15 6PB London
    British13823260001
    GRACIE, Marie Louise
    Griffin Brewery
    Chiswick Lane South
    W4 2QB Chiswick
    London
    Secretario
    Griffin Brewery
    Chiswick Lane South
    W4 2QB Chiswick
    London
    British59472240002
    O'BRIEN, Anthony Louis
    Copper Einde Carters Lane
    Kelvedon Road Little Braxsted
    CM8 3LF Witham
    Essex
    Secretario
    Copper Einde Carters Lane
    Kelvedon Road Little Braxsted
    CM8 3LF Witham
    Essex
    British31325590002
    TURNER, Robert Ian
    Weston Mark
    Upton Grey
    RG25 2RJ Basingstoke
    Hampshire
    Secretario
    Weston Mark
    Upton Grey
    RG25 2RJ Basingstoke
    Hampshire
    British18000050001
    ATKINSON, Nigel John Bewley
    Griffin Brewery
    Chiswick Lane South
    W4 2QB Chiswick
    London
    Director
    Griffin Brewery
    Chiswick Lane South
    W4 2QB Chiswick
    London
    EnglandBritish21496910002
    AUGAR, Philip John
    26 Chaucer Road
    CB2 2EB Cambridge
    Cambridgeshire
    Director
    26 Chaucer Road
    CB2 2EB Cambridge
    Cambridgeshire
    EnglandBritish188386600001
    BRAY, Ian David
    Griffin Brewery
    Chiswick Lane South
    W4 2QB Chiswick
    London
    Director
    Griffin Brewery
    Chiswick Lane South
    W4 2QB Chiswick
    London
    EnglandBritish165359490002
    CLARKE, Paul Anthony
    Little Warren
    Seven Hills Road
    KT11 1ER Cobham
    Surrey
    Director
    Little Warren
    Seven Hills Road
    KT11 1ER Cobham
    Surrey
    U.K.British2032670002
    COUNCELL, Adam Thomas
    86-93 Strand On The Green
    W4 3NN London
    Pier House
    England
    Director
    86-93 Strand On The Green
    W4 3NN London
    Pier House
    England
    EnglandBritish148675630002
    DODD, Simon Ray
    Griffin Brewery
    Chiswick Lane South
    W4 2QB Chiswick
    London
    Director
    Griffin Brewery
    Chiswick Lane South
    W4 2QB Chiswick
    London
    EnglandBritish211419750001
    DOUGLAS, James Charles Robert
    Griffin Brewery
    Chiswick Lane South
    W4 2QB Chiswick
    London
    Director
    Griffin Brewery
    Chiswick Lane South
    W4 2QB Chiswick
    London
    EnglandBritish111723620001
    DRURY, Reginald Hugh
    Halls Farm
    Farley Hill
    RG7 1UJ Swallowfield
    Berkshire
    Director
    Halls Farm
    Farley Hill
    RG7 1UJ Swallowfield
    Berkshire
    British18414910002
    DUNSMORE, John Michael
    Griffin Brewery
    Chiswick Lane South
    W4 2QB Chiswick
    London
    Director
    Griffin Brewery
    Chiswick Lane South
    W4 2QB Chiswick
    London
    ScotlandBritish34568410008
    ESPEY, James Stuart
    17 Somerset Road
    Wimbledon
    SW19 5JZ London
    Director
    17 Somerset Road
    Wimbledon
    SW19 5JZ London
    EnglandBritish805990001
    FERNIE, William Mackinnson
    Manor Farm
    Tellisford
    BA2 7RL Bath
    Avon
    Director
    Manor Farm
    Tellisford
    BA2 7RL Bath
    Avon
    British109742810001
    FORDHAM, Lynn Rosanne
    Griffin Brewery
    Chiswick Lane South
    W4 2QB Chiswick
    London
    Director
    Griffin Brewery
    Chiswick Lane South
    W4 2QB Chiswick
    London
    EnglandBritish74999430001
    FULLER, Anthony Gerard Fleetwood
    Griffin Brewery
    Chiswick Lane South
    W4 2QB Chiswick
    London
    Director
    Griffin Brewery
    Chiswick Lane South
    W4 2QB Chiswick
    London
    United KingdomBritish7895840001
    FULLER, John William Fleetwood, Major Sir
    Neston Park
    SN13 9TG Corsham
    Wiltshire
    Director
    Neston Park
    SN13 9TG Corsham
    Wiltshire
    British30751170001
    JONES, Helen Victoria
    Strand On The Green
    W4 3NN London
    Pier House 86-93
    England
    Director
    Strand On The Green
    W4 3NN London
    Pier House 86-93
    England
    EnglandBritish93034430002
    KERR, Alastair Gibson
    Griffin Brewery
    Chiswick Lane South
    W4 2QB Chiswick
    London
    Director
    Griffin Brewery
    Chiswick Lane South
    W4 2QB Chiswick
    London
    EnglandBritish124295480004
    MACANDREW, Nicholas Rupert
    Griffin Brewery
    Chiswick Lane South
    W4 2QB Chiswick
    London
    Director
    Griffin Brewery
    Chiswick Lane South
    W4 2QB Chiswick
    London
    United KingdomBritish7971710001

    ¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para FULLER SMITH & TURNER PLC?

    Declaraciones de personas con control significativo
    Notificado elCesado elDeclaración
    16 nov 201816 nov 2018La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa.

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0