WILSON CONNOLLY LIMITED

WILSON CONNOLLY LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaWILSON CONNOLLY LIMITED
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00244804
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de WILSON CONNOLLY LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra WILSON CONNOLLY LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Gate House
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Buckinghamshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de WILSON CONNOLLY LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    WILCON HOMES LIMITED31 dic 197731 dic 1977
    WILCON CONSTRUCTION LIMITED02 ene 193002 ene 1930

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de WILSON CONNOLLY LIMITED?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 dic 2024
    Próximas cuentas vencen el30 sept 2025
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2023

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para WILSON CONNOLLY LIMITED?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta03 abr 2025
    Próxima declaración de confirmación vence17 abr 2025
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta03 abr 2024
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para WILSON CONNOLLY LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Cese del nombramiento de Michael Andrew Lonnon como secretario el 09 dic 2024

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Mr Sayed Suleiman Ashrafi como secretario el 09 dic 2024

    2 páginasAP03

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2023

    11 páginasAA

    Cese del nombramiento de Omolola Olutomilayo Adedoyin como director el 24 abr 2024

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Jennifer Canty como director el 24 abr 2024

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 03 abr 2024 con actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mrs Omolola Olutomilayo Adedoyin como director el 09 oct 2023

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Katherine Elizabeth Hindmarsh como director el 09 oct 2023

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2022

    12 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 03 abr 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2021

    13 páginasAA

    Parte del bien o empresa ha sido liberada y ya no forma parte de la carga 55

    2 páginasMR05

    Declaración de confirmación presentada el 03 abr 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2020

    15 páginasAA

    Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada Highdown House Yeoman Way Worthing West Sussex BN99 3HH

    1 páginasAD03

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado de Elder House St Georges Business Park 207 Brooklands Road Weybridge Surrey KT13 0TS United Kingdom a Highdown House Yeoman Way Worthing West Sussex BN99 3HH

    1 páginasAD02

    Declaración de confirmación presentada el 03 abr 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2019

    19 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 03 abr 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Colin Richard Clapham como director el 31 oct 2019

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Miss Katherine Elizabeth Hindmarsh como director el 31 oct 2019

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Ian Graham Connor como director el 25 oct 2019

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Sarah Judith Thornley como director el 25 oct 2019

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2018

    20 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 20 abr 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    ¿Quiénes son los directivos de WILSON CONNOLLY LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    ASHRAFI, Sayed Suleiman
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Secretario
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    330347940001
    CANTY, Jennifer
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    Director
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishCompany Secretary322288120001
    CONNOR, Ian Graham
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Director
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director193626080001
    HASTINGS, Jonathan Philip
    7 Hanger Court
    Hanger Green
    W5 3ER London
    Secretario
    7 Hanger Court
    Hanger Green
    W5 3ER London
    British4733610001
    LAWTHER, Samuel David
    Stow Cottage
    Spaldwick Road, Stow Longa
    PE18 0TL Huntingdon
    Cambridgeshire
    Secretario
    Stow Cottage
    Spaldwick Road, Stow Longa
    PE18 0TL Huntingdon
    Cambridgeshire
    British41835460012
    LONNON, Michael Andrew, Mr.
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Secretario
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    British34521340004
    NUNN, Carol Jayne
    4 Juniper Close
    NN12 6XP Towcester
    Northamptonshire
    Secretario
    4 Juniper Close
    NN12 6XP Towcester
    Northamptonshire
    British116824870001
    STOTE, Tanya
    Honeyburge
    The Fordrough
    B90 1PP Solihull
    West Midlands
    Secretario
    Honeyburge
    The Fordrough
    B90 1PP Solihull
    West Midlands
    British113603590001
    ADEDOYIN, Omolola Olutomilayo
    Turnpike Road
    HP12 3 NR High Wycombe
    Gate House
    Bucks
    United Kingdom
    Director
    Turnpike Road
    HP12 3 NR High Wycombe
    Gate House
    Bucks
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director193735640001
    ANDREW, Peter Robert
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Director
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritishRegional Managing Director113503830003
    BANNISTER, William Henry
    28 Riverside Road
    West Moors
    BH22 0LQ Ferndown
    Dorset
    Director
    28 Riverside Road
    West Moors
    BH22 0LQ Ferndown
    Dorset
    United KingdomBritishDirector58990140003
    BEAL, Ian Paul
    Meadowbank
    10 Stagswood
    BH31 6PX Verwood
    Dorset
    Director
    Meadowbank
    10 Stagswood
    BH31 6PX Verwood
    Dorset
    BritishDirector71260780003
    BELL, Darren
    5 Brookway
    Wrea Green
    PR4 2NU Preston
    Director
    5 Brookway
    Wrea Green
    PR4 2NU Preston
    United KingdomBritishManaging Director73256080001
    BENSON, Deborah Clare
    30 Wardie Square
    EH5 1EU Edinburgh
    Lothian
    Director
    30 Wardie Square
    EH5 1EU Edinburgh
    Lothian
    BritishManaging Director52845300004
    BLACK, Ian Craig
    7 The Courtyard
    Ecton Hall
    NN6 0QE Ecton
    Northamptonshire
    Director
    7 The Courtyard
    Ecton Hall
    NN6 0QE Ecton
    Northamptonshire
    BritishChartered Accountant4579780003
    BROOMFIELD, Matthew
    3 Link Drive
    Brampton
    PE28 4FE Huntingdon
    Cambridgeshire
    Director
    3 Link Drive
    Brampton
    PE28 4FE Huntingdon
    Cambridgeshire
    BritishDirector80131820001
    BURGESS, Alan Robert
    1 Pinetops
    Forest Road
    RH12 4HU Horsham
    West Sussex
    Director
    1 Pinetops
    Forest Road
    RH12 4HU Horsham
    West Sussex
    EnglandBritishCompany Director79587600001
    CARNEY, Christopher
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Director
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director125216670001
    CHANDRAN, Vikranth
    Carlton Avenue East
    Wembley
    HA9 8QB London
    227
    United Kingdom
    Director
    Carlton Avenue East
    Wembley
    HA9 8QB London
    227
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant139652640001
    CLAPHAM, Colin Richard
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Director
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Secretary9684390001
    COKER, John Edwin
    Brambly Hedge 3 Somersall Willows
    S40 3SR Chesterfield
    Derbyshire
    Director
    Brambly Hedge 3 Somersall Willows
    S40 3SR Chesterfield
    Derbyshire
    EnglandBritishCompany Director100513680001
    DICKERSON, Graham Leslie
    St Aubuns
    Cricketfield Lane
    CM23 2SR Bishops Stortford
    Herts
    Director
    St Aubuns
    Cricketfield Lane
    CM23 2SR Bishops Stortford
    Herts
    EnglandBritishManaging Director127266390001
    EDGINGTON, Richard Alan
    Ashleigh
    Main Road Great Haywood
    ST18 0SU Stafford
    Director
    Ashleigh
    Main Road Great Haywood
    ST18 0SU Stafford
    EnglandBritishManaging Director81884240001
    FAULKNER, Jeffrey Dean
    1 The Cherries
    Euxton
    PR7 6NG Chorley
    Lancashire
    Director
    1 The Cherries
    Euxton
    PR7 6NG Chorley
    Lancashire
    BritishDirector77563410003
    FLOOD, Robert William
    Cloisters Road
    Winterbourne
    BS33 1QP Bristol
    Brinksworth Leaze
    Director
    Cloisters Road
    Winterbourne
    BS33 1QP Bristol
    Brinksworth Leaze
    EnglandBritishManaging Director134877050001
    FOULKES, Christopher Andrew
    76 Muirhill
    Limpley Stoke
    BA2 7FB Bath
    Avon
    Director
    76 Muirhill
    Limpley Stoke
    BA2 7FB Bath
    Avon
    United KingdomBritishNone33941280001
    FRAQUELLI, Lorenzo Giuseppe
    17 Derwent Road
    AL5 3PA Harpenden
    Hertfordshire
    Director
    17 Derwent Road
    AL5 3PA Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritishManaging Director48396030001
    GREEN, Robert David
    11 Whitworth Lane
    Loughton
    MK5 8EB Milton Keynes
    Director
    11 Whitworth Lane
    Loughton
    MK5 8EB Milton Keynes
    EnglandBritishDirector76720550003
    GREENING, Malcolm David
    181 Burley Lane
    Quarndon
    DE22 5JS Derby
    Derbyshire
    Director
    181 Burley Lane
    Quarndon
    DE22 5JS Derby
    Derbyshire
    BritishCompany Director58648450001
    GRIFFITHS, Melvyn Robert
    Bethal House Pytchley Court
    Crown Lane
    NN6 7AL West Haddon
    Northamptonshire
    Director
    Bethal House Pytchley Court
    Crown Lane
    NN6 7AL West Haddon
    Northamptonshire
    United KingdomBritishDirector113395580001
    HATCH, Christopher John
    19 Welwyn Hall Gardens
    AL6 9LF Welwyn
    Hertfordshire
    Director
    19 Welwyn Hall Gardens
    AL6 9LF Welwyn
    Hertfordshire
    BritishCompany Director50577850006
    HINDMARSH, Katherine Elizabeth
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Director
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Secretary257671040002
    HOLLAND-KAYE, William John
    39 Britannia Road
    SW6 2HJ London
    Director
    39 Britannia Road
    SW6 2HJ London
    BritishManaging Director110518040001
    JOHNSON, Peter Thomas
    34 Homewood Road
    AL1 4BQ St Albans
    Hertfordshire
    Director
    34 Homewood Road
    AL1 4BQ St Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritishAccountant8895880004
    KENRICK, Joanne Louise
    Flat 9
    53 Rosslyn Hill Hampstead
    NW3 5UH London
    Director
    Flat 9
    53 Rosslyn Hill Hampstead
    NW3 5UH London
    BritishDirector75636150002

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de WILSON CONNOLLY LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    06 abr 2016
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro832629
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene WILSON CONNOLLY LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Legal charge
    Creado el 03 jul 2009
    Entregado el 16 jul 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each guarantor or borrower or chargor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Eldohouse farm being on the south side of mount road, bury st edmunds part t/no SK82666. Eldohouse farm being on the south side of mount road, bury st edmunds part t/no SK82666. 34 turnpike road, red lodge, freckenahm part t/no SK80912. Insurances and other contracts see image for full details.
    Personas con derecho
    • Wilmington Trust (London) Limited (the Security Agent) as Agent and Trustee for the Secured Creditors
    Transacciones
    • 16 jul 2009Registro de un cargo (395)
    • 01 jul 2010Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad gravada ha sido liberada (MG04)
    • 01 jul 2010Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad gravada ha sido liberada (MG04)
    • 04 feb 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Legal charge
    Creado el 27 oct 2003
    Entregado el 30 oct 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £3,308,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    The freehold land situated at upton rocks widnes chesire.
    Personas con derecho
    • The Council of the Borough of Halton
    Transacciones
    • 30 oct 2003Registro de un cargo (395)
    • 11 oct 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of charge
    Creado el 24 oct 2003
    Entregado el 30 oct 2003
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    £2,450,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The freehold land and premises known as part of nunnery fields hospital nunnery fields canterbury kent.
    Personas con derecho
    • East Kent Hospitals National Health Service Trust
    Transacciones
    • 30 oct 2003Registro de un cargo (395)
    Legal mortgage
    Creado el 21 oct 2003
    Entregado el 28 oct 2003
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The whole of the l/h land being 146 orrell road, orrell t/no GM607707.
    Personas con derecho
    • Steven John Burness and Rita Ann Burness
    Transacciones
    • 28 oct 2003Registro de un cargo (395)
    Legal charge
    Creado el 30 sept 2003
    Entregado el 11 oct 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Land at wychwood village, crewe, cheshire,.
    Personas con derecho
    • Countryside Properties PLC
    Transacciones
    • 11 oct 2003Registro de un cargo (395)
    • 08 dic 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 06 ago 2003
    Entregado el 13 ago 2003
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All that f/h property situate and k/a coryton house 27 pendwyallt road coryton cardiff.
    Personas con derecho
    • Royal Mail Group PLC
    Transacciones
    • 13 ago 2003Registro de un cargo (395)
    Legal charge
    Creado el 07 jul 2003
    Entregado el 09 jul 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £5,908,750.00 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    All that f/h property situate at manor farm crescent off brook way bradley stoke south glos containing approx 7.6 acres.
    Personas con derecho
    • South Gloucestershire District Council
    Transacciones
    • 09 jul 2003Registro de un cargo (395)
    • 23 jun 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 20 jun 2003
    Entregado el 24 jun 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The freehold land known as and forming part of woodlands memorial ground blackpool road ansdell lytham st annes.
    Personas con derecho
    • Fylde Rugby Union Football Club Limited
    Transacciones
    • 24 jun 2003Registro de un cargo (395)
    • 17 jul 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 02 may 2003
    Entregado el 03 may 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £3,429,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Land on the east side of southend road hornchurch essex.
    Personas con derecho
    • Maylands Green Estate Co Limited & Romford Construction Company Limited
    Transacciones
    • 03 may 2003Registro de un cargo (395)
    • 04 feb 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 28 abr 2003
    Entregado el 10 may 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £1,897,500 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Land comprising old stowupland park stowmarket suffolk.
    Personas con derecho
    • Crest Nicholson Residential (Eastern) Limited
    Transacciones
    • 10 may 2003Registro de un cargo (395)
    • 04 feb 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 28 abr 2003
    Entregado el 03 may 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £1,897,500 due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Land comprising old stowupland park, stowmarket, suffolk.
    Personas con derecho
    • Crest Nicholson Residential (Eastern) Limited
    Transacciones
    • 03 may 2003Registro de un cargo (395)
    • 04 feb 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 25 abr 2003
    Entregado el 29 abr 2003
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Scholes park farm and scholes lodge farm scholes leeds west yorkshire.
    Personas con derecho
    • Scholes Park Developments Limited
    Transacciones
    • 29 abr 2003Registro de un cargo (395)
    • 27 jul 2022Parte del bien o empresa ha sido liberada y ya no forma parte de la carga (MR05)
    Legal charge
    Creado el 23 abr 2003
    Entregado el 01 may 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    The sum of £2,400,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    F/H property k/a the woodlands park hotel wellington road timperley cheshire t/no: GM171621.
    Personas con derecho
    • Brian Norris Walker
    Transacciones
    • 01 may 2003Registro de un cargo (395)
    • 27 may 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 01 abr 2003
    Entregado el 16 abr 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All that freehold property under t/n's CH423380 and CH423391 and the rights interest and estate in the land described in the statutory declarations of david stone and derek nuttall dated 25 march 2003. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Northwich Victoria Football Club Company Limited
    Transacciones
    • 16 abr 2003Registro de un cargo (395)
    • 18 may 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 01 abr 2003
    Entregado el 16 abr 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the northwich victoria football club company limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All that freehold property known as or being the football stadium and land at the drill field northwich cheshire. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 16 abr 2003Registro de un cargo (395)
    • 04 ago 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 26 mar 2003
    Entregado el 09 abr 2003
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All the land at medway trading estate hart street maidstone kent t/no K583305.
    Personas con derecho
    • Bernard Christopher Norman Roger Holmes
    Transacciones
    • 09 abr 2003Registro de un cargo (395)
    Legal charge
    Creado el 26 mar 2003
    Entregado el 29 mar 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    One million six hundred thousand pounds (£1,600,000) due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Land on the south east side of hart street, maidstone, kent t/n K583305.
    Personas con derecho
    • Cathedral Medway Limited
    Transacciones
    • 29 mar 2003Registro de un cargo (395)
    • 11 oct 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 20 dic 2002
    Entregado el 06 ene 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £21,660,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Land at orsett hospital rowley road basildon essex.
    Personas con derecho
    • Basildon and Thurrock General Hospitals National Health Service Trust
    Transacciones
    • 06 ene 2003Registro de un cargo (395)
    • 04 feb 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 04 oct 2002
    Entregado el 08 oct 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £750,000 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Land to the rear of tidings hill halstead essex.
    Personas con derecho
    • G E Cook & Sons Limited
    Transacciones
    • 08 oct 2002Registro de un cargo (395)
    • 11 oct 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 30 ago 2002
    Entregado el 31 ago 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The property k/a land to the south of clay lane, fishbourne, nr chichester, west sussex t/no. WSX257370.
    Personas con derecho
    • Seaward Homes (South) Limited
    Transacciones
    • 31 ago 2002Registro de un cargo (395)
    • 04 feb 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 28 jun 2002
    Entregado el 18 jul 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Land at county way, trowbridge, wiltshire.
    Personas con derecho
    • Swan Hill Developments Limited
    Transacciones
    • 18 jul 2002Registro de un cargo (395)
    • 26 mar 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 16 may 2002
    Entregado el 22 may 2002
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Land at lee mill,ivybridge,devon.
    Personas con derecho
    • Peter Joseph Cane and William John Cane
    Transacciones
    • 22 may 2002Registro de un cargo (395)
    Legal charge
    Creado el 18 abr 2002
    Entregado el 02 may 2002
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    F/H land lying to the south of codicote road, wheathampstead, hertfordshire. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Sainsbury's Supermarkets Limited
    Transacciones
    • 02 may 2002Registro de un cargo (395)
    Legal charge
    Creado el 21 mar 2002
    Entregado el 26 mar 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Land and buildings on the north east side of carver street, birmingham, forming part of the land t/n WM467585.
    Personas con derecho
    • Midland and City Limited, Baystone Associates Limited, and Lampol Developments Limited Togethertrading as Ppk Partnership
    Transacciones
    • 26 mar 2002Registro de un cargo (395)
    • 04 feb 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal mortgage
    Creado el 21 dic 2001
    Entregado el 04 ene 2002
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All that freehold land lying to the south of codicote road wheathampstead hertfordshire.
    Personas con derecho
    • Sainsburys Supermarkets Limited
    Transacciones
    • 04 ene 2002Registro de un cargo (395)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0