IBSTOCK BRICKS (1996) LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | IBSTOCK BRICKS (1996) LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 00246855 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de IBSTOCK BRICKS (1996) LIMITED?
- Actividades de otras sociedades holding n.c.o.p. (64209) / Actividades financieras y de seguros
¿Dónde se encuentra IBSTOCK BRICKS (1996) LIMITED?
| Dirección de la sede social | Leicester Road Ibstock LE67 6HS Leicestershire |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de IBSTOCK BRICKS (1996) LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| IBSTOCK BRICKS LIMITED | 01 ago 1996 | 01 ago 1996 |
| REDLAND BRICKS LIMITED | 07 abr 1986 | 07 abr 1986 |
| BIRTLEY BRICK COMPANY LIMITED(THE) | 27 mar 1930 | 27 mar 1930 |
| BIRTLEY BRICK COMPANY LIMITED(THE) | 27 mar 1930 | 27 mar 1930 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de IBSTOCK BRICKS (1996) LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para IBSTOCK BRICKS (1996) LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 30 may 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 13 jun 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 30 may 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para IBSTOCK BRICKS (1996) LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Cancelación total de la carga 002468550002 | 1 páginas | MR04 | ||
Cese del nombramiento de Christopher Mark Mcleish como director el 10 oct 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2024 | 16 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 30 may 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Modification des détails de Ibstock Plc en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 14 oct 2024 | 2 páginas | PSC05 | ||
Nombramiento de Mr Nicholas David Martin Giles como secretario el 31 jul 2024 | 2 páginas | AP03 | ||
Cese del nombramiento de Rebecca Anne Parker como secretario el 31 jul 2024 | 1 páginas | TM02 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2023 | 16 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 30 may 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2022 | 1 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mr Joseph Henry Hudson como director el 07 jul 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 30 may 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mrs Rebecca Anne Parker como secretario el 27 ene 2023 | 2 páginas | AP03 | ||
Cese del nombramiento de Nicholas David Martin Giles como secretario el 27 ene 2023 | 1 páginas | TM02 | ||
Cambio de datos del director Mr Chris Mark Mcleish el 23 jun 2022 | 2 páginas | CH01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 30 may 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2021 | 2 páginas | AA | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2020 | 1 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 30 may 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2019 | 2 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 30 may 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Ian Alan Tichias como director el 29 feb 2020 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr Nicholas David Martin Giles como secretario el 08 nov 2019 | 2 páginas | AP03 | ||
Cese del nombramiento de Robert Douglas como secretario el 08 nov 2019 | 1 páginas | TM02 | ||
Cese del nombramiento de Kevin John Sims como director el 31 ago 2019 | 1 páginas | TM01 | ||
¿Quiénes son los directivos de IBSTOCK BRICKS (1996) LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GILES, Nicholas David Martin | Secretario | Ibstock LE67 6HS Leicestershire Leicester Road United Kingdom | 325659540001 | |||||||
| HUDSON, Joseph Henry | Director | Leicester Road Ibstock LE67 6HS Leicestershire | United Kingdom | British | 261706070001 | |||||
| DOUGLAS, Robert | Secretario | Leicester Road Ibstock LE67 6HS Leicestershire | 207824070001 | |||||||
| GILES, Nicholas David Martin | Secretario | Leicester Road Ibstock LE67 6HS Leicestershire | 264499400001 | |||||||
| HARDY, Stephen Philip | Secretario | Leicester Road Ibstock LE67 6HS Leicestershire | British | 1726320003 | ||||||
| KHALFEY, Shamshad | Secretario | Leicester Road Ibstock LE67 6HS Leicestershire | 198382580001 | |||||||
| PARKER, Rebecca Anne | Secretario | Leicester Road LE67 6HS Ibstock Ibstock Plc Leicestershire United Kingdom | 304791640001 | |||||||
| PIKE, Andrew Stephen | Secretario | Whitebeam House 1 Greaves Close CV34 6LU Warwick | British | 65678800001 | ||||||
| TAYLOR, Anthony John | Secretario | 70 Macaulay Road LE17 4XB Lutterworth Leicestershire | British | 10999890001 | ||||||
| REDLAND SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | Redland House RH2 0SJ Reigate Surrey | 9859690001 | |||||||
| ADAMSON, Euan John Alistair | Director | Grove House 2 Grove Road Sonning Common RG4 9RL Reading Berkshire | British | 12490050001 | ||||||
| ASPDEN, Peter Graham | Director | 15 Blackthorn Close LE17 4UX Lutterworth Leicestershire | British | 78527750001 | ||||||
| AUSTIN, Allan | Director | Leicester Road Ibstock LE67 6HS Leicestershire | England | British | 132696210002 | |||||
| BULL, Geoffrey Ronald | Director | 8 Highfields Close LE65 2FN Ashby De La Zouch Leicestershire | England | British | 87875720001 | |||||
| CHELLEW, Mark Peter | Director | Holly Cottage Mill Lane Blakenhall Nantwich Cheshire | Australian | 38666380001 | ||||||
| CLAMP, Martyn Stuart | Director | 15 Churchill Close LE65 2LR Ashby De La Zouch Leicestershire | England | British | 1726330001 | |||||
| CORBETT, Gerald Michael Nolan | Director | Holtsmere End Lane Redbourn AL3 7AW St. Albans Holtsmere End Farm Hertfordshire | England | British | 139519980001 | |||||
| FLEMING, Ian James | Director | Holtye Croft Cansiron Lane Cowden TN8 7EE Edenbridge Kent | United Kingdom | British | 10457080001 | |||||
| FLEMING, Ian James | Director | Holtye Croft Cansiron Lane Cowden TN8 7EE Edenbridge Kent | United Kingdom | British | 10457080001 | |||||
| FOWLES, Andrew Timothy | Director | The Old Post Office Adderley TF9 3TD Market Drayton Shropshire | British | 40862750001 | ||||||
| GILLESPIE, Graham Richard William | Director | Park Farm House Peakes End Steppingley MK45 5AY Bedford Bedfordshire | British | 38639780003 | ||||||
| JOHNSON, Brian Clark | Director | Abbotslea Langhurstwood Road RH12 4QL Horsham West Sussex | British | 28066700001 | ||||||
| JOHNSON, Peter Michael | Director | The Lydd Top Road, Sharpthorne RH19 4NS East Grinstead West Sussex | United Kingdom | British | 66565420001 | |||||
| MACLELLAN, Ian David | Director | Wormleighton Grange CV47 2XZ Southam Warwickshire | United Kingdom | British | 33693580001 | |||||
| MCLEISH, Christopher Mark | Director | Leicester Road Ibstock LE67 6HS Leicestershire | England | British | 261406410002 | |||||
| MEMMOTT, Clive Allan James | Director | 14 Ford Lane Allestree DE22 2EW Derby Derbyshire | United Kingdom | British | 45467910001 | |||||
| MENGEL, Phillip Richard | Director | 23 Muirfield Drive PA 19607 Reading Usa | American | 51016560001 | ||||||
| MILHAM, John Edward | Director | The Dower House 39 Main Street Market Bosworth CV13 0JN Nuneaton Warwickshire | British | 1767830001 | ||||||
| MORTON, Keith Frederick Ronald | Director | Leicester Road Ibstock LE67 6HS Leicestershire | England | British | 146567400001 | |||||
| NAPIER, Robert Stewart | Director | Baynards Manor RH12 3AD Rudgwick West Sussex | United Kingdom | British | 10964720001 | |||||
| PIKE, Andrew Stephen | Director | Whitebeam House 1 Greaves Close CV34 6LU Warwick | British | 65678800001 | ||||||
| RICHARDS, John | Director | Leicester Road Ibstock LE67 6HS Leicestershire | England | British | 49304880003 | |||||
| ROBERTS, Neal Anthony | Director | 14 Bullington End Road Castlethorpe MK19 7ER Milton Keynes Buckinghamshire | British | 12470210001 | ||||||
| ROBERTS, Neal Anthony | Director | 68 Tudor Hill B73 6BE Sutton Coldfield West Midlands | British | 12470210002 | ||||||
| SIMS, Kevin John | Director | Leicester Road Ibstock LE67 6HS Leicestershire | England | British | 13863340005 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de IBSTOCK BRICKS (1996) LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibstock Plc | 06 abr 2016 | LE67 6HS Ibstock Leicester Road Leicestershire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0