CROMWELL LAND INVESTMENTS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | CROMWELL LAND INVESTMENTS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 00267455 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de CROMWELL LAND INVESTMENTS LIMITED?
- Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra CROMWELL LAND INVESTMENTS LIMITED?
| Dirección de la sede social | 8 Canada Square E14 5HQ London United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CROMWELL LAND INVESTMENTS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| PEUREULA INVESTMENTS LIMITED | 03 ago 1932 | 03 ago 1932 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de CROMWELL LAND INVESTMENTS LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2011 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para CROMWELL LAND INVESTMENTS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Hollie Rheanna Wood como secretario el 24 jul 2013 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||||||
Nombramiento de Katherine Dean como secretario el 24 jul 2013 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||||||
Estado de capital el 17 jun 2013
| 4 páginas | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cese del nombramiento de Karen Lyon como secretario el 04 abr 2013 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||||||
Nombramiento de Hollie Rheanna Wood como secretario el 04 abr 2013 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 12 ene 2013 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2011 | 24 páginas | AA | ||||||||||||||
Los registros se han trasladado a la dirección del domicilio social registrado | 2 páginas | AD04 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Richard John Cole como director el 31 may 2012 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Andrew David John Moffat como director el 31 may 2012 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 2 Jubilee Place London SW3 3TQ el 11 jun 2012 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 12 ene 2012 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Jonathan Peter Marlow como director el 30 nov 2011 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Laurence Edwin Hayes como director el 30 nov 2011 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cambio de datos del secretario Karen Lyon el 02 ago 2011 | 2 páginas | CH03 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Edward Glover como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2010 | 15 páginas | AA | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Sarah Gledhill como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Sharon Kerridge como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de CROMWELL LAND INVESTMENTS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEAN, Katherine | Secretario | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | 180088270001 | |||||||
| COLE, Richard John | Director | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 32663530001 | |||||
| MARLOW, Jonathan Peter | Director | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 159417990001 | |||||
| BANDEL, Martin Howard | Secretario | Gable End 29 Christchurch Crescent WD7 8AQ Radlett Hertfordshire | British | 37249220002 | ||||||
| BLACK, Nicola Suzanne | Secretario | Springfield 24 Drovers Way CM23 4GF Bishops Stortford Hertfordshire | British | 52160130002 | ||||||
| COLE, Jennifer | Secretario | Flat 2 The Earl Of Devon 213 Devons Road Bow Common E3 3QX London | British | 74489480002 | ||||||
| FORSTER, Helen | Secretario | Flat 4 5 Corkran Road KT6 6PL Surbiton Surrey | British | 106129360001 | ||||||
| JENKINSON, Louisa Jane | Secretario | 12 Amberley Close Send GU23 7BX Woking Surrey | British | 106060330002 | ||||||
| LYON, Karen | Secretario | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | Other | 140536930001 | ||||||
| MILLER, Philip | Secretario | 87 Sutton Court Fauconberg Road W4 3JF London | British | 121053850001 | ||||||
| NIVEN, Frances Julie | Secretario | 73 Celestial Gardens SE13 5RU London | British | 78670270001 | ||||||
| POOLE, Rebecca Louise | Secretario | 69b Replingham Road Southfields SW18 5LU Wimbledon | British | 92013940001 | ||||||
| STUART-SMITH, Gordon | Secretario | Summerview Chequers Park Wye TN25 5BA Ashford Kent | British | 5463920001 | ||||||
| WOOD, Hollie Rheanna | Secretario | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | 177184380001 | |||||||
| PATERNOSTER SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | 55 Basinghall Street EC2V 5HD London | 76827740001 | |||||||
| ALLPORT, Howard Coplestone | Director | 20 Fernshaw Road SW10 0TE London | British | 3356770001 | ||||||
| ASHKEN, Karol Maksymilian | Director | 60 Chapel Road KT20 5SE Tadworth Surrey | British | 6684100002 | ||||||
| BANDEL, Martin Howard | Director | Gable End 29 Christchurch Crescent WD7 8AQ Radlett Hertfordshire | England | British | 37249220002 | |||||
| DE ALBUQUERQUE, Simon Peter | Director | 15 Fielding Mews Barnes SW13 9EY London | England | British | 150525130001 | |||||
| EDWARDS, Dylan Crocker | Director | 22 Greenway Gardens UB6 9TT Greenford Middlesex | British | 5965630001 | ||||||
| GLEDHILL, Sarah Louise | Director | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 131963100002 | |||||
| GLOVER, Edward Douglas | Director | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 121380002 | |||||
| HAYES, Laurence Edwin | Director | Jubilee Place SW3 3TQ London 2 England | United Kingdom | British | 192784770001 | |||||
| HOLBROOK, Carolyn | Director | 5 Croftside CO8 5LL Bures St Mary Suffolk | United Kingdom | British | 165098780001 | |||||
| KERRIDGE, Sharon Diana Mandy | Director | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 128267610003 | |||||
| MOFFAT, Andrew David John | Director | Jubilee Place SW3 3TQ London 2 England | England | British | 34399870003 | |||||
| RAWLINS, Richard Denis | Director | 183 Ramsden Road SW12 8RG London | United Kingdom | British | 56889050001 | |||||
| STUART-SMITH, Gordon | Director | Summerview Chequers Park Wye TN25 5BA Ashford Kent | British | 5463920001 | ||||||
| SZPIRO, Toby Nicholas Maximilian | Director | Flat 3 18 Camden Hill Gardens W8 7AY London | United Kingdom | British | 76573230001 | |||||
| THORP, Timothy Geoffrey | Director | 3 St George's Road TN13 3ND Sevenoaks Kent | England | British | 66923730003 | |||||
| VON GUIONNEAU, Werner Marc Friedrich | Director | 33 Lansdowne Road W11 2LQ London | England | German, | 110089200001 |
¿Tiene CROMWELL LAND INVESTMENTS LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creado el 16 jul 1996 Entregado el 31 jul 1996 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Composite debenture | Creado el 27 sept 1990 Entregado el 05 oct 1990 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of a guarantee of even date | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 30 mar 1983 Entregado el 07 abr 1983 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción F/H land at 1 branksea street and works adjoining fulham fixed and. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Deposit of deeds without instrument. | Creado el 22 dic 1977 Entregado el 05 ene 1978 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción 30, somerville road, small heath, birmingham. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Sub-charge | Creado el 23 nov 1977 Entregado el 09 dic 1977 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción The debt of £7,221,009.42 that the co. Shall not be at liberty to create any mortgage or charge (see doc M115). | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 27 abr 1977 Entregado el 10 may 1977 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción 74, davey rd, handswoth birmingham 20. together with all fixtures etc. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 27 abr 1977 Entregado el 10 may 1977 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción 108 & 126 alvechurch road west heath, birmingham 31 together with all fixtures etc. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 08 dic 1976 Entregado el 09 dic 1976 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción All those properties briefly described in the schedule (attached to doc 111) tog. With all fixtures whatsoever.(see doc.111 For further details) . | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 20 sept 1974 Entregado el 04 oct 1974 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción A floating charge on the (see doc 101 for details). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0