WEST LONDON LEASEHOLDS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | WEST LONDON LEASEHOLDS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 00279600 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de WEST LONDON LEASEHOLDS LIMITED?
- (7011) /
¿Dónde se encuentra WEST LONDON LEASEHOLDS LIMITED?
| Dirección de la sede social | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de WEST LONDON LEASEHOLDS LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2009 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para WEST LONDON LEASEHOLDS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Lucinda Bell como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Timothy Roberts como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Anthony Braine como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Estado de capital el 15 abr 2010
| 4 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Anthony Braine como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Sarah Barzycki como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Peter Clarke como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de un director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de un director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Nigel Webb como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Graham Roberts como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Ndiana Ekpo el 01 oct 2009 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 31 dic 2009 avec liste complète des actionnaires | 8 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2009 | 18 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Andrew Jones como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 288a | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 288b | ||||||||||
legacy | 6 páginas | 363a | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2008 | 18 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 288b | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de WEST LONDON LEASEHOLDS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKPO, Ndiana | Secretario | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | Other | 138446320001 | ||||||
| FORSHAW, Christopher Michael John | Director | 44 Kerris Way Lower Earley RG6 5UW Reading Berkshire | England | British | 1898090001 | |||||
| CLARKE, Peter Courtenay | Secretario | Langkawi 2 Ashlea Road SL9 8NY Chalfont St Peter Buckinghamshire | British | 78691990001 | ||||||
| SCUDAMORE, Rebecca Jane | Secretario | 40 Canbury Avenue KT2 6JP Kingston Upon Thames Surrey | Other | 72249480003 | ||||||
| BARZYCKI, Sarah Morrell | Director | Sandown Road KT10 9TT Esher 27 Surrey | United Kingdom | British | 58016770004 | |||||
| BELL, Lucinda Margaret | Director | 6 Priory Gardens Chiswick W4 1TT London | England | British | 32809050004 | |||||
| BERRY, David Charles | Director | Portland Dene Valley Way SL9 7PN Gerrards Cross Buckinghamshire | British | 166550001 | ||||||
| BOWDEN, Robert Edward | Director | The Chase Ongar Road CM15 0DG Kelvedon Hatch Essex | United Kingdom | British | 152497530001 | |||||
| BRAINE, Anthony | Director | 21 Woodville Road Ealing W5 2SE London | United Kingdom | British | 32809000002 | |||||
| CLARKE, Peter Courtenay | Director | Oakmeade Park Road SL2 4PG Stoke Poges Berkshire | United Kingdom | British | 78691990003 | |||||
| GUNSTON, Michael Ian | Director | Larchmont Hambledon Road, Denmead PO7 6HB Waterlooville Hampshire | United Kingdom | British | 3079890002 | |||||
| HESTER, Stephen Alan Michael | Director | 3 Ilchester Place W14 8AA London | British | 51688320001 | ||||||
| JONES, Andrew Marc | Director | Hazlewell Road Putney SW15 6LH London 2 | England | British | 82020730004 | |||||
| KALMAN, Stephen Lionel | Director | 81 Eastbury Road HA6 3AP Northwood Middlesex | England | British | 1188110001 | |||||
| METLISS, Cyril | Director | 25 Foscote Road Hendon NW4 3SE London | British | 3079600001 | ||||||
| RITBLAT, Nicholas Simon Jonathan | Director | 37 Queens Grove NW8 6HN London | United Kingdom | British | 35758050004 | |||||
| ROBERTS, Graham Charles | Director | 6a Lower Belgrave Street SW1W 0LJ London | England | British | 79807180002 | |||||
| ROBERTS, Timothy Andrew | Director | Lorne House Oxshott Way KT11 2RU Cobham Surrey | United Kingdom | British | 63986410003 | |||||
| RUTHERFORD, John Beach | Director | 19 The Ridings Blatchington Green BN25 3HW Seaford East Sussex | British | 32816480001 | ||||||
| WEBB, Nigel Mark | Director | Beech Lodge 53 Crouch Hall Lane Redbourn AL3 7EU St Albans Hertfordshire | England | British | 58059360001 | |||||
| WESTON SMITH, John Harry | Director | 10 Eldon Grove Hampstead NW3 5PT London | England | British | 13547380001 | |||||
| WILSON, Alan James | Director | 30 Broxbourne Road BR6 0AY Orpington Kent | England | British | 3078220001 |
¿Tiene WEST LONDON LEASEHOLDS LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of substitution & charge | Creado el 04 mar 1988 Adquirido el 05 may 1988 Entregado el 24 may 1988 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £5,000,000 | |
Breve descripción Vale lodge 1, vale avenue tunbridge wells, kent title no k 188903. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Deed of subsitution & charge | Creado el 16 nov 1987 Adquirido el 27 ene 1989 Entregado el 09 feb 1989 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £5,000,000 | |
Breve descripción 1) 14, 16, 20, 22 & 24 adelaide street & 74 bank hey street blackpool, lancashire titel no. La 513555 2) 26 & 28 adelaide street blackpool, lancashire title no la 513554. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 01 oct 1986 Entregado el 20 oct 1986 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or the british land company PLC under the terms of the facility letter dated 27 may 1986 to the chargee | |
Breve descripción 8, 9 and 10 cornwall terrace regents park, london NW1. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal mortgage | Creado el 21 nov 1977 Entregado el 24 nov 1977 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción L/H property known as:- 7 faraday close, holywell industrial estate rickmansworth hertfordshire title no:- hd 60746. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Deed of variation amending a legal mortgage | Creado el 07 jul 1977 Entregado el 19 jul 1977 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada Diletion of appendix to clause one of origenal charge dated 10 may 1976 | |
Breve descripción F/H property at 26, cloyhead way handsworth birmingham title no wk 87895. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal mortgage | Creado el 10 may 1976 Entregado el 11 may 1976 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada For further securing all moneys now due or to become due from the british land company LTD & the chargee on any account whatsoever nor exceeding £550,000 secured by five other charges each dated 8TH september 1975 | |
Breve descripción Property known as 26 holyhed way, birmingham. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 19 dic 1975 Entregado el 19 dic 1975 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada For further securing all monies due or to become due under the terms of a charge dated 19TH jan, 1973 and a deed of variation dated 19TH december, 1975 | |
Breve descripción Property situate at west coppice road, brownhills, staffordshire. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0