JTB REALISATIONS LIMITED

JTB REALISATIONS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaJTB REALISATIONS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00288766
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de JTB REALISATIONS LIMITED?

    • Venta al por menor de calzado en establecimientos especializados (47721) / Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas

    ¿Dónde se encuentra JTB REALISATIONS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de JTB REALISATIONS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    A. JONES & SONS LIMITED04 jun 193404 jun 1934

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de JTB REALISATIONS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2014

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para JTB REALISATIONS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Renuncia de bienes vacantes

    1 páginasBONA

    Renuncia de bienes vacantes

    1 páginasBONA

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Informe de progreso del administrador

    32 páginasAM10

    Aviso de cambio de la administración a la disolución

    32 páginasAM23

    Informe de progreso del administrador

    28 páginasAM10

    Informe de progreso del administrador

    31 páginasAM10

    Aviso de extensión del período de la administración

    3 páginasAM19

    Informe de progreso del administrador

    36 páginasAM10

    Declaración de asuntos con el formulario AM02SOA

    12 páginasAM02

    Notificación de la aprobación presunta de las propuestas

    3 páginasAM06

    Certificado de cambio de nombre

    Company name changed A. jones & sons LIMITED\certificate issued on 03/05/17
    2 páginasCERTNM
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 13 abr 2017

    RES15

    Aviso de cambio de nombre

    2 páginasCONNOT

    Declaración de la propuesta del administrador

    44 páginas2.17B

    Domicilio social registrado cambiado de Outersole House 1 Wheatfield Way Hinckley Leicestershire LE10 1YG England a 15 Canada Square London E14 5GL el 09 abr 2017

    2 páginasAD01

    Nombramiento de un administrador

    1 páginas2.12B

    Exercice comptable en cours prolongé du 31 dic 2016 au 28 feb 2017

    1 páginasAA01

    Cese del nombramiento de Simon Edward Cook como director el 27 ene 2017

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr David John Riddiford como director el 19 dic 2016

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de David Robert Short como director el 06 oct 2016

    1 páginasTM01

    Cancelación total de la carga 002887660014

    1 páginasMR04

    Registro de la carga 002887660018, creada el 22 sept 2016

    70 páginasMR01

    Domicilio social registrado cambiado de A Jones & Sons Limited Interlink Way West, Interlink Business Park Bardon Coalville Leicestershire LE67 1LD England a Outersole House 1 Wheatfield Way Hinckley Leicestershire LE10 1YG el 08 ago 2016

    1 páginasAD01

    Renuncia del auditor

    1 páginasAUD

    Renuncia del auditor

    1 páginasAUD

    ¿Quiénes son los directivos de JTB REALISATIONS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    KILLICK, Michael David
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Director
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    WalesBritishCfo75927820002
    RIDDIFORD, David John
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Director
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    EnglandBritishExecutive Chairman220918310001
    JOHNSON, David Edward
    20 Great Footway
    Langton Green
    TN3 0DT Tunbridge Wells
    Kent
    Secretario
    20 Great Footway
    Langton Green
    TN3 0DT Tunbridge Wells
    Kent
    British10571470001
    TODD, Jeremy
    West Street
    TN20 6DS Mayfield
    Knowle Way
    East Sussex
    United Kingdom
    Secretario
    West Street
    TN20 6DS Mayfield
    Knowle Way
    East Sussex
    United Kingdom
    BritishFinance Director109143970003
    WHITE, Andrew Robert
    18 Maple Road
    Eastbourne
    BN23 6NZ East Sussex
    Secretario
    18 Maple Road
    Eastbourne
    BN23 6NZ East Sussex
    British159789980001
    BARTLE, Kenneth
    Mill Hill
    Rattlesden
    IP30 0SQ Bury St Edmunds
    The Smock Mill, Hitchcocks Mill
    Suffolk
    United Kingdom
    Director
    Mill Hill
    Rattlesden
    IP30 0SQ Bury St Edmunds
    The Smock Mill, Hitchcocks Mill
    Suffolk
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector73909180007
    BARTLE, Kenneth
    The Smock Mill Hitchcocks Mill
    Mill Hill Rattlesden
    IP30 0SQ Bury St Edmunds
    Suffolk
    Director
    The Smock Mill Hitchcocks Mill
    Mill Hill Rattlesden
    IP30 0SQ Bury St Edmunds
    Suffolk
    EnglandBritishRetail Consultant73909180007
    BOOT, Terry Michael
    Interlink Way West, Interlink Business Park
    Bardon
    LE67 1LD Coalville
    A Jones & Sons Limited
    Leicestershire
    England
    Director
    Interlink Way West, Interlink Business Park
    Bardon
    LE67 1LD Coalville
    A Jones & Sons Limited
    Leicestershire
    England
    EnglandBritishCfo67041160001
    CHURCH, John George
    The Old Rectory
    Farthingstone
    NN12 8EZ Towcester
    Northamptonshire
    Director
    The Old Rectory
    Farthingstone
    NN12 8EZ Towcester
    Northamptonshire
    United KingdomBritishChartered Accountant12963560001
    CLARK, Lancelot Pease
    Apartment 142
    Archie Street
    SE1 London
    Director
    Apartment 142
    Archie Street
    SE1 London
    BritishManager28161570002
    COOK, Simon Edward
    1 Wheatfield Way
    LE10 1YG Hinckley
    Outersole House
    Leicestershire
    England
    Director
    1 Wheatfield Way
    LE10 1YG Hinckley
    Outersole House
    Leicestershire
    England
    EnglandBritishCpo104673410002
    COORENS, Eric Maria Hendrikus
    Interlink Way West,
    Interlink Business Park
    LE67 1LD Bardon, Coalville
    Macintosh Fashion Uk
    Leicestershire
    United Kingdom
    Director
    Interlink Way West,
    Interlink Business Park
    LE67 1LD Bardon, Coalville
    Macintosh Fashion Uk
    Leicestershire
    United Kingdom
    NetherlandsDutchChief Operating Officer157586370001
    CRAWSHAW, John
    2 Hyde Tynings Close
    BN20 7TQ Eastbourne
    East Sussex
    Director
    2 Hyde Tynings Close
    BN20 7TQ Eastbourne
    East Sussex
    United KingdomBritishCompany Director121560001
    DE MOOR, Frank Karel
    Interlink Way West,
    Interlink Business Park
    LE67 1LD Bardon, Coalville
    Macintosh Fashion Uk
    Leicestershire
    United Kingdom
    Director
    Interlink Way West,
    Interlink Business Park
    LE67 1LD Bardon, Coalville
    Macintosh Fashion Uk
    Leicestershire
    United Kingdom
    BelgiumBelgianChief Executive Office159745220001
    DUNCAN SMITH, Alastair David
    94 Wakehurst Road
    SW11 6BT London
    Director
    94 Wakehurst Road
    SW11 6BT London
    BritishBusiness Manager69076490001
    HUNEN, Peter Therese Antoon
    Interlink Way West,
    Interlink Business Park
    LE67 1LD Bardon, Coalville
    Macintosh Fashion Uk
    Leicestershire
    United Kingdom
    Director
    Interlink Way West,
    Interlink Business Park
    LE67 1LD Bardon, Coalville
    Macintosh Fashion Uk
    Leicestershire
    United Kingdom
    NetherlandsDutchCompany Secretary159744910001
    JELINEK, Vaclav
    2 Avenue Place, Avenue Lane
    BN21 3RB Eastbourne
    East Sussex
    Director
    2 Avenue Place, Avenue Lane
    BN21 3RB Eastbourne
    East Sussex
    BritishRetail Executive109139210002
    JOHNSON, David Edward
    20 Great Footway
    Langton Green
    TN3 0DT Tunbridge Wells
    Kent
    Director
    20 Great Footway
    Langton Green
    TN3 0DT Tunbridge Wells
    Kent
    BritishChartered Accountant10571470001
    KENNEDY, Iain Manning
    3 Townsend Close
    NN6 9HP Hanging Houghton
    Northamptonshire
    Director
    3 Townsend Close
    NN6 9HP Hanging Houghton
    Northamptonshire
    EnglandBritishCompany Director187882990001
    NOBLE, Alison Jane Bennett
    82 Gayville Road
    SW11 6JP London
    Director
    82 Gayville Road
    SW11 6JP London
    United KingdomBritishRetail Buyer103289830002
    PHILLIPS, Peter John
    Gibraltar Lane
    Cookham Dean
    SL6 9TR Maidenhead
    Gibraltar House
    Berkshire
    United Kingdom
    Director
    Gibraltar Lane
    Cookham Dean
    SL6 9TR Maidenhead
    Gibraltar House
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector51075400001
    PHILLIPS, Peter John
    St. Peter Street
    SL7 1NQ Marlow
    The Minnows
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Director
    St. Peter Street
    SL7 1NQ Marlow
    The Minnows
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    BritishCompany Director51075400002
    SHORT, David Robert
    1 Wheatfield Way
    LE10 1YG Hinckley
    Outersole House
    Leicestershire
    England
    Director
    1 Wheatfield Way
    LE10 1YG Hinckley
    Outersole House
    Leicestershire
    England
    EnglandBritishCeo38957690003
    SHORTEN, Paul William
    Kinell Windmill Green
    Stone Cross
    BN24 5DY Pevensey
    East Sussex
    Director
    Kinell Windmill Green
    Stone Cross
    BN24 5DY Pevensey
    East Sussex
    BritishCompany Director33661480001
    STRIJBOS, Theodorus Leonardus
    Interlink Way West,
    Interlink Business Park
    LE67 1LD Bardon, Coalville
    Macintosh Fashion Uk
    Leicestershire
    United Kingdom
    Director
    Interlink Way West,
    Interlink Business Park
    LE67 1LD Bardon, Coalville
    Macintosh Fashion Uk
    Leicestershire
    United Kingdom
    NetherlandsDutchChief Financial Officer157586510001
    TODD, Jeremy
    West Street
    TN20 6DS Mayfield
    Knowle Way
    East Sussex
    United Kingdom
    Director
    West Street
    TN20 6DS Mayfield
    Knowle Way
    East Sussex
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director109143970003
    WALTON JONES, Howard
    Robin Hill Tilley Lane
    Boreham Street
    BN27 4UT Hailsham
    East Sussex
    Director
    Robin Hill Tilley Lane
    Boreham Street
    BN27 4UT Hailsham
    East Sussex
    BritishCompany Director20804560001
    WATKINSON, John Dudley
    Glebe Farm
    Old Weston Road
    PE28 5AG Brington
    Cambs
    Director
    Glebe Farm
    Old Weston Road
    PE28 5AG Brington
    Cambs
    EnglandBritishDirector66949520004
    WHITE, Andrew Robert
    Highgate Drive
    Knighton
    LE2 6HJ Leicester
    31
    Leicestershire
    United Kingdom
    Director
    Highgate Drive
    Knighton
    LE2 6HJ Leicester
    31
    Leicestershire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector146324190001

    ¿Tiene JTB REALISATIONS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 22 sept 2016
    Entregado el 28 sept 2016
    Pendiente
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Alteri Europe, L.P.
    Transacciones
    • 28 sept 2016Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 15 feb 2016
    Entregado el 17 feb 2016
    Pendiente
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Alteri Europe, L.P. (The Security Agent)
    Transacciones
    • 17 feb 2016Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 26 oct 2015
    Entregado el 02 nov 2015
    Pendiente
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Alteri Europe L.P. (As Secuirty Agent)
    Transacciones
    • 02 nov 2015Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 26 oct 2015
    Entregado el 02 nov 2015
    Pendiente
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Alteri Europe, L.P. (As Security Agent)
    Transacciones
    • 02 nov 2015Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 14 nov 2014
    Entregado el 25 nov 2014
    Satisfecho en su totalidad
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Ing Bank N.V. (The "Security Agent") as Trustee for Each of the Secured Parties
    Transacciones
    • 25 nov 2014Registro de una carga (MR01)
    • 28 sept 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 14 nov 2014
    Entregado el 25 nov 2014
    Satisfecho en su totalidad
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Ing Bank N.V., Acting in Its Capacity of Security Agent (The "Secured Party" Which Expression Includes Its Successors and Assigns)
    Transacciones
    • 25 nov 2014Registro de una carga (MR01)
    • 30 oct 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 15 sept 2010
    Entregado el 18 sept 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 18 sept 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 20 may 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 09 nov 2005
    Entregado el 16 nov 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 16 nov 2005Registro de un cargo (395)
    • 12 ene 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 20 dic 2002
    Entregado el 02 ene 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 02 ene 2003Registro de un cargo (395)
    • 07 dic 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 07 mar 2002
    Entregado el 21 mar 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 21 mar 2002Registro de un cargo (395)
    • 07 dic 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 08 feb 2002
    Entregado el 23 feb 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 23 feb 2002Registro de un cargo (395)
    • 12 mar 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Supplemental mortgage to a debenture dated 22 february 2001,
    Creado el 16 ago 2001
    Entregado el 03 sept 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All present and future obligations and liabilities, whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever, of each obligor to the lender
    Breve descripción
    By way of first legal mortgage the property being all that l/h premises k/a 53 west street horsham west sussex, all that l/h premises k/a number 30-32 the promenade cheltenham gloucestershire, all that l/h premises k/a 40 high street reigate surrey RH2 9AT, all that l/h premises k/a 103-105 terminus road eastbourne east sussex, together with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures) at any time thereon.
    Personas con derecho
    • Burdale Financial Limited
    Transacciones
    • 03 sept 2001Registro de un cargo (395)
    • 24 dic 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Supplemental debenture to a debenture dated 22 february 2001 made between (amongst others) the chargor and burdale financial limited
    Creado el 10 ago 2001
    Entregado el 31 ago 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee (all terms as defined)
    Breve descripción
    By way of first fixed charge all of its right title and interest in and to the additional collection account and all monies standing to the credit of the additional collection account and the debts represented by them. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Burdale Financial Limited
    Transacciones
    • 31 ago 2001Registro de un cargo (395)
    • 24 dic 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Security agreement
    Creado el 22 feb 2001
    Entregado el 07 mar 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to or in connection with the facility agreement (all terms as defined)
    Breve descripción
    In order to provide continuing security for the payment or performance of the obligation in the agreement the obligor vested possession of the certificates of title to the collateral in the secured party (or its agent) to the intent that the secured party should have a security interest or interests in the collateral in accordance with article 2 (3) of the 1983 law but so that the secured party should not in any circumstances incur any liability or be under any obligation whatsoever in connection with the collateral. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Burdale Financial Limited
    Transacciones
    • 07 mar 2001Registro de un cargo (395)
    • 24 dic 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of debenture made between, amongst others, the company and the chargee
    Creado el 22 feb 2001
    Entregado el 07 mar 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All present and future obligations and liabilities of each obligor to the chargee (all terms as defined)
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Burdale Financial Limited
    Transacciones
    • 07 mar 2001Registro de un cargo (395)
    • 24 dic 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Floating charge
    Creado el 22 feb 2001
    Entregado el 07 mar 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies and liabilities due or to become due from the company to the chargee under the loan note instrument and in accordance with the terms of an agreement of even date
    Breve descripción
    Floating charge. Undertaking and all property and assets.
    Personas con derecho
    • Church & Co PLC
    Transacciones
    • 07 mar 2001Registro de un cargo (395)
    • 05 nov 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Standard security
    Creado el 20 abr 1995
    Entregado el 21 abr 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £20,000 due from the company to the chargee
    Breve descripción
    First floor office premises at 56 hanover street edinburgh.
    Personas con derecho
    • Scottish Amicable Life Assurance Society Limited
    Transacciones
    • 21 abr 1995Registro de un cargo (395)
    • 17 feb 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene JTB REALISATIONS LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    24 mar 2017Inicio de la administración
    05 abr 2019Fin de la administración
    En administración
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Blair Carnegie Nimmo
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    Profesional
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    William James Wright
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    Profesional
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    Stephen John Absolom
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    Profesional
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0