HEATH LAMBERT INSURANCE SERVICES LIMITED

HEATH LAMBERT INSURANCE SERVICES LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaHEATH LAMBERT INSURANCE SERVICES LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00308512
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de HEATH LAMBERT INSURANCE SERVICES LIMITED?

    • (7499) /

    ¿Dónde se encuentra HEATH LAMBERT INSURANCE SERVICES LIMITED?

    Dirección de la sede social
    133 Houndsditch
    London
    EC3A 7AH
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de HEATH LAMBERT INSURANCE SERVICES LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    HEATH INSURANCE SERVICES LIMITED30 oct 199630 oct 1996
    C E HEATH (INSURANCE SERVICES) LIMITED28 nov 199028 nov 1990
    B & C INSURANCE BROKERS (UK) LIMITED02 ago 198902 ago 1989
    B & C INSURANCE BROKERS LIMITED 01 jul 198801 jul 1988
    CAYZER STEEL BOWATER (LONDON) LIMITED13 ago 198513 ago 1985
    TENNANT BUDD LIMITED21 dic 193521 dic 1935

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de HEATH LAMBERT INSURANCE SERVICES LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2010

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para HEATH LAMBERT INSURANCE SERVICES LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Cese del nombramiento de William David Bloomer como director el 10 oct 2011

    2 páginasTM01

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2010

    5 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 31 ene 2011

    15 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital15 feb 2011

    Estado de capital el 15 feb 2011

    • Capital: GBP 8,300,000
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2009

    5 páginasAA

    Exercice comptable précédent raccourci du 31 mar 2010 au 31 dic 2009

    3 páginasAA01

    Resoluciones

    Resolutions
    29 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01

    Declaración de los objetos de la sociedad

    1 páginasCC04

    Déclaration annuelle établie au 31 ene 2010

    15 páginasAR01

    Detalles de la variación de los derechos vinculados a las acciones

    2 páginasSH10

    Nombramiento de Mr Adrian Colosso como director

    3 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Michael Bruce como director

    2 páginasTM01

    Cuentas preparadas hasta el 31 mar 2009

    5 páginasAA

    legacy

    8 páginas363a

    legacy

    1 páginas288c

    Cuentas preparadas hasta el 31 mar 2008

    6 páginasAA

    legacy

    7 páginas363s

    Cuentas preparadas hasta el 31 mar 2007

    6 páginasAA

    legacy

    8 páginas363s

    legacy

    páginas363(288)

    legacy

    páginas363(353)

    Cuentas preparadas hasta el 31 mar 2006

    7 páginasAA

    legacy

    1 páginas287

    ¿Quiénes son los directivos de HEATH LAMBERT INSURANCE SERVICES LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    HL CORPORATE SERVICES LIMITED
    133 Houndsditch
    EC3A 7AH London
    Secretario corporativo
    133 Houndsditch
    EC3A 7AH London
    43700080007
    COLOSSO, Adrian
    Burnham Road
    Woodham Mortimer
    CM9 6SP Maldon
    Hillside Farm
    Essex
    Director
    Burnham Road
    Woodham Mortimer
    CM9 6SP Maldon
    Hillside Farm
    Essex
    EnglandBritishGroup Chief Executive4555310002
    THOMAS, Robert Nigel
    South West House
    Weston Road
    BA1 2XU Bath
    Avon
    Director
    South West House
    Weston Road
    BA1 2XU Bath
    Avon
    United KindgomBritishAccountant40630840002
    SHARP, Pandora
    Flat 9 Da Vinci Court
    1 Rossetti Road
    SE16 3EA London
    Secretario
    Flat 9 Da Vinci Court
    1 Rossetti Road
    SE16 3EA London
    British64972020003
    WILKINSON, Sidney James
    67 Chessfield Park
    Little Chalfont
    HP6 6RU Amersham
    Buckinghamshire
    Secretario
    67 Chessfield Park
    Little Chalfont
    HP6 6RU Amersham
    Buckinghamshire
    British1138390001
    BAREHAM, Robert Edward
    Squirrels
    33 Bidborough Ridge
    TN4 0UT Tunbridge Wells
    Kent
    Director
    Squirrels
    33 Bidborough Ridge
    TN4 0UT Tunbridge Wells
    Kent
    United KingdomBritishChartered Accountant8522090001
    BARTLETT, Steven James
    10 Ash Meadow
    Willesborough
    TN24 0LW Ashford
    Kent
    Director
    10 Ash Meadow
    Willesborough
    TN24 0LW Ashford
    Kent
    EnglandBritishInsurance Broker47527700001
    BLOOMER, William David
    Barry Road
    East Dulwich
    SE22 0JS London
    214
    Director
    Barry Road
    East Dulwich
    SE22 0JS London
    214
    United KingdomBritishCompany Solicitor72374560002
    BRUCE, Michael Andrew
    Royston Manor St Peter's Lane
    Clayworth
    DN22 9AA Retford
    Nottinghamshire
    Director
    Royston Manor St Peter's Lane
    Clayworth
    DN22 9AA Retford
    Nottinghamshire
    United KingdomBritishGroup Managing Director61928170002
    CONSTABLE, Robert Mark
    9 Mount Road
    GU6 7LT Cranleigh
    Surrey
    Director
    9 Mount Road
    GU6 7LT Cranleigh
    Surrey
    BritishInsurance Broker115305700001
    DRUMMOND, Peter David
    Angel House
    Angel Street
    GU28 0BJ Petworth
    West Sussex
    Director
    Angel House
    Angel Street
    GU28 0BJ Petworth
    West Sussex
    BritishInsurance Broker34676460002
    GARNHAM, Jasper Meredydd
    Harewood Lodge Bulstrode Way
    SL9 7QT Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Director
    Harewood Lodge Bulstrode Way
    SL9 7QT Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    BritishInsurance Broker8522110001
    IRONMONGER, Richard Kenneth
    Briar Cottage
    Broadmore Lane
    IP25 6TE Carbrooke
    Norfolk
    Director
    Briar Cottage
    Broadmore Lane
    IP25 6TE Carbrooke
    Norfolk
    BritishInsurance Broker8852330004
    JERVIS, Ian Michael Peter
    1 Hove Park Way
    BN3 6PS Hove
    East Sussex
    Director
    1 Hove Park Way
    BN3 6PS Hove
    East Sussex
    BritishInsurance Broker77237610001
    KAUFMAN, John Banwell
    6 Scotsdale Close
    BR5 1NU Petts Wood
    Kent
    Director
    6 Scotsdale Close
    BR5 1NU Petts Wood
    Kent
    EnglandBritishInsurance Broker147388510001
    KIER, Michael Hector
    23 Belmont Road
    TW2 5DA Twickenham
    Middlesex
    Director
    23 Belmont Road
    TW2 5DA Twickenham
    Middlesex
    DanishLloyds Broker8719670001
    MANSFIELD, Diane Frances
    Barton
    Crossways Park, West Chiltington
    RH20 2QZ Pulborough
    West Sussex
    Director
    Barton
    Crossways Park, West Chiltington
    RH20 2QZ Pulborough
    West Sussex
    BritishChartered Accountant64151360001
    MARGRETT, David Basil
    60 Deansway
    Finchley
    N2 0JE London
    Director
    60 Deansway
    Finchley
    N2 0JE London
    BritishInsurance Broker313150002
    ROWE, Nicholas
    Amberly House
    The Cleave
    OX11 0EL Harwell
    Oxfordshire
    Director
    Amberly House
    The Cleave
    OX11 0EL Harwell
    Oxfordshire
    BritishCompany Secretary33862660001
    RUNCIMAN, Jeffrey Keith
    7 Pinfold Close
    Hale Barns
    WA15 0SA Altrincham
    Cheshire
    Director
    7 Pinfold Close
    Hale Barns
    WA15 0SA Altrincham
    Cheshire
    BritishInsurance Broker10020520001
    SANSOM, Richard James
    12 Birch Mead
    Locksbottom
    BR6 8LT Orpington
    Kent
    Director
    12 Birch Mead
    Locksbottom
    BR6 8LT Orpington
    Kent
    United KingdomBritishChartered Accountant105966060001
    SIMPER, Anthony
    21 Lambourn Way
    Lords Wood
    ME5 8PU Chatham
    Kent
    Director
    21 Lambourn Way
    Lords Wood
    ME5 8PU Chatham
    Kent
    BritishInsurance Broker34987510001
    SMITH, Paul David
    Applegarth
    Faygate Lane, Rusper
    RH12 4RF Horsham
    West Sussex
    Director
    Applegarth
    Faygate Lane, Rusper
    RH12 4RF Horsham
    West Sussex
    EnglandBritishInsurance Broker8522160002
    SPRINGBETT, David John
    Abbey House Huntercombe Lane South
    Taplow
    SL6 0PQ Maidenhead
    Berkshire
    Director
    Abbey House Huntercombe Lane South
    Taplow
    SL6 0PQ Maidenhead
    Berkshire
    BritishInsurance Broker12798880001
    SUMMERS, Paul John
    14 Whorlton Road
    SE15 3PD London
    Director
    14 Whorlton Road
    SE15 3PD London
    BritishInsurance Broker28330910003
    WAKELING, Julian David
    18 Lightwater Meadow
    GU18 5XH Lightwater
    Surrey
    Director
    18 Lightwater Meadow
    GU18 5XH Lightwater
    Surrey
    EnglandBritishInsurance Broker34987520001
    WARBURTON, Brian
    Great Mead Standon Green End
    High Cross
    SG11 1BP Ware
    Hertfordshire
    Director
    Great Mead Standon Green End
    High Cross
    SG11 1BP Ware
    Hertfordshire
    BritishInsurance Broker8514310001
    WILKINSON, Ian Michael Colin
    Fuggles Oast Amber Lane
    Chart Sutton
    ME17 3SF Maidstone
    Kent
    Director
    Fuggles Oast Amber Lane
    Chart Sutton
    ME17 3SF Maidstone
    Kent
    BritishInsurance Broker28330920001

    ¿Tiene HEATH LAMBERT INSURANCE SERVICES LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Guarantee & debenture
    Creado el 29 feb 2000
    Entregado el 09 mar 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to any of the secured parties (as defined) pursuant to all or any of the secured documents (as defined), including the debenture
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 09 mar 2000Registro de un cargo (395)
    • 09 ene 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of variation made in addition to and modifying the security and trust deed dated 18 september 1989 ("the principal deed") as modified by a deed of variation dated 1 november 1993 (the "first deed of variation")
    Creado el 23 sept 1999
    Entregado el 01 oct 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Breve descripción
    All monies (including brokerage) for the time being standing to the credit of or pursuant to lloyds brokers byelaw (no.5 Of 1988) (see form 395 for full details).
    Personas con derecho
    • Lloyds
    Transacciones
    • 01 oct 1999Registro de un cargo (395)
    • 13 jul 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Second guarantee and debenture
    Creado el 03 dic 1997
    Entregado el 22 dic 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the senior finance documents and the debenture as defined therein
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Security Trustee for the Beneficiaries
    Transacciones
    • 22 dic 1997Registro de un cargo (395)
    • 05 may 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of variation
    Creado el 01 nov 1993
    Entregado el 10 nov 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    For varying the terms of the security trust deed dated 18 september 1989
    Breve descripción
    All monies (including brokerage) for the time being standing to the credit of or pursuant to the byelaw required. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds
    Transacciones
    • 10 nov 1993Registro de un cargo (395)
    • 13 jul 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Assignment
    Creado el 16 may 1990
    Entregado el 31 may 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All moneys due or owing or from time to time becoming due or owing to the company under or by virtue of a sum of sterling pounds 75,000 placed on call deposit with barclays de zoete wedd on 16-5-90 under deal reference no 495002, in name of barclays bank PLC re b & c insurance brokers (UK) limited.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 31 may 1990Registro de una carga
    Security and trust deed
    Creado el 18 sept 1989
    Entregado el 23 sept 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Breve descripción
    All monies (including brokerage) for the time being standing to the credit of or pursuant to lloyds brokers byelaw (no. 5 of 1988) (see form 395 for full details).
    Personas con derecho
    • Lloyds
    Transacciones
    • 23 sept 1989Registro de una carga
    • 13 jul 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Trust deed
    Creado el 23 feb 1983
    Entregado el 04 mar 1983
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge.
    Breve descripción
    All that the company's right title and interest in the monies standing to the credit of the company's "c" account at the date of the trust deed (see doc M135 for further details).
    Personas con derecho
    • The Corporation of Lloyds
    Transacciones
    • 04 mar 1983Registro de una carga

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0