BLUE CIRCLE HOME PRODUCTS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | BLUE CIRCLE HOME PRODUCTS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 00315900 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de BLUE CIRCLE HOME PRODUCTS LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra BLUE CIRCLE HOME PRODUCTS LIMITED?
| Dirección de la sede social | Park Lodge London Road RH4 1TH Dorking Surrey United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de BLUE CIRCLE HOME PRODUCTS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| BIRMID QUALCAST PUBLIC LIMITED COMPANY | 01 jul 1936 | 01 jul 1936 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de BLUE CIRCLE HOME PRODUCTS LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2016 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para BLUE CIRCLE HOME PRODUCTS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 7 páginas | LIQ13 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Katrin Gertrude Boldt como director el 31 may 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Katrin Gertrude Boldt como director el 31 may 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 1 páginas | 600 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Oliver Trevor Marwood Templar-Coates como director el 12 ene 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de solvencia | 5 páginas | LIQ01 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 abr 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Andreas Kranz como director el 30 jun 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 abr 2016 avec liste complète des actionnaires | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nombramiento de Vice-President, Finance Oliver Trevor Marwood Templar-Coates como director el 22 feb 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Andreas Kranz el 26 feb 2016 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Nombramiento de Group Tax Manager Simon Gregory Crossley como director el 22 feb 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Howard Bruce Moller como director el 22 feb 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Richard Mark Harris como director el 22 feb 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Howard Bruce Moller el 26 oct 2015 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
Cambio de datos del director Howard Bruce Moller el 26 oct 2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Nombramiento de Katrin Boldt como director el 22 feb 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Howard Bruce Moller como director el 22 feb 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Andreas Kranz como director el 22 feb 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Regent House Station Approach Dorking Surrey RH4 1th a Park Lodge London Road Dorking Surrey RH4 1th el 29 oct 2015 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 01 abr 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de BLUE CIRCLE HOME PRODUCTS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOLLER, Howard Bruce | Secretario | London Road RH4 1TH Dorking Park Lodge Surrey United Kingdom | 182645670001 | |||||||||||
| CROSSLEY, Simon Gregory | Director | London Road RH4 1TH Dorking Park Lodge Surrey United Kingdom | England | British | 152458590002 | |||||||||
| MOLLER, Howard Bruce | Director | London Road RH4 1TH Dorking Park Lodge Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 176766970001 | |||||||||
| ELLIOTT, Raymond Alfred | Secretario | 4 Church Close Rushton NN14 1SB Kettering Northamptonshire | British | 34102870003 | ||||||||||
| FRANKLIN, Gordon Francis | Secretario | The Cottage Little End Hunningham CV33 9DT Leamington Spa Warwickshire | British | 29905900001 | ||||||||||
| GRIMASON, Deborah | Secretario | Rosa's Cottage 13 Church Road PE28 2RJ Warboys Cambridgeshire | British | 120668330001 | ||||||||||
| LOVELL, John Sinclair | Secretario | RH4 1TH Dorking Regent House Surrey United Kingdom | 174993530001 | |||||||||||
| MOTTRAM, Clive Jonathan | Secretario | Granite House Granite Way, Syston LE7 1PL Leicester Company Secretariat Department Leicestershire United Kingdom | British | 101320990002 | ||||||||||
| LAFARGE SECRETARIES (UK) LIMITED | Secretario corporativo | Granite Way Syston LE7 1PL Leicester Granite House Leicestershire |
| 9859690010 | ||||||||||
| BOLDT, Katrin Gertrude | Director | 8008 Zurich Muhlebachstrasse 30 Switzerland Switzerland | Switzerland | German | 206614710001 | |||||||||
| BUCKLE, Philip | Director | 23 Hazelwood Road Duffield DE56 4DP Belper Derbyshire | United Kingdom | British | 173803190001 | |||||||||
| COLLIGNON, Marie-Cecile | Director | Bickenhill Lane B37 7BQ Solihull Portland House Birmingham United Kingdom | France | French | 163152100001 | |||||||||
| ELLIOTT, Raymond Alfred | Director | 4 Church Close Rushton NN14 1SB Kettering Northamptonshire | British | 34102870003 | ||||||||||
| FENNELL, Sonia | Director | Granite House Granite Way, Syston LE7 1PL Leicester Company Secretariat Department Leicestershire | England | British | 9591230004 | |||||||||
| GRIMASON, Deborah | Director | Bickenhill Lane B37 7BQ Solihuill Portland House West Midlands United Kingdom | United Kingdom | British | 120668330001 | |||||||||
| GRIMASON, Deborah | Director | Rosa's Cottage 13 Church Road PE28 2RJ Warboys Cambridgeshire | United Kingdom | British | 120668330001 | |||||||||
| HARRIS, Richard Mark | Director | Station Approach RH4 1TH Dorking Regent House Surrey United Kingdom | England | British | 59154630001 | |||||||||
| KRANZ, Andreas | Director | 8050 Zurich Hagenholzstrasse 85 Switzerland Switzerland | Switzerland | Swiss | 206623200001 | |||||||||
| LANYON, Phillip Thomas Edward | Director | Granite House Granite Way, Syston LE7 1PL Leicester Company Secretariat Department Leicestershire | United Kingdom | British | 153614170001 | |||||||||
| LOUDON, James Rushworth Hope | Director | Olantigh Wye TN25 5EW Ashford Kent | England | British | 11393670001 | |||||||||
| LOVELL, John Sinclair | Director | Granite House Granite Way, Syston LE7 1PL Leicester Company Secretariat Department Leicestershire United Kingdom | United Kingdom | British | 101433290002 | |||||||||
| MARSHALL, Samuel, Dr | Director | Low Hall Barn 24 Rupert Road LS29 0AQ Ilkley West Yorkshire | British | 15620620001 | ||||||||||
| MARTIN, Anthony James | Director | 7 Hazeldene Drive HA5 3NJ Pinner Middlesex | British | 12431770001 | ||||||||||
| MCCOLGAN, James William | Director | Stonecraft Station Road Great Longstone DE45 1TS Bakewell Derbyshire | British | 47914420001 | ||||||||||
| MCKAY, Francis John | Director | Lodge Way House Lodge Way NN5 7UG Harlestone Road Northampton | British | 78787530001 | ||||||||||
| MILLS, Peter William Joseph | Director | RH4 1TH Dorking Regent House Surrey United Kingdom | England | British | 50416220001 | |||||||||
| MOLLER, Howard Bruce | Director | London Road RH4 1TH Dorking Park Lodge Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 176766970001 | |||||||||
| MOTTRAM, Clive Jonathan | Director | Granite House Granite Way, Syston LE7 1PL Leicester Company Secretariat Department Leicestershire United Kingdom | England | British | 101320990002 | |||||||||
| PHILBY, Patrick Montague | Director | Hayles Piece Kintbury RG17 9SY Hungerford Berkshire | British | 14690620002 | ||||||||||
| POWELL, Rebecca Joan | Director | Granite House Granite Way Syston LE7 1PL Leicester Company Secretariat Department Leicestershire United Kingdom | England | British | 159214660001 | |||||||||
| REID, Ian Maclean | Director | Newstead House The Green LE17 4SG Bitteswell Leicestershire | British | 10964750002 | ||||||||||
| RITCHIE, David Robert | Director | 14 Ashfield Road B14 7AS Birmingham | United Kingdom | British | 78483510001 | |||||||||
| TAPP, Richard Francis | Director | 33 Station Road Earls Barton NN6 0NT Northampton Northamptonshire | British | 31629120001 | ||||||||||
| TEMPLAR-COATES, Oliver Trevor Marwood | Director | Copt Oak Road LE37 9PJ Markfield Bardon Hall Leciestershire United Kingdom | United Kingdom | British | 113410580004 | |||||||||
| WARD, Joseph | Director | 7 Eden Close Rainhill L35 0ND Prescot Merseyside | British | 14156550001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de BLUE CIRCLE HOME PRODUCTS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lafarge Building Materials Limited | 06 abr 2016 | London Road RH4 1TH Dorking Park Lodge Surrey United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene BLUE CIRCLE HOME PRODUCTS LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0