BENTLEY DRIVERS CLUB LIMITED

BENTLEY DRIVERS CLUB LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaBENTLEY DRIVERS CLUB LIMITED
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social
    Número de empresa 00316068
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de BENTLEY DRIVERS CLUB LIMITED?

    • Actividades de otras organizaciones de miembros n.c.p. (94990) / Otras actividades de servicios

    ¿Dónde se encuentra BENTLEY DRIVERS CLUB LIMITED?

    Dirección de la sede social
    W.O.Bentley Memorial Building
    Ironstone Lane
    OX15 6ED Wroxton, Banbury
    Oxfordshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de BENTLEY DRIVERS CLUB LIMITED?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 dic 2024
    Próximas cuentas vencen el30 sept 2025
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2023

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para BENTLEY DRIVERS CLUB LIMITED?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta15 may 2025
    Próxima declaración de confirmación vence29 may 2025
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta15 may 2024
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para BENTLEY DRIVERS CLUB LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Nombramiento de Mrs Joanna Way como director el 29 may 2024

    2 páginasAP01

    Cambio de datos del director Mr Hentry Edward Johnson el 05 jun 2024

    2 páginasCH01

    Nombramiento de Mr Hentry Edward Johnson como director el 29 may 2024

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Philip Brooks como director el 21 abr 2024

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 15 may 2024 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cessation de Duncan Charles Wiltshire en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 21 abr 2024

    1 páginasPSC07

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2023

    16 páginasAA

    Nombramiento de Mr Terence Francis Charles Cooper como director el 21 abr 2024

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Duncan Charles Wiltshire como director el 21 abr 2024

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Diana Margaret Green Davy como director el 21 abr 2024

    1 páginasTM01

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de modificación de los Artículos de Asociación

    RES01

    Nombramiento de Mr Bernard Antony Walker como director el 11 ene 2024

    2 páginasAP01

    Notification de Christopher Michael Warner en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 11 ene 2024

    2 páginasPSC01

    Nombramiento de Mr Christopher Michael Warner como director el 04 dic 2023

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Dr Diana Margaret Green Davy como director el 04 dic 2023

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mrs Barbara Ann Haig como director el 04 dic 2023

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Paul David Spencer como director el 04 dic 2023

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Andrew John Day como director el 04 dic 2023

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Pauline Brown como director el 08 dic 2023

    1 páginasTM01

    Notification de Duncan Charles Wiltshire en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 20 nov 2023

    2 páginasPSC01

    Cessation de Phillip William Hine en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 20 nov 2023

    1 páginasPSC07

    Cese del nombramiento de Ian Wayland Harris como director el 17 nov 2023

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Phillip William Hine como director el 20 nov 2023

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 15 may 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mrs Pauline Brown como director el 23 abr 2023

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de BENTLEY DRIVERS CLUB LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BOATWRIGHT, Dennis John
    W.O.Bentley Memorial Building
    Ironstone Lane
    OX15 6ED Wroxton, Banbury
    Oxfordshire
    Secretario
    W.O.Bentley Memorial Building
    Ironstone Lane
    OX15 6ED Wroxton, Banbury
    Oxfordshire
    184254720001
    COOPER, Terence Francis Charles
    W.O.Bentley Memorial Building
    Ironstone Lane
    OX15 6ED Wroxton, Banbury
    Oxfordshire
    Director
    W.O.Bentley Memorial Building
    Ironstone Lane
    OX15 6ED Wroxton, Banbury
    Oxfordshire
    EnglandBritishDirector102793570001
    DAY, Andrew John
    W.O.Bentley Memorial Building
    Ironstone Lane
    OX15 6ED Wroxton, Banbury
    Oxfordshire
    Director
    W.O.Bentley Memorial Building
    Ironstone Lane
    OX15 6ED Wroxton, Banbury
    Oxfordshire
    EnglandBritishCompany Director9358200003
    HAIG, Barbara Ann
    W.O.Bentley Memorial Building
    Ironstone Lane
    OX15 6ED Wroxton, Banbury
    Oxfordshire
    Director
    W.O.Bentley Memorial Building
    Ironstone Lane
    OX15 6ED Wroxton, Banbury
    Oxfordshire
    EnglandBritishDirector11978830001
    JOHNSON, Henry Edward
    W.O.Bentley Memorial Building
    Ironstone Lane
    OX15 6ED Wroxton, Banbury
    Oxfordshire
    Director
    W.O.Bentley Memorial Building
    Ironstone Lane
    OX15 6ED Wroxton, Banbury
    Oxfordshire
    EnglandBritishDirector323749590002
    SPENCER, David John
    W.O.Bentley Memorial Building
    Ironstone Lane
    OX15 6ED Wroxton, Banbury
    Oxfordshire
    Director
    W.O.Bentley Memorial Building
    Ironstone Lane
    OX15 6ED Wroxton, Banbury
    Oxfordshire
    EnglandBritishCompany Director108271870001
    SPENCER, Paul David
    W.O.Bentley Memorial Building
    Ironstone Lane
    OX15 6ED Wroxton, Banbury
    Oxfordshire
    Director
    W.O.Bentley Memorial Building
    Ironstone Lane
    OX15 6ED Wroxton, Banbury
    Oxfordshire
    EnglandBritishDirector73368600002
    WALKER, Bernard Antony
    W.O.Bentley Memorial Building
    Ironstone Lane
    OX15 6ED Wroxton, Banbury
    Oxfordshire
    Director
    W.O.Bentley Memorial Building
    Ironstone Lane
    OX15 6ED Wroxton, Banbury
    Oxfordshire
    EnglandBritishRetired24084490001
    WARNER, Christopher Michael
    W.O.Bentley Memorial Building
    Ironstone Lane
    OX15 6ED Wroxton, Banbury
    Oxfordshire
    Director
    W.O.Bentley Memorial Building
    Ironstone Lane
    OX15 6ED Wroxton, Banbury
    Oxfordshire
    EnglandBritishDirector317407390001
    WAY, Joanna
    W.O.Bentley Memorial Building
    Ironstone Lane
    OX15 6ED Wroxton, Banbury
    Oxfordshire
    Director
    W.O.Bentley Memorial Building
    Ironstone Lane
    OX15 6ED Wroxton, Banbury
    Oxfordshire
    United KingdomBritishDirector129758920001
    FELL, Barbara Molly
    9 Cautley Close
    Quainton
    HP22 4BN Aylesbury
    Buckinghamshire
    Secretario
    9 Cautley Close
    Quainton
    HP22 4BN Aylesbury
    Buckinghamshire
    British52664110001
    GEE, Patricia Marie Elizabeth
    Mountararat
    Meadway, Oving
    HP22 4EX Aylesbury
    Buckinghamshire
    Secretario
    Mountararat
    Meadway, Oving
    HP22 4EX Aylesbury
    Buckinghamshire
    BritishAdministrator58019610004
    PORT, William John
    The Gap North Side
    Steeple Aston
    OX6 3SE Bicester
    Oxfordshire
    Secretario
    The Gap North Side
    Steeple Aston
    OX6 3SE Bicester
    Oxfordshire
    British28443300001
    WATSON, John Nicholas
    Upper Cottage
    Chilbolton
    SO20 6AZ Stockbridge
    Hampshire
    Secretario
    Upper Cottage
    Chilbolton
    SO20 6AZ Stockbridge
    Hampshire
    British29664870002
    ADAMS, Simon
    9 Hope Place
    Levenhall
    EH21 7QD Musselburgh
    Midlothian
    Director
    9 Hope Place
    Levenhall
    EH21 7QD Musselburgh
    Midlothian
    BritishEngineer109859010001
    ALEXANDER, Richard, Sir
    W.O.Bentley Memorial Building
    Ironstone Lane
    OX15 6ED Wroxton, Banbury
    Oxfordshire
    Director
    W.O.Bentley Memorial Building
    Ironstone Lane
    OX15 6ED Wroxton, Banbury
    Oxfordshire
    EnglandBritishPublic Relations52768950002
    ALEXANDER, Richard, Sir
    1 Northdowns View
    Harrietsham
    ME17 1AQ Maidstone
    Kent
    Director
    1 Northdowns View
    Harrietsham
    ME17 1AQ Maidstone
    Kent
    EnglandBritishPublic Relations Consultant52768950002
    AMBLER, Charles John
    Harden Hall
    Harden
    BD16 1JL Bingley
    West Yorkshire
    Director
    Harden Hall
    Harden
    BD16 1JL Bingley
    West Yorkshire
    United KingdomBritishEngineer9358180001
    ANDERSON, Thomas Johnstone, Doctor
    14 Grange Terrace
    EH9 2LD Edinburgh
    Director
    14 Grange Terrace
    EH9 2LD Edinburgh
    BritishMedical Practioner50945640001
    ANDREWS, Mark Stuart
    Arlington Crescent
    EN8 7RN Waltham Cross
    33
    Hertfordshire
    England
    Director
    Arlington Crescent
    EN8 7RN Waltham Cross
    33
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritishMotor Engineer88130450002
    ARMSTRONG, Thea
    32 Wo75 Butternut Lane
    Naperville
    Illinois 60540
    Usa
    Director
    32 Wo75 Butternut Lane
    Naperville
    Illinois 60540
    Usa
    AmericanAttorney89951040001
    ASKER-BROWNE, David Malcolm
    W.O.Bentley Memorial Building
    Ironstone Lane
    OX15 6ED Wroxton, Banbury
    Oxfordshire
    Director
    W.O.Bentley Memorial Building
    Ironstone Lane
    OX15 6ED Wroxton, Banbury
    Oxfordshire
    EnglandBritishChartered Occupational Hygienist140671210001
    BAKER, Roy Charles
    Downrew
    4 Kestrel Close
    GU4 7DR Guildford
    Surrey
    Director
    Downrew
    4 Kestrel Close
    GU4 7DR Guildford
    Surrey
    United KingdomBritishAccountant2915970003
    BALL, John Richard
    Fountains Barn
    Main Street, Cottesmore
    LE15 7DJ Oakham
    Rutland
    Director
    Fountains Barn
    Main Street, Cottesmore
    LE15 7DJ Oakham
    Rutland
    BritishDirector56075770001
    BASKERVILLE, Brian Terence
    Saddlers House Saddlers Row
    GU28 0AN Petworth
    West Sussex
    Director
    Saddlers House Saddlers Row
    GU28 0AN Petworth
    West Sussex
    BritishAntiquarian Horologist58611650001
    BERTHINUSSEN, Angus Park
    Parkview
    34 Dewartown
    EH23 4NX Gorebridge
    Midlothian
    Director
    Parkview
    34 Dewartown
    EH23 4NX Gorebridge
    Midlothian
    ScotlandBritishRetired30945100003
    BEVAN, David Howard
    Hall Place
    Ropley
    SO24 0DX Alresford
    Hampshire
    Director
    Hall Place
    Ropley
    SO24 0DX Alresford
    Hampshire
    BritishChartered Accountant11632420001
    BRADFIELD, Thomas Michael
    Loudhams Barn Burtons Lane
    Little Chalfont
    HP8 4BS Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Director
    Loudhams Barn Burtons Lane
    Little Chalfont
    HP8 4BS Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    BritishRetired28443340001
    BRAMHALL, Sean Michael
    Southport Road
    Scarisbrick
    PR8 5LF Southport
    Brooklands 242
    Merseyside
    England
    Director
    Southport Road
    Scarisbrick
    PR8 5LF Southport
    Brooklands 242
    Merseyside
    England
    EnglandBritishCompany Director57834250001
    BRENNER, Russell Keith
    Russlea 8 Barton Close
    IG7 6LJ Chigwell
    Essex
    Director
    Russlea 8 Barton Close
    IG7 6LJ Chigwell
    Essex
    EnglandBritishCompany Director51076750002
    BROOKS, Philip
    W.O.Bentley Memorial Building
    Ironstone Lane
    OX15 6ED Wroxton, Banbury
    Oxfordshire
    Director
    W.O.Bentley Memorial Building
    Ironstone Lane
    OX15 6ED Wroxton, Banbury
    Oxfordshire
    United StatesAmericanRetired258520760001
    BROWN, John Robert
    2 Cedar Mount
    Bruan Road
    RG14 7AX Newbury
    Berkshire
    Director
    2 Cedar Mount
    Bruan Road
    RG14 7AX Newbury
    Berkshire
    BritishElectrical Wholesaler28443350002
    BROWN, Pauline
    W.O.Bentley Memorial Building
    Ironstone Lane
    OX15 6ED Wroxton, Banbury
    Oxfordshire
    Director
    W.O.Bentley Memorial Building
    Ironstone Lane
    OX15 6ED Wroxton, Banbury
    Oxfordshire
    EnglandBritishDirector134211500001
    BULLING, Stephen Francis Langlands
    209 Birchanger Lane
    Birchanger
    CM23 5QJ Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Director
    209 Birchanger Lane
    Birchanger
    CM23 5QJ Bishops Stortford
    Hertfordshire
    EnglandBritishChartered Accountant79978150001
    CAMPS, Donald
    Poplar House Ruthin Road
    Adwy Coedpoeth
    LL11 3US Wrexham
    Clwyd
    Wales
    Director
    Poplar House Ruthin Road
    Adwy Coedpoeth
    LL11 3US Wrexham
    Clwyd
    Wales
    BritishEngineer34688300001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de BENTLEY DRIVERS CLUB LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Mr Christopher Michael Warner
    W.O.Bentley Memorial Building
    Ironstone Lane
    OX15 6ED Wroxton, Banbury
    Oxfordshire
    11 ene 2024
    W.O.Bentley Memorial Building
    Ironstone Lane
    OX15 6ED Wroxton, Banbury
    Oxfordshire
    No
    Nacionalidad: British
    País de residencia: England
    Naturaleza del control
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre la empresa.
    Mr Duncan Charles Wiltshire
    W.O.Bentley Memorial Building
    Ironstone Lane
    OX15 6ED Wroxton, Banbury
    Oxfordshire
    20 nov 2023
    W.O.Bentley Memorial Building
    Ironstone Lane
    OX15 6ED Wroxton, Banbury
    Oxfordshire
    Nacionalidad: British
    País de residencia: United Kingdom
    Naturaleza del control
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre la empresa.
    Mr Phillip William Hine
    W.O.Bentley Memorial Building
    Ironstone Lane
    OX15 6ED Wroxton, Banbury
    Oxfordshire
    10 ago 2022
    W.O.Bentley Memorial Building
    Ironstone Lane
    OX15 6ED Wroxton, Banbury
    Oxfordshire
    Nacionalidad: British
    País de residencia: England
    Naturaleza del control
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre la empresa.
    Mr Richard Parkinson
    W.O.Bentley Memorial Building
    Ironstone Lane
    OX15 6ED Wroxton, Banbury
    Oxfordshire
    27 abr 2019
    W.O.Bentley Memorial Building
    Ironstone Lane
    OX15 6ED Wroxton, Banbury
    Oxfordshire
    Nacionalidad: British
    País de residencia: England
    Naturaleza del control
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre la empresa.
    Mr Ronald John Warmington
    W.O.Bentley Memorial Building
    Ironstone Lane
    OX15 6ED Wroxton, Banbury
    Oxfordshire
    06 abr 2017
    W.O.Bentley Memorial Building
    Ironstone Lane
    OX15 6ED Wroxton, Banbury
    Oxfordshire
    Nacionalidad: British
    País de residencia: United Kingdom
    Naturaleza del control
    • La persona tiene el derecho de ejercer, o ejerce realmente, una influencia o control significativo sobre la empresa.

    ¿Tiene BENTLEY DRIVERS CLUB LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Mortgage over real property
    Creado el 30 mar 2009
    Entregado el 02 abr 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The real property being- unit 1, apollo office park, drift road, wroxton, oxfordshire t/no ON259910 and any buildings, fixtures and fittings and fixed plant and machinery. And all related rights see image for full details.
    Personas con derecho
    • Tbf Holdings Limited
    Transacciones
    • 02 abr 2009Registro de un cargo (395)
    • 11 feb 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Legal charge
    Creado el 11 ago 2006
    Entregado el 15 ago 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Unit 1 apollo office park drift road wroxton,. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 15 ago 2006Registro de un cargo (395)
    • 05 mar 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 27 jul 2006
    Entregado el 02 ago 2006
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 02 ago 2006Registro de un cargo (395)
    • 05 jun 2008Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    Legal charge
    Creado el 16 oct 1975
    Entregado el 31 oct 1975
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    "Madges" long crendon buckinghamshire.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank Limited
    Transacciones
    • 31 oct 1975Registro de una carga
    • 28 jul 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0