ZOE HOTELS (UK) LIMITED

ZOE HOTELS (UK) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaZOE HOTELS (UK) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 00318226
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de ZOE HOTELS (UK) LIMITED?

    • (7415) /

    ¿Dónde se encuentra ZOE HOTELS (UK) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    C/O Kroll
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ZOE HOTELS (UK) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    LE MERIDIEN HOTELS (UK) LIMITED 23 ago 200123 ago 2001
    FORTE HOTELS (UK) LIMITED09 jul 199109 jul 1991
    TRUSTHOUSE FORTE HOTELS LIMITED 31 dic 197931 dic 1979
    TRUST HOUSES FORTE HOTELS LIMITED04 sept 193604 sept 1936

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de ZOE HOTELS (UK) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2004

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para ZOE HOTELS (UK) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 30 sept 2013

    5 páginas4.68

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    3 páginas4.71

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 29 ago 2013

    5 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 28 feb 2013

    5 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 29 ago 2012

    5 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 29 feb 2012

    5 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 29 ago 2011

    5 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 28 feb 2011

    5 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 29 ago 2010

    9 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 28 feb 2010

    5 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 29 ago 2009

    5 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 28 feb 2009

    5 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 29 ago 2008

    6 páginas4.68

    legacy

    1 páginas287

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación

    LRESSP

    Declaración de solvencia

    4 páginas4.70

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    5 páginas363a

    legacy

    1 páginas353

    legacy

    1 páginas288c

    legacy

    1 páginas287

    Memorándum y Estatutos

    20 páginasMA

    Certificado de cambio de nombre

    Company name changed le meridien hotels (uk) LIMITED\certificate issued on 03/01/06
    2 páginasCERTNM

    ¿Quiénes son los directivos de ZOE HOTELS (UK) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    STARMAN SECRETARIES LIMITED
    Hesketh House
    43-45 Portman Square
    W1H 6HN London
    Secretario corporativo
    Hesketh House
    43-45 Portman Square
    W1H 6HN London
    98359920004
    COOKE, Martin Anthony
    Uggool
    Moycullen
    Galway
    Ireland
    Director
    Uggool
    Moycullen
    Galway
    Ireland
    IrelandIrishFinance Director87347070001
    EDIS-BATES, Jonathan Geoffrey
    The Croft
    Chalfont Lane Chorleywood
    WD3 5PP Rickmansworth
    Hertfordshire
    Secretario
    The Croft
    Chalfont Lane Chorleywood
    WD3 5PP Rickmansworth
    Hertfordshire
    British49678170001
    FRASER, Simon Scott
    Foxtrot 1 Shey Copse
    GU22 8HS Woking
    Surrey
    Secretario
    Foxtrot 1 Shey Copse
    GU22 8HS Woking
    Surrey
    BritishDirector39862810001
    MACKENZIE, Lisa Marie
    70 Vassall Road
    Kennington
    SW9 6HY London
    Secretario
    70 Vassall Road
    Kennington
    SW9 6HY London
    BritishDirector Of Tax 78059700001
    MASON, Timothy Charles
    231 Station Road
    Knowle
    B93 0PU Solihull
    West Midlands
    Secretario
    231 Station Road
    Knowle
    B93 0PU Solihull
    West Midlands
    British12314170002
    MILLS, John Michael
    33 Peplins Way
    AL9 7UR Brookmans Park
    Hertfordshire
    Secretario
    33 Peplins Way
    AL9 7UR Brookmans Park
    Hertfordshire
    British42268710001
    SIMS, Roy John Peter
    6 Star Hill Drive
    Churt
    GU10 2HP Farnham
    Surrey
    Secretario
    6 Star Hill Drive
    Churt
    GU10 2HP Farnham
    Surrey
    British12396130001
    STEVENS, David John
    42 Burghley Road
    Wimbledon
    SW19 5HN London
    Secretario
    42 Burghley Road
    Wimbledon
    SW19 5HN London
    British56704240001
    TAUTZ, Helen Jane
    30 South Crescent
    Prittlewell
    SS2 6TA Southend On Sea
    Essex
    Secretario
    30 South Crescent
    Prittlewell
    SS2 6TA Southend On Sea
    Essex
    British37564540001
    FORTE NOMINEES LIMITED
    166 High Holborn
    WC1V 6TT London
    Secretario corporativo
    166 High Holborn
    WC1V 6TT London
    42198970001
    BARRETT, Brian Michael
    75 Altwood Road
    SL6 4PS Maidenhead
    Berkshire
    Director
    75 Altwood Road
    SL6 4PS Maidenhead
    Berkshire
    BritishDirector31548800001
    CAUX, Emmanuel Francis Rene
    44 Queensgate Gardens
    SW7 5ND London
    Director
    44 Queensgate Gardens
    SW7 5ND London
    FrenchDirector Of Operations78059760001
    COOPER, Stephen Richard
    Meadow Cottage 7-9 Ayot Green
    Ayot St Peter
    AL6 9AB Welwyn
    Hertfordshire
    Director
    Meadow Cottage 7-9 Ayot Green
    Ayot St Peter
    AL6 9AB Welwyn
    Hertfordshire
    BritishExecutive Director31548820001
    DAFFURN, Thomas
    The Beeches Hall Close
    Maids Moreton
    MK18 1RH Buckingham
    Buckinghamshire
    Director
    The Beeches Hall Close
    Maids Moreton
    MK18 1RH Buckingham
    Buckinghamshire
    BritishExecutive Director56015740001
    EDIS-BATES, Jonathan Geoffrey
    The Croft
    Chalfont Lane Chorleywood
    WD3 5PP Rickmansworth
    Hertfordshire
    Director
    The Croft
    Chalfont Lane Chorleywood
    WD3 5PP Rickmansworth
    Hertfordshire
    EnglandBritishSol Sec49678170001
    ELTON, James Robert
    27 Elsie Road
    SE22 8DX London
    Director
    27 Elsie Road
    SE22 8DX London
    United KingdomBritishDirector Of Development55689440001
    FERGUSON, Iain Donald
    2 Chalet Close
    Shootersway Lane
    HP4 3NR Berkhamsted
    Hertfordshire
    Director
    2 Chalet Close
    Shootersway Lane
    HP4 3NR Berkhamsted
    Hertfordshire
    United KingdomBritishChartered Accountant10297860001
    FORTE, Rocco Giovanni, The Hon Sir
    21 Cheyne Gardens
    SW3 5QT London
    Director
    21 Cheyne Gardens
    SW3 5QT London
    EnglandBritishExecutive Chairman2725010001
    FOXON, Marten
    Crownpitts Cottage The Close
    Busbridge
    GU7 1PQ Godalming
    Surrey
    Director
    Crownpitts Cottage The Close
    Busbridge
    GU7 1PQ Godalming
    Surrey
    BritishProperty & Deveoopment44933010001
    FRASER, Simon Scott
    Foxtrot 1 Shey Copse
    GU22 8HS Woking
    Surrey
    Director
    Foxtrot 1 Shey Copse
    GU22 8HS Woking
    Surrey
    BritishFinance Director39862810001
    GIANNUZZI, Alfonso
    Apartment 68 New River Head
    173 Rosebery Avenue
    EC1R 4UN London
    Director
    Apartment 68 New River Head
    173 Rosebery Avenue
    EC1R 4UN London
    BritishDirector86128310001
    HAMILL, Keith
    166 High Holborn
    WC1V 6TT London
    Director
    166 High Holborn
    WC1V 6TT London
    BritishFinance Director76268070001
    HEARN, Alan John
    Tylecroft 29 Woodchester Park
    Knotty Green
    HP9 2TU Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Director
    Tylecroft 29 Woodchester Park
    Knotty Green
    HP9 2TU Beaconsfield
    Buckinghamshire
    BritishManaging Director13648200003
    HEARN, Dennis
    Bishops Platt
    Norlands Lane
    TW20 8SS Thorpe
    Surrey
    Director
    Bishops Platt
    Norlands Lane
    TW20 8SS Thorpe
    Surrey
    BritishDeputy Chief51334350001
    HEARN, Grant David
    Bishops Platt
    Norlands Lane
    TW20 8SS Thorpe
    Surrey
    Director
    Bishops Platt
    Norlands Lane
    TW20 8SS Thorpe
    Surrey
    United KingdomBritishDirector88628480001
    JONES, Michael Rees
    Rutland House
    Church Street
    NN11 Ilford
    Daventry
    Director
    Rutland House
    Church Street
    NN11 Ilford
    Daventry
    British31548760002
    LAMBERT, Bernard Charles Hector
    Flat 10
    21-23 Palace Gate
    W8 5LS London
    Director
    Flat 10
    21-23 Palace Gate
    W8 5LS London
    AustriaFrenchManaging Director60956020002
    LOVETT, Norman
    25 Balmoral Way
    Belmont
    Surrey
    Director
    25 Balmoral Way
    Belmont
    Surrey
    BritishCommercial Director49941610001
    LYNCH, Roderick Robertson
    9 Osier Mews
    Chiswick
    W4 2NT London
    Director
    9 Osier Mews
    Chiswick
    W4 2NT London
    United KingdomBritishDirector Sales106587750001
    MACKENZIE, Lisa Marie
    70 Vassall Road
    Kennington
    SW9 6HY London
    Director
    70 Vassall Road
    Kennington
    SW9 6HY London
    BritishDirector Of Tax 78059700001
    MACKENZIE, Lisa Marie
    70 Vassall Road
    Kennington
    SW9 6HY London
    Director
    70 Vassall Road
    Kennington
    SW9 6HY London
    BritishDirector Of Tax 78059700001
    MAHONEY, Richard Lee
    Flat 14,38 Queens Gate
    SW7 5JN London
    Director
    Flat 14,38 Queens Gate
    SW7 5JN London
    AmericanChief Operating Officer78240440004
    MALONEY, David Ossian
    64 Ledborough Lane
    HP9 2DG Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Director
    64 Ledborough Lane
    HP9 2DG Beaconsfield
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishChief Financial Officer69071800002
    MILLS, John Michael
    33 Peplins Way
    AL9 7UR Brookmans Park
    Hertfordshire
    Director
    33 Peplins Way
    AL9 7UR Brookmans Park
    Hertfordshire
    BritishCompany Secretary42268710001

    ¿Tiene ZOE HOTELS (UK) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Security agreement
    Creado el 15 abr 2003
    Entregado el 01 may 2003
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    Any and all present and future obligations due or to become due from any obligor to the chargee (the "security agent") as agent and trustee for itself and each of the secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All the shares stocks debentures bonds or other securities. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Cibc World Markets PLC
    Transacciones
    • 01 may 2003Registro de un cargo (395)
    Mortgage of shares
    Creado el 15 abr 2003
    Entregado el 01 may 2003
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All present and future obligations due or to become due from any obligor to the chargee (the "security agent") as agent and trustee for itself and each of the secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All the shares and all related rights. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Cibc World Markets PLC
    Transacciones
    • 01 may 2003Registro de un cargo (395)
    Portuguese public deed executed outside the UK and comprising of property situated there
    Creado el 05 jul 2002
    Entregado el 06 ago 2002
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The shares and the right to all dividends. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Cibc World Markets PLC (The Security Agent)
    Transacciones
    • 06 ago 2002Registro de un cargo (395)
    Security agreement
    Creado el 31 dic 2001
    Entregado el 18 ene 2002
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All obligations and liabilities due or to become due from any obligor (as defined) to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All right,title and interest in the shares and related rights,dividends and other distributions thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Cibc Woirld Markets PLC,as Agent and Trustee for Itself and Each of the Secured Creditors
    Transacciones
    • 18 ene 2002Registro de un cargo (395)
    Notarial deed of pledge
    Creado el 21 dic 2001
    Entregado el 09 ene 2002
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All obligations and liabilities due or to become due from any obligor (as defined) to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The share pledge guarantees the full and prompt performance by the chargor and the obligors of the secured liabilities up to a maximum amount of GBP87,000,000 which includes the repaument of principal and the payment of interest, commissions, fees, taxes and expenses, costs and indemnities related thereto including those which may be incurred as a result of the granting and the enforcement of the pledge. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Cibc World Markets PLC (The "Security Agent")
    Transacciones
    • 09 ene 2002Registro de un cargo (395)
    • 09 may 2002Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    Debenture between inter alia grand hotels (m) intermediate holding company I limited, the company and the other chargors named therein (the chargors) and cibc world markets PLC (the security agent) as agent and trustee for itself and each of the secured creditors
    Creado el 11 jul 2001
    Entregado el 26 jul 2001
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    Any and all present and future obligations and liabilities of any obligor to the secured creditors (or any of them) under each or any of the senior finance documents, the senior mezzanine finance documents and the junior mezzanine finance documents (all terms as defined)
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Cibc World Markets PLC
    Transacciones
    • 26 jul 2001Registro de un cargo (395)
    A charge & deed of release reg. Pursuant to an o/c dated 30/5/84
    Creado el 26 ene 1984
    Entregado el 31 may 1984
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £1,750,000 7 1/4% first mortgage debenture stock 1988/1991 of the company and all other monies payable thereunder supplemental to a trust deed dated 18TH november, 1965.
    Breve descripción
    The chequers hotel, newbury with all buildings erections, fixtures, fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Commercial Union Assurance Company PLC
    Transacciones
    • 31 may 1984Registro de una carga
    • 15 jun 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge & deed of release
    Creado el 26 ene 1984
    Entregado el 31 may 1984
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £12,500,000 10 1/2% first mortgage debenture stock 1991/1996 of the company and all other monies payable thereunder supplemental to a trust deed dated 1-3-71
    Breve descripción
    (1) the queen hotel, chester (2) lion hotel, shrewsbury. (3) the dolphin hotel, southampton. With all buildings, erections fixtures, fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Commercial Union Assurance Company PLC
    Transacciones
    • 31 may 1984Registro de una carga
    • 15 jun 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage
    Creado el 21 dic 1979
    Entregado el 03 ene 1980
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee not exceeding ukp 20,000 under the terms of a loan agreement dated 21 dec 79
    Breve descripción
    L/H property known as cumberland hotel and 20 great cumberland place marble arch in the london borough of city of westminster with all building fixtures (including trade fixtures) and fixed plant & machinery first floating charge over the furniture fittings & effects (but excluding all fixtures fixed plant & machinery title nos. Ln 10102 ln 10103.
    Personas con derecho
    • Finance Corporation for Industry Limited
    Transacciones
    • 03 ene 1980Registro de una carga
    Standard security presented for registration at the register of sasines on 28/3/1977
    Creado el 22 mar 1977
    Entregado el 15 abr 1977
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    For securing all monies due under the terms of a loan agreement dated 27/1/1977 from the company to the chargee.
    Breve descripción
    Property in union st,2 academy st,inverness,scotland comprising the royal hotel,inverness.
    Personas con derecho
    • Morgan Guaranty Trust Co.of New York
    Transacciones
    • 15 abr 1977Registro de una carga
    • 15 jun 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Standard security which was presented for registration at registry of sasines on 3/8/1972
    Creado el 01 ago 1972
    Entregado el 15 ago 1972
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    Standard security which was presented for registration at registry of sasines on 3RD aug 72 for securing £1,500,000
    Breve descripción
    Post house,corstorphine rd,edinburgh. See doc 97 for details.
    Personas con derecho
    • Unitholders Provident Assurance Limited
    Transacciones
    • 15 ago 1972Registro de una carga
    • 15 jun 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Trust deed
    Creado el 01 mar 1971
    Adquirido el 29 may 1980
    Entregado el 03 jul 1980
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £288918
    Breve descripción
    Kensington close and scarsdale lodge, wright lane, kensington.
    Personas con derecho
    • Commercial Union Assurance Company Limited
    Transacciones
    • 03 jul 1980Registro de una carga
    • 15 jun 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage & further charge
    Creado el 30 abr 1970
    Adquirido el 29 may 1980
    Entregado el 03 jul 1980
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £223,378
    Breve descripción
    The skyway hotel, bath road, harlington, middlesex. The skyway hotel southampton.
    Personas con derecho
    • The Eagle Star Insurance Company Limited
    Transacciones
    • 03 jul 1980Registro de una carga
    Indenture presented for registration at land registry of northern ireland on 10/03/1969
    Creado el 07 feb 1969
    Entregado el 22 may 1969
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    For securing £50,000
    Breve descripción
    Lands at kilmakee, barony of belfast upper and county of antrim comprisedin title no. 24801.
    Personas con derecho
    • Ministry of Commerce for Northern Ireland.
    Transacciones
    • 22 may 1969Registro de una carga
    Mortgage & further charge
    Creado el 19 oct 1966
    Adquirido el 29 may 1980
    Entregado el 03 jul 1980
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £118,713.50
    Breve descripción
    The skyway hotel, bath road, harlington, middlesex. The skyway hotel southampton.
    Personas con derecho
    • The Eagle Star Insurance Company Limited
    Transacciones
    • 03 jul 1980Registro de una carga
    Charge
    Creado el 06 ene 1966
    Adquirido el 29 may 1980
    Entregado el 03 jul 1980
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £288918
    Breve descripción
    Kensington close and scarsdale lodge, wright lane, kensington.
    Personas con derecho
    • The Prudential Assurance Company Limited
    Transacciones
    • 03 jul 1980Registro de una carga
    • 15 jun 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Trust deed
    Creado el 29 may 1963
    Adquirido el 01 oct 1968
    Entregado el 16 ene 1969
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    For securing debenture stock of trust houses group LTD amounting to £3,000,000 secured on property acquired by trust houses LTD on the 1ST, october 1968
    Breve descripción
    Various pieces of land and buildings & premises of which for full detailssee attached 1ST schedule on doc 67 inter company conveyance of 1.10.68.
    Personas con derecho
    • Commercial Union Assurance Company Limited
    Transacciones
    • 16 ene 1969Registro de una carga
    • 15 jun 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Further charge
    Creado el 22 feb 1961
    Adquirido el 29 may 1980
    Entregado el 03 jul 1980
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £118713.50
    Breve descripción
    The skyway hotel, bath road, harlington, middlesex.
    Personas con derecho
    • The Eagle Star Insurance Company Limited
    Transacciones
    • 03 jul 1980Registro de una carga
    Mortgage
    Creado el 29 ene 1960
    Adquirido el 29 may 1980
    Entregado el 03 jul 1980
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    Nil
    Breve descripción
    The skyway hotel, bath road, harlington, middlesex.
    Personas con derecho
    • The Eagle Star Insurance Company Limited
    Transacciones
    • 03 jul 1980Registro de una carga

    ¿Tiene ZOE HOTELS (UK) LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    08 ene 2014Fecha de disolución
    30 ago 2007Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Christopher J Hughes
    Kroll Limited
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Profesional
    Kroll Limited
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0